MBM MOSSPAK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MBM MOSSPAK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00753373 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MBM MOSSPAK LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich MBM MOSSPAK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Glenthorn Farm Whittlesey Road PE15 0AW March Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MBM MOSSPAK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MOSSPAK (POTATOES) LIMITED | 13. März 1963 | 13. März 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBM MOSSPAK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MBM MOSSPAK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von MBM MOSSPAK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERSLUIS, Klaus Christian | Sekretär | Brooklands Lane Menston LS29 6PL Ilkley 19 West Yorkshire | Dutch | 104302950001 | ||||||
BASCETTA, Emanuele | Geschäftsführer | Abbanoy House 52 Kibbleston Road PA10 2PW Kilbarchan Renfrewshire | United Kingdom | British | Managing Director | 102843530001 | ||||
BEVERSLUIS, Klaus Christian | Geschäftsführer | Brooklands Lane Menston LS29 6PL Ilkley 19 West Yorkshire | United Kingdom | Dutch | Director | 104302950001 | ||||
BAKER, Nigel Roland | Sekretär | Damson House Shivean Gate Moulton PE12 6PF Spalding Lincolnshire | British | Accountant | 56774080002 | |||||
DUTTON, Thomas Herbert | Sekretär | 1 Butler Way CW5 7AS Nantwich Cheshire | British | 15020200002 | ||||||
HINES, Christine Anne | Sekretär | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
BAINES, Michael Ronald | Geschäftsführer | 10 Stevens Close Prestwood HP16 0SQ Great Missenden Buckinghamshire | England | English | Chartered Accountant | 35565540003 | ||||
BEESON, Robert John | Geschäftsführer | The Old Rectory Saxlingham NR25 7JZ Holt Norfolk | British | Director | 29846960001 | |||||
BOLTON, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 63 Bottrells Lane HP8 4EJ Chalfont St. Giles Buckinghamshire | Irish | Commercial Director | 83366100002 | |||||
CAMPBELL, Rosalind Ilona | Geschäftsführer | 6 Hawthorn Close WD17 4SB Watford Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 58191970001 | |||||
COMPSON, Christopher John | Geschäftsführer | Old Mill Farmhouse Tuddenham IP28 6SQ Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72803320001 | ||||
CRAIG, Ian Alexander | Geschäftsführer | 11 Manor View Whittlesey PE7 1TF Peterborough Cambridgeshire | England | British | Company Director | 57329350002 | ||||
HILLS, David Edward | Geschäftsführer | Lantern Barn Sharrington NR24 2BU Melton Constable Norfolk | British | Director | 10816830001 | |||||
LEACH, Paul Alan | Geschäftsführer | 58 Donnington Road CV36 4BG Shipston On Stour Warwickshire | British | Treasurer | 60788330002 | |||||
LEACH, Paul Alan | Geschäftsführer | 20 Malvern Road SL6 7RH Maidenhead Berkshire | British | Treasurer | 60788330001 | |||||
MCHUGH, Peter Thomas | Geschäftsführer | Lakeside House Adbaston ST20 0RH Stafford Staffordshire | British | Managing Director | 15441390001 | |||||
MILES, Christopher Thomas | Geschäftsführer | Smithy House Audlem CW3 0DA Crewe Cheshire | British | Managing Director | 15020220001 | |||||
MUSK, Michael John | Geschäftsführer | Torwood Limbourne Lane Fittleworth RH20 1HR Pulborough West Sussex | British | Finance Director | 42341410001 | |||||
OLINS, Laurence Stephen | Geschäftsführer | 32 Hendon Avenue Finchley N3 1UE London | British | Director | 4716420001 | |||||
OWEN, Raymond | Geschäftsführer | The Meadows Broomhall Lane SY10 7HG Oswestry Shropshire | British | Potato Merchant | 24474150001 | |||||
RACKSTRAW, Colin Albert | Geschäftsführer | 22 Willow Avenue HP12 4QU High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 35674110001 | ||||
ROSEN, Andrew Scott | Geschäftsführer | 301 West 53rd Street New York Ny 10019 United States | American | Company Director | 64268220001 | |||||
SIMPSON, Andrew John | Geschäftsführer | Pine Tree Barns Harts Lane Bawburgh NR9 3LT Norwich Norfolk | England | British | Director | 105165150001 |
Hat MBM MOSSPAK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Group debenture | Erstellt am 26. Nov. 2003 Geliefert am 15. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Aug. 1999 Geliefert am 26. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Okt. 1990 Geliefert am 07. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Strip of land six metres wide newstead industrial estate trentham stoke-on-trent staffs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £220,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1990 Geliefert am 04. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £110,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the company's present and future leasehold (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate, trentham stoke-on-trent staffordshire t/n sf 45196) (please see doc for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Feb. 1990 Geliefert am 16. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and factory premises at newstead industrial estate trentham stoke-on-trent staffordshire title no: SF45196. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1987 Geliefert am 23. Sept. 1987 | Vollständig erf üllt | Gesicherter Betrag £50,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1987 Geliefert am 23. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Sept. 1987 Geliefert am 23. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £110,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Loan agreement & debenture | Erstellt am 15. Okt. 1986 Geliefert am 21. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set off | Erstellt am 21. Dez. 1984 Geliefert am 04. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or J.E. england & sons (wellington) PLC to lloyds bank PLC | |
Kurze Angaben Any sums standing to the credit of any any present/future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 1984 Geliefert am 04. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Factory and land at newstead trading estate, trentham road, blurton, stoke-on-trent. T/n sf 45196. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Nov. 1984 Geliefert am 24. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Stocks shares and other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0