MBM MOSSPAK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMBM MOSSPAK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00753373
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MBM MOSSPAK LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich MBM MOSSPAK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Glenthorn Farm
    Whittlesey Road
    PE15 0AW March
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MBM MOSSPAK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MOSSPAK (POTATOES) LIMITED13. März 196313. März 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBM MOSSPAK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für MBM MOSSPAK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Wer sind die Geschäftsführer von MBM MOSSPAK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BEVERSLUIS, Klaus Christian
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Sekretär
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Dutch104302950001
    BASCETTA, Emanuele
    Abbanoy House
    52 Kibbleston Road
    PA10 2PW Kilbarchan
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Abbanoy House
    52 Kibbleston Road
    PA10 2PW Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritishManaging Director102843530001
    BEVERSLUIS, Klaus Christian
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brooklands Lane
    Menston
    LS29 6PL Ilkley
    19
    West Yorkshire
    United KingdomDutchDirector104302950001
    BAKER, Nigel Roland
    Damson House Shivean Gate
    Moulton
    PE12 6PF Spalding
    Lincolnshire
    Sekretär
    Damson House Shivean Gate
    Moulton
    PE12 6PF Spalding
    Lincolnshire
    BritishAccountant56774080002
    DUTTON, Thomas Herbert
    1 Butler Way
    CW5 7AS Nantwich
    Cheshire
    Sekretär
    1 Butler Way
    CW5 7AS Nantwich
    Cheshire
    British15020200002
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Sekretär
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    BAINES, Michael Ronald
    10 Stevens Close
    Prestwood
    HP16 0SQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    10 Stevens Close
    Prestwood
    HP16 0SQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandEnglishChartered Accountant35565540003
    BEESON, Robert John
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Saxlingham
    NR25 7JZ Holt
    Norfolk
    BritishDirector29846960001
    BOLTON, Stephen Thomas
    63 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    63 Bottrells Lane
    HP8 4EJ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    IrishCommercial Director83366100002
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    COMPSON, Christopher John
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Old Mill Farmhouse Tuddenham
    IP28 6SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Accountant72803320001
    CRAIG, Ian Alexander
    11 Manor View
    Whittlesey
    PE7 1TF Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    11 Manor View
    Whittlesey
    PE7 1TF Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director57329350002
    HILLS, David Edward
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Lantern Barn
    Sharrington
    NR24 2BU Melton Constable
    Norfolk
    BritishDirector10816830001
    LEACH, Paul Alan
    58 Donnington Road
    CV36 4BG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    58 Donnington Road
    CV36 4BG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishTreasurer60788330002
    LEACH, Paul Alan
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    20 Malvern Road
    SL6 7RH Maidenhead
    Berkshire
    BritishTreasurer60788330001
    MCHUGH, Peter Thomas
    Lakeside House
    Adbaston
    ST20 0RH Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Lakeside House
    Adbaston
    ST20 0RH Stafford
    Staffordshire
    BritishManaging Director15441390001
    MILES, Christopher Thomas
    Smithy House
    Audlem
    CW3 0DA Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Smithy House
    Audlem
    CW3 0DA Crewe
    Cheshire
    BritishManaging Director15020220001
    MUSK, Michael John
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Torwood Limbourne Lane
    Fittleworth
    RH20 1HR Pulborough
    West Sussex
    BritishFinance Director42341410001
    OLINS, Laurence Stephen
    32 Hendon Avenue
    Finchley
    N3 1UE London
    Geschäftsführer
    32 Hendon Avenue
    Finchley
    N3 1UE London
    BritishDirector4716420001
    OWEN, Raymond
    The Meadows
    Broomhall Lane
    SY10 7HG Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Meadows
    Broomhall Lane
    SY10 7HG Oswestry
    Shropshire
    BritishPotato Merchant24474150001
    RACKSTRAW, Colin Albert
    22 Willow Avenue
    HP12 4QU High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    22 Willow Avenue
    HP12 4QU High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant35674110001
    ROSEN, Andrew Scott
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    Geschäftsführer
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    AmericanCompany Director64268220001
    SIMPSON, Andrew John
    Pine Tree Barns Harts Lane
    Bawburgh
    NR9 3LT Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Pine Tree Barns Harts Lane
    Bawburgh
    NR9 3LT Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector105165150001

    Hat MBM MOSSPAK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Group debenture
    Erstellt am 26. Nov. 2003
    Geliefert am 15. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 10. Aug. 1999
    Geliefert am 26. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 1990
    Geliefert am 07. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Strip of land six metres wide newstead industrial estate trentham stoke-on-trent staffs.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 31. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1990
    Geliefert am 04. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £220,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Peter Mchugh
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1990
    Geliefert am 04. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Janet Miles
    • Hartley Pensions Management Services Limited
    • Christopher Miles
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1990
    Geliefert am 04. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All the company's present or future f/h or l/h (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate trentham stoke on trent staffs t/n sf 45196) (please see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Christopher Miles
    • Janet Miles
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1990
    Geliefert am 04. Sept. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £110,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All the company's present and future leasehold (including a fixed charge over the l/h property situate at newstead industrial estate, trentham stoke-on-trent staffordshire t/n sf 45196) (please see doc for details).
    Berechtigte Personen
    • Scott & Newman Limited
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 1990
    Geliefert am 16. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and factory premises at newstead industrial estate trentham stoke-on-trent staffordshire title no: SF45196.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 31. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1987
    Geliefert am 23. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Christopher Thomas Miles
    • Janet Patricia Miles
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1987
    Geliefert am 23. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hartley Pensions Management Services
    • J.P. Miles
    • C.T. Miles
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1987
    Geliefert am 23. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £110,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    (See doc M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Scott & Newman Limited
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Loan agreement & debenture
    Erstellt am 15. Okt. 1986
    Geliefert am 21. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures.
    Berechtigte Personen
    • J.E. England & Sons (Wellington) PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    Letter of set off
    Erstellt am 21. Dez. 1984
    Geliefert am 04. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or J.E. england & sons (wellington) PLC to lloyds bank PLC
    Kurze Angaben
    Any sums standing to the credit of any any present/future account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 1984
    Geliefert am 04. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Factory and land at newstead trading estate, trentham road, blurton, stoke-on-trent. T/n sf 45196.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 21. Nov. 1984
    Geliefert am 24. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stocks shares and other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1984Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0