ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00755613
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ATKINS CONSULTANTS LIMITED01. Juni 200401. Juni 2004
    WS ATKINS CONSULTANTS LIMITED12. Apr. 198912. Apr. 1989
    W.S.ATKINS & PARTNERS29. März 196329. März 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 18. Apr. 2024

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for Ws Atkins Limited as a person with significant control on 12. Okt. 2023

    2 SeitenPSC05

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed atkins consultants LIMITED\certificate issued on 12/10/23
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name12. Okt. 2023

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 11. Okt. 2023

    RES15

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2023 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    5 SeitenAA

    Notification of Ws Atkins Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Parfab Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Confab Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alan James Cullens als Geschäftsführer am 07. Apr. 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    5 SeitenAA

    Ernennung von Joanne Jarman als Direktor am 17. Mai 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Anderson als Geschäftsführer am 17. Mai 2021

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCALLISTER, Louise Mary
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238795760001
    NOBELEN, Elliot Michael
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238796420001
    COLE, Simon Glenister
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritishAccountant146000480001
    JARMAN, Joanne
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director283434280001
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Sekretär
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    DAVID, Katie Charmian
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    British73696680003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Sekretär
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    GERRARD, Ashley Louise
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218094750001
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Sekretär
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    HAYLOCK, Colin Peter
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    Sekretär
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    British47687610001
    LINDSAY, Catherine Elizabeth
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218252890001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    TOMALIN, Richard Howarth
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    Sekretär
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    British13199870002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Sekretär
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    BritishCompany Secretary85595860003
    ANDERSON, Mark Stephen
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritishAccountant122463830003
    ARCHER, Paul Edward
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    BritishChart. Building Serv.Engineer43573300001
    BALFE, Philip Joseph
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    BritishEngineer29923830001
    BALL, Geoffrey Robert
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Engineer83110540001
    BARRETT, Richard John, Bsc, Ceng, Mice
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    Geschäftsführer
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    EnglandBritishChartered Engineer121534930001
    BARROW, Jill Helen
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    Geschäftsführer
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    BritishManagement Consultant82386630001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Geschäftsführer
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    BritishCor Treasurer983300008
    BINNIE, Christopher Jon Anthony
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    BritishCivil Engineer14298460001
    BROWN, Peter Allan
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    Geschäftsführer
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    BritishChartered Engineer30520670001
    BROWNE, Maximilian George Burrowes
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    Geschäftsführer
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    BritishChartered Civil Engineer19130630001
    BROYD, Timothy William, Professor
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    EnglandBritishConsultant Engineer58859990001
    BUSBY, Peter Leonard
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    Geschäftsführer
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    BritishChartered Civil Engineer44813100001
    CATTO, Ivor Douglas
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    Geschäftsführer
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Engineer87066030002
    CLARK, Piers Benedict, Dr
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    Geschäftsführer
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    United KingdomBritishPrinciple Scientist84765290001
    CLARKE, Keith Edward
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritishArchitect93106530002
    CLEMENTS, David Russell
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    Geschäftsführer
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    United KingdomBritishChartered Engineer22250060002
    COLLINS, Rodney
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    BritishCivil Engineer12906160001
    CORRIE, Robert Keith
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishCivil Engineer35957190001
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Hr Director189297280001
    CUMING, James Anthony
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    Geschäftsführer
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    EnglandBritishChartered Engineer19130650002
    CUTHBERT, Richard Harry
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    United KingdomBritishTransport Planner43573230002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    14. Dez. 2022
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England & Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer01885586
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer755561
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer755581
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second fixed and floating debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2003
    Geliefert am 11. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 11. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 18. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment in respect of the shepherd contracts
    Erstellt am 20. März 2002
    Geliefert am 28. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assignor with full title guarantee, as continuing security for the performance and payment of all the secured obligations, hereby assigns and agrees to assign to the assignee all of its right, title, benefit and interest whatsoever present and future in: (a) clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract; and (b) the guarantee insofar as it relates to the contractor's obligations under clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract.
    Berechtigte Personen
    • TS4I (Process Utilities 1) Limited
    Transaktionen
    • 28. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sharge charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited)
    Erstellt am 13. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 04. Jan. 1996
    Geliefert am 18. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bridgend custodial services limited to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    All dividends paid or payable on the shares being:- 24,000 "a" shares and 1,000 "b" shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement
    Erstellt am 05. März 1992
    Geliefert am 10. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date and in respect of the deposit agreement.
    Kurze Angaben
    All rights to the repayment of the deposit (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 10. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral mortgage
    Erstellt am 14. Juni 1988
    Geliefert am 28. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from atkins properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Kurze Angaben
    L/H property k/a premises on the third floor of the western wing of sir william atkins house, southern link road epsom, surrey together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    Collateral mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1988
    Geliefert am 10. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Kurze Angaben
    All the l/h property k/a the western wing of sir william atkins house, southern link road, epsom together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and the full benefit of the covenants and guarantee on the part of the company contained in the lease dated 4/3/88.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    Collateral mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 1987
    Geliefert am 18. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all moneys due or to become due from scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of subsititution dated 13/7/86
    Kurze Angaben
    All the l/h property demised to the company by the lease or underlease (please see form 395 for full details of property) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time therein.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    • 16. März 1991Registrierung einer Belastung
    Collateral mortgage
    Erstellt am 13. Juni 1986
    Geliefert am 19. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/86.
    Kurze Angaben
    Land and buildings situate to the west of and having access to ashley road, epsom, surrey and continuing to chalk lane on the east and k/a woodcote grove, title no:- p 17436 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 25. Apr. 1985
    Geliefert am 02. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company.
    Transaktionen
    • 02. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    • 06. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 07. Aug. 1963
    Geliefert am 13. Aug. 1963
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property including uncalled capital. (See doc 6).
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank LTD.
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1963Registrierung einer Belastung
    • 06. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0