ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00755613 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ATKINS CONSULTANTS LIMITED | 01. Juni 2004 | 01. Juni 2004 |
WS ATKINS CONSULTANTS LIMITED | 12. Apr. 1989 | 12. Apr. 1989 |
W.S.ATKINS & PARTNERS | 29. März 1963 | 29. März 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Apr. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Ws Atkins Limited as a person with significant control on 12. Okt. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed atkins consultants LIMITED\certificate issued on 12/10/23 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Ws Atkins Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Parfab Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Confab Limited as a person with significant control on 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan James Cullens als Geschäftsführer am 07. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Joanne Jarman als Direktor am 17. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Anderson als Geschäftsführer am 17. Mai 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCALLISTER, Louise Mary | Sekretär | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238795760001 | |||||||
NOBELEN, Elliot Michael | Sekretär | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238796420001 | |||||||
COLE, Simon Glenister | Geschäftsführer | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | Accountant | 146000480001 | ||||
JARMAN, Joanne | Geschäftsführer | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 283434280001 | ||||
BAKER, Helen Alice | Sekretär | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 108742050002 | ||||||
DAVID, Katie Charmian | Sekretär | 31 Sandy Lane TN13 3TP Sevenoaks Kent | British | 73696680003 | ||||||
DAVIS, Philip Stephen James | Sekretär | Hartland Woodside Drive RG18 9QD Hermitage Berkshire | British | 71932630003 | ||||||
GERRARD, Ashley Louise | Sekretär | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218094750001 | |||||||
HAMES, Victoria Elizabeth | Sekretär | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
HAYLOCK, Colin Peter | Sekretär | Downside The Drive Belmont SM2 7DP Sutton Surrey | British | 47687610001 | ||||||
LINDSAY, Catherine Elizabeth | Sekretär | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218252890001 | |||||||
MASSIE, Amanda Jane Emilia | Sekretär | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
TOMALIN, Richard Howarth | Sekretär | 22 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | British | 13199870002 | ||||||
WEBSTER, Richard | Sekretär | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | Company Secretary | 85595860003 | |||||
ANDERSON, Mark Stephen | Geschäftsführer | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | Accountant | 122463830003 | ||||
ARCHER, Paul Edward | Geschäftsführer | 15 Woodgavil SM7 1AA Banstead Surrey | British | Chart. Building Serv.Engineer | 43573300001 | |||||
BALFE, Philip Joseph | Geschäftsführer | White Lodge Rectory Drive GU6 7PX Ewhurst Surrey | British | Engineer | 29923830001 | |||||
BALL, Geoffrey Robert | Geschäftsführer | Dial Cottage Church Lane Sevenhampton GL54 5SW Cheltenham Gloucestershire | British | Chartered Engineer | 83110540001 | |||||
BARRETT, Richard John, Bsc, Ceng, Mice | Geschäftsführer | Meadows End Hilliers Lane BS25 5NA Churchill North Somerset | England | British | Chartered Engineer | 121534930001 | ||||
BARROW, Jill Helen | Geschäftsführer | Blackslade Manor Widecombe In The Moor TQ13 7TF Devon | British | Management Consultant | 82386630001 | |||||
BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Geschäftsführer | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | Cor Treasurer | 983300008 | |||||
BINNIE, Christopher Jon Anthony | Geschäftsführer | 4 Reigate Hill Close RH2 9PG Reigate Surrey | British | Civil Engineer | 14298460001 | |||||
BROWN, Peter Allan | Geschäftsführer | Warren Road GU1 2HG Guildford 48 Surrey | British | Chartered Engineer | 30520670001 | |||||
BROWNE, Maximilian George Burrowes | Geschäftsführer | Knockcree Mahee Island Comber N1 BT23 6EP County Down | British | Chartered Civil Engineer | 19130630001 | |||||
BROYD, Timothy William, Professor | Geschäftsführer | 2 Hillbury Gardens CR6 9TQ Warlingham Surrey | England | British | Consultant Engineer | 58859990001 | ||||
BUSBY, Peter Leonard | Geschäftsführer | 8 The Common Ealing W5 3TR London | British | Chartered Civil Engineer | 44813100001 | |||||
CATTO, Ivor Douglas | Geschäftsführer | Highfields KT21 2NL Ashtead 12 Surrey | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 87066030002 | ||||
CLARK, Piers Benedict, Dr | Geschäftsführer | 61 Downs Wood KT18 5UJ Epsom Downs Surrey | United Kingdom | British | Principle Scientist | 84765290001 | ||||
CLARKE, Keith Edward | Geschäftsführer | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | Architect | 93106530002 | ||||
CLEMENTS, David Russell | Geschäftsführer | Southernhay High Street TA17 8SE Hinton St George Somerset | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 22250060002 | ||||
COLLINS, Rodney | Geschäftsführer | The Bothy Forest Road KT24 5ER East Horsley Surrey | British | Civil Engineer | 12906160001 | |||||
CORRIE, Robert Keith | Geschäftsführer | 7 Hawkwood Dell Great Bookham KT23 4JR Leatherhead Surrey | England | British | Civil Engineer | 35957190001 | ||||
CULLENS, Alan James | Geschäftsführer | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | Group Hr Director | 189297280001 | ||||
CUMING, James Anthony | Geschäftsführer | 74 Chenies Mews WC1E 6HU London | England | British | Chartered Engineer | 19130650002 | ||||
CUTHBERT, Richard Harry | Geschäftsführer | Saxons Meath Green Lane RH6 8JA Horley Surrey | United Kingdom | British | Transport Planner | 43573230002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atkinsréalis (Ws) Limited | 14. Dez. 2022 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Confab Limited | 06. Apr. 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Parfab Limited | 06. Apr. 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Second fixed and floating debenture | Erstellt am 27. Feb. 2003 Geliefert am 11. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 18. Dez. 2002 Geliefert am 27. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security assignment in respect of the shepherd contracts | Erstellt am 20. März 2002 Geliefert am 28. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assignor with full title guarantee, as continuing security for the performance and payment of all the secured obligations, hereby assigns and agrees to assign to the assignee all of its right, title, benefit and interest whatsoever present and future in: (a) clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract; and (b) the guarantee insofar as it relates to the contractor's obligations under clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Sharge charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited) | Erstellt am 13. Aug. 1998 Geliefert am 21. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of shares | Erstellt am 04. Jan. 1996 Geliefert am 18. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bridgend custodial services limited to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben All dividends paid or payable on the shares being:- 24,000 "a" shares and 1,000 "b" shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit agreement | Erstellt am 05. März 1992 Geliefert am 10. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date and in respect of the deposit agreement. | |
Kurze Angaben All rights to the repayment of the deposit (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral mortgage | Erstellt am 14. Juni 1988 Geliefert am 28. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from atkins properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86 | |
Kurze Angaben L/H property k/a premises on the third floor of the western wing of sir william atkins house, southern link road epsom, surrey together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral mortgage | Erstellt am 21. Apr. 1988 Geliefert am 10. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86 | |
Kurze Angaben All the l/h property k/a the western wing of sir william atkins house, southern link road, epsom together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and the full benefit of the covenants and guarantee on the part of the company contained in the lease dated 4/3/88. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral mortgage | Erstellt am 30. Jan. 1987 Geliefert am 18. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all moneys due or to become due from scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of subsititution dated 13/7/86 | |
Kurze Angaben All the l/h property demised to the company by the lease or underlease (please see form 395 for full details of property) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral mortgage | Erstellt am 13. Juni 1986 Geliefert am 19. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/86. | |
Kurze Angaben Land and buildings situate to the west of and having access to ashley road, epsom, surrey and continuing to chalk lane on the east and k/a woodcote grove, title no:- p 17436 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 25. Apr. 1985 Geliefert am 02. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts and other debts due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 07. Aug. 1963 Geliefert am 13. Aug. 1963 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property including uncalled capital. (See doc 6). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0