FURNIVAL ESTATES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FURNIVAL ESTATES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00758082 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FURNIVAL ESTATES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FURNIVAL ESTATES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street London W1U 1PB |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FURNIVAL ESTATES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FURNIVAL ESTATES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FURNIVAL ESTATES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von FURNIVAL ESTATES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||
BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar Gibraltar | Gibraltar | British | Solicitor | 69435160001 | ||||
WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | Barrister-In-Law | 80132540006 | ||||
TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor | 135316290001 | |||||||
CURTIS, Ernest Leonard | Sekretär | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
GIBSON, William Mcaulay | Sekretär | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
GILBERT, Nicholas Jay | Sekretär | Woodville 14 Carlton Park Avenue WF8 3HQ Pontefract West Yorkshire | British | 81344240001 | ||||||
JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||
MILLINGTON, Paul Terence | Sekretär | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | British | 58693930003 | ||||||
BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 63940900001 | ||||
BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 63940900001 | ||||
BEST, George Laidler | Geschäftsführer | Kiddall Hall Farm York Road Barwick In Elmet LS14 3AE Leeds West Yorkshire | British | Director | 2748600001 | |||||
CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | Director | 84076630001 | |||||
CURTIS, Ernest Leonard | Geschäftsführer | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | Director | 19382660001 | |||||
EVANS, Andreas Frederick | Geschäftsführer | Leathley Grange LS21 2LA Leathley North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 9485290003 | ||||
EVANS, Dominic Redvers | Geschäftsführer | Pine Lodge 9 Sandmoor Avenue LS17 7DW Leeds West Yorkshire | British | Director | 7095590001 | |||||
EVANS, Frederick Redvers | Geschäftsführer | 16 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | British | Director | 4409160001 | |||||
EVANS, Roderick Michael | Geschäftsführer | Oakhill House Roundhay Park Lane LS17 8AR Leeds | British | Director | 40175270002 | |||||
GIBSON, William Mcaulay | Geschäftsführer | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | Director | 5387660001 | |||||
HELLIWELL, David Alistair | Geschäftsführer | 8 Farndale Close Spofforth Hill LS22 4XE Wetherby West Yorkshire | England | British | Estates Director | 15578740001 | ||||
HORSBROUGH, Pauline Elizabeth | Gesch äftsführer | 30 The Orchard Wrenthorpe WF2 0LL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 4961270001 | ||||
MCKENDRICK, Charles | Geschäftsführer | St Anns Main Street LS22 5EB Kirk Deighton North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 173983190001 | ||||
MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | United Kingdom | British | Accountant | 58693930003 | ||||
TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | Director | 66424440001 | |||||
REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat FURNIVAL ESTATES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999 | Erstellt am 28. Jan. 2002 Geliefert am 06. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The leasehold land known as land ajoining eyre street, furnival street, matilda way and matilda street, sheffield. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999) | Erstellt am 03. Aug. 1999 Geliefert am 16. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 06. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £87,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed | |
Kurze Angaben Together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon (for full details of charge see form 395 and contd sheet). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second supplemental charge deed | Erstellt am 04. Dez. 1992 Geliefert am 08. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Redvers house union street sheffield south yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 21. Nov. 1990 Geliefert am 29. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Redvers marse furnival street sheffield t/n: ywe 60547 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further charge | Erstellt am 19. Sept. 1978 Geliefert am 20. Sept. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,240,000 and all other monies due or to become due from evans of leeds limited to the chargee under the terms of a deed dated 17-6-61. | |
Kurze Angaben Land and buildings situate in sheffield being furnival house, furnival gate, as comprised in a lease dated 15-11-65. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1975 Geliefert am 02. Juli 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Redvers slouse, furnival street, sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Dep of title deed w/i | Erstellt am 23. Dez. 1971 Geliefert am 28. Dez. 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £650,000 | |
Kurze Angaben Property at junction of union st and furnival gate, sheffield, known as redvers house. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 17. Juni 1971 Geliefert am 28. Juni 1971 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,335,000 & all other monies due or to become due from evans of leeds LTD to the chargee any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Furnival house, furnival gate, sheffield comprised in a lease dated 15/11/65. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Dez. 1970 Geliefert am 08. Dez. 1970 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £800,000 due from lonsdale properties LTD to the chargers and for further securing £700,000 outstanding under 2 charges dated respectively 24/06/68 and 30/12/68 and due from the company millshaw property co. LTD and mulgate investments LTD to the chargee. | |
Kurze Angaben Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way and matilda st, sheffield known as furnival house. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1968 Geliefert am 09. Jan. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £427,000 & further securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68, all due from the company and the three other companies referred to therein | |
Kurze Angaben Land containing 891 square yards at the junction of furnival st & union lane in the city of sheffield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Dez. 1968 Geliefert am 09. Jan. 1969 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £427,000 & furthe securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68. all due from the company and three other companies referred to therein. | |
Kurze Angaben Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way, & matilda st, sheffield. 4833 square yards approx. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Juni 1968 Geliefert am 28. Juni 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing £345,000 and all other monies due or to become due from the co, to the chargee on any{ account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining eyre street,furnival street matilda way and matilda street sheffield together with the buildings erected thereon. (See doc 20). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0