CINEWORLD EXHIBITION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CINEWORLD EXHIBITION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00758966 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Power Road Studios 114 Power Road W4 5PY Chiswick London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UGC EXHIBITION LIMITED | 16. Nov. 1999 | 16. Nov. 1999 |
| VC EXHIBITION LIMITED | 23. Aug. 1996 | 23. Aug. 1996 |
| MGM EXHIBITION LIMITED | 06. Apr. 1993 | 06. Apr. 1993 |
| CANNON EXHIBITION LIMITED | 08. Feb. 1989 | 08. Feb. 1989 |
| CANNON CINEMAS LIMITED | 15. Okt. 1985 | 15. Okt. 1985 |
| CANNON CLASSIC CINEMAS LIMITED | 16. Juni 1982 | 16. Juni 1982 |
| CLASSIC CINEMAS PROPERTIES LIMITED | 26. Apr. 1963 | 26. Apr. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Jan. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Matthew Neil Eyre als Direktor am 08. Aug. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charlotte Abigail Brookmyre als Geschäftsführer am 08. Aug. 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Jan. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Merav Keren als Direktor am 23. Juni 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Bowcock als Geschäftsführer am 09. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 ca 2006 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Charlotte Abigail Buck am 27. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Charlotte Abigail Buck als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Wiener als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Yoe als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Olswang Cosec Limited als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 114 Power Road Studios Power Road Chiswick London W4 5PY* am 17. Okt. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Seventh Floor 90 High Holborn London WC1V 6XX* am 16. Okt. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Fiona Elizabeth Smith als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Fiona Elizabeth | Sekretär | Studios 114 Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road | British | 182083050001 | ||||||||||
| EYRE, Matthew Neil | Geschäftsführer | Power Road Studios 114 Power Road Chiswick W4 5PY London Cineworld Group Plc England | England | British | 213190620001 | |||||||||
| KEREN, Merav | Geschäftsführer | 114 Power Road W4 5PY Chiswick Power Road Studios London | United Kingdom | Israeli | 199412670001 | |||||||||
| HEWETT, John Christopher | Sekretär | Railway End 44 The Grip Linton CB1 6NR Cambridge Cambridgeshire | British | 1934250001 | ||||||||||
| LEGGE, Diana Patricia | Sekretär | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||||||
| SMITH, Bernard Arthur | Sekretär | 12 North Holmes Close RH12 4HB Horsham West Sussex | British | 1678790001 | ||||||||||
| TAYLOR, Margaret | Sekretär | 19 Rusthall Avenue W4 1BW London | Irish | 46146250002 | ||||||||||
| ZAMET, Naomi Rae | Sekretär | Flat 1 Merlin House Oak Hill Park Frognal Hampstead NW3 7LJ London | British | 42158970002 | ||||||||||
| GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 5 Chancery Lane Cliffords Inn EC4A 1BU London | 900002550001 | |||||||||||
| HAL MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | Hanover House 14 Hanover Square W1S 1HP London | 2851030001 | |||||||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor United Kingdom |
| 83864780002 | ||||||||||
| ABBOTT, Trevor Michael | Geschäftsführer | Blendons Highcotts Lane West Clandon GU4 7XA Guildford Surrey | British | 35278820001 | ||||||||||
| AUGER, George Albert | Geschäftsführer | 1 Wellington Place Church Lane EN10 7JB Broxbourne Hertfordshire | British | 53897760002 | ||||||||||
| BOWCOCK, Philip | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios | United Kingdom | British | 166007090001 | |||||||||
| BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir | Geschäftsführer | 9 Holland Park W11 3TH London | British | 39498750002 | ||||||||||
| BROOKMYRE, Charlotte Abigail | Geschäftsführer | 114 Power Road W4 5PY Chiswick Power Road Studios London | England | British | 160575040004 | |||||||||
| BURKE, Simon Paul | Geschäftsführer | 35 Chepstow Place W2 4TT London | United Kingdom | Irish | 30017870003 | |||||||||
| CARSON, Thomas Patrick | Geschäftsführer | 1718 Via La Paz Burbank FOREIGN California 91501 Usa | American | 31954990001 | ||||||||||
| COHEN, Malcolm | Geschäftsführer | B D O Stoy Hayward 8 Baker Street W1U 3LL London | United Kingdom | British | 125776060001 | |||||||||
| DEVEREUX, Robert Harold Ferrers | Geschäftsführer | 5 Ladbroke Terrace W11 3PG London | England | British | 68747470001 | |||||||||
| DHADWAR, Sukhrajit Singh | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios United Kingdom | United Kingdom | British | 98926850002 | |||||||||
| DOEREN, William Bernard | Geschäftsführer | 25 Ennismore Mews SW7 1AB London | American | 34151930001 | ||||||||||
| DURA, Jean-Marie | Geschäftsführer | 99 Bis De La Croix Rousse 69004 Lyon France | French | 67133410001 | ||||||||||
| EVANS, Martin John | Geschäftsführer | 44 Heath Gardens TW1 4LZ Twickenham Middlesex | British | 38925660001 | ||||||||||
| HYATT, Gregory John | Geschäftsführer | The Firs 27 Crookham Road GU51 5DP Fleet Hampshire | United Kingdom | British | 61663230001 | |||||||||
| JENKINS, Barry Charles | Geschäftsführer | Homelands Rock Hill BR6 7PP Chelsfield Kent | England | British | 97730910001 | |||||||||
| JONES, Richard David | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios | United Kingdom | British | 45933780006 | |||||||||
| MURPHY, Stephen Thomas Matthew | Geschäftsführer | 23 The Crescent SW13 0NN London | British | 70496800002 | ||||||||||
| SOMMERS, Michael John | Geschäftsführer | Beth House Norrels Drive, East Horsley KT24 5DR Leatherhead Surrey | England | British | 115290220001 | |||||||||
| SUSSFIELD, Alain | Geschäftsführer | 9 Boulevard Delessert Paris, 75016 FOREIGN France | French | 66976410001 | ||||||||||
| TAYLOR, Margaret | Geschäftsführer | 19 Rusthall Avenue W4 1BW London | Irish | 46146250002 | ||||||||||
| VERRECCHIA, Guy | Geschäftsführer | 21 Villa Madrid Neuilly Sur Seine 92200 France | French | 66971470001 | ||||||||||
| WIENER, Stephen Mark | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios | United Kingdom | United States | 41603390004 | |||||||||
| WRIGHT, David Simon | Geschäftsführer | The East House Brightwell Cum Sotwell OX10 0RQ Wallingford Oxfordshire | British | 40965810001 | ||||||||||
| YOE, Tony Tsen Wei | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios United Kingdom | United Kingdom | British | 140231730002 |
Hat CINEWORLD EXHIBITION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Juni 2006 Geliefert am 04. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture dated 1 december 2004 | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 29. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Sept. 1997 Geliefert am 26. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of each obligor (as defined) to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under each or any of the financing documents (as defined)in each case together with all costs,charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben F/H property k/a the abc cinema new broadway ealing greater london t/n MX438267 and other f/h properties l/h land and premises k/a the mgm cinema arcadian centre hurst street birmingham and other l/h property please refer to form 395 for full details of charged property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juni 1996 Geliefert am 15. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the lenders (as defined therein) (or any of them) on any account whatsoever under each or any of the finance documents (as defined therein) (the "secured liabilities") provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that if it were so included, the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juli 1995 Geliefert am 11. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release | Erstellt am 01. Mai 1987 Geliefert am 20. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all moneys due & to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the credit lyonaise bank nederland nv under the terms of a supplemental security assignment of december 1986 and any other agreement or document as defined in the deeed | |
Kurze Angaben The benefit of the distribution agreement listed in exhibit 4 therto a copy of which is annexed hereto for fuller details see doc M30/21 may/ln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendments no 1 to the credit agreement dated 19.12.85 | Erstellt am 19. Dez. 1985 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees as defined under the terms of the credit agreement dated 2.12.85 and/or any other agreement or document as defined in the deed | |
Kurze Angaben All accounts, drafts, letter agreements letters of credits, notes any present or future agreements see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment no 1 to the credit agreement | Erstellt am 19. Dez. 1985 Geliefert am 07. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the banks as defined under the terms of the credit agreement dated 2/12/85 and/or any other agreement or document as defined in the deed | |
Kurze Angaben All present and future obligations and indebtedness (see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 02. Dez. 1985 Geliefert am 11. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the agreement notes, and this deed | |
Kurze Angaben All present and future obligations and indebtedness for further details see doc M242. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Sept. 1985 Geliefert am 17. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 16/9/85 | |
Kurze Angaben (See doc M240). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 1984 Geliefert am 03. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises k/a the classic cinema george lane folkestone shepway district in the county of kent floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 1984 Geliefert am 03. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the classic cinema king st., Ramsgate in the thanet district of the county of the kent title no k 455890 floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Juli 1984 Geliefert am 12. Juli 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The classic cinema & adjoining car park at queen street deal, kent & assignment of the goodwill & connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Jan. 1984 Geliefert am 26. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and bldgs on the western side of high street, cosham, portsmouth k/a the classic cinema, high street, cosham, portsmouth assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1984 Geliefert am 20. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H the columbia theatre 93 shaftesbury avenue london, W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1984 Geliefert am 20. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H the picturedrome cinema at the junction of canada grove & linden road, bognor regis, west sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1984 Geliefert am 20. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as focus 1 and focus 2 high street shopping centre, brentwood, essex title no ex 277688. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 13. Sept. 1983 Geliefert am 15. Sept. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Scala cinema, 25/29 market street, nottiingham floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented at the register of saisnes on the 24-6-82 | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 13. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Classic cinema, 59 kirk road, wishaw. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82 | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 13. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Classi cinema nicolson street edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82 | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 13. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Classic cinema, 520 sauchiehall street, glasgow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 17. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All those premises comprising a cinematograph theatre situate in parts of both levels of the basement and part of the ground floor of the development. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 17. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Cinema premises situate at 65 the haymarket, london, SW1 containing three cinemas with ancillary offices (please doc M21 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Juni 1982 Geliefert am 17. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill (as per schedule attached hereto please see doc M210). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release & substitution | Erstellt am 30. Jan. 1981 Geliefert am 11. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 7TH june, 1972 | |
Kurze Angaben Classic cinemas 1 and 2 horse fair, banbury, oxfordshire title no on 19304. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0