CINEWORLD EXHIBITION LIMITED

CINEWORLD EXHIBITION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCINEWORLD EXHIBITION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00758966
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Power Road Studios
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UGC EXHIBITION LIMITED16. Nov. 199916. Nov. 1999
    VC EXHIBITION LIMITED23. Aug. 199623. Aug. 1996
    MGM EXHIBITION LIMITED06. Apr. 199306. Apr. 1993
    CANNON EXHIBITION LIMITED08. Feb. 198908. Feb. 1989
    CANNON CINEMAS LIMITED15. Okt. 198515. Okt. 1985
    CANNON CLASSIC CINEMAS LIMITED16. Juni 198216. Juni 1982
    CLASSIC CINEMAS PROPERTIES LIMITED26. Apr. 196326. Apr. 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis01. Jan. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Ernennung von Matthew Neil Eyre als Direktor am 08. Aug. 2016

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Charlotte Abigail Brookmyre als Geschäftsführer am 08. Aug. 2016

    2 SeitenTM01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 22. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 4,906
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Jan. 2015

    6 SeitenAA

    Ernennung von Merav Keren als Direktor am 23. Juni 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Bowcock als Geschäftsführer am 09. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 4,906
    SH01

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519 ca 2006
    3 SeitenMISC

    Änderung der Details des Direktors für Miss Charlotte Abigail Buck am 27. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Ernennung von Miss Charlotte Abigail Buck als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Wiener als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 4,906
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Tony Yoe als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Olswang Cosec Limited als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 114 Power Road Studios Power Road Chiswick London W4 5PY* am 17. Okt. 2013

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Seventh Floor 90 High Holborn London WC1V 6XX* am 16. Okt. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Fiona Elizabeth Smith als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, Fiona Elizabeth
    Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road
    Sekretär
    Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road
    British182083050001
    EYRE, Matthew Neil
    Power Road Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Cineworld Group Plc
    England
    Geschäftsführer
    Power Road Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Cineworld Group Plc
    England
    EnglandBritish213190620001
    KEREN, Merav
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    Geschäftsführer
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    United KingdomIsraeli199412670001
    HEWETT, John Christopher
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    British1934250001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Sekretär
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    SMITH, Bernard Arthur
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    British1678790001
    TAYLOR, Margaret
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Sekretär
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Irish46146250002
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Sekretär
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Sekretär
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04051235
    83864780002
    ABBOTT, Trevor Michael
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    British35278820001
    AUGER, George Albert
    1 Wellington Place
    Church Lane
    EN10 7JB Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Wellington Place
    Church Lane
    EN10 7JB Broxbourne
    Hertfordshire
    British53897760002
    BOWCOCK, Philip
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Geschäftsführer
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritish166007090001
    BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    Geschäftsführer
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    British39498750002
    BROOKMYRE, Charlotte Abigail
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    Geschäftsführer
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    EnglandBritish160575040004
    BURKE, Simon Paul
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    Geschäftsführer
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    United KingdomIrish30017870003
    CARSON, Thomas Patrick
    1718 Via La Paz
    Burbank
    FOREIGN California 91501
    Usa
    Geschäftsführer
    1718 Via La Paz
    Burbank
    FOREIGN California 91501
    Usa
    American31954990001
    COHEN, Malcolm
    B D O Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Geschäftsführer
    B D O Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    United KingdomBritish125776060001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Geschäftsführer
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    DHADWAR, Sukhrajit Singh
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritish98926850002
    DOEREN, William Bernard
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    Geschäftsführer
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    American34151930001
    DURA, Jean-Marie
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    Geschäftsführer
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    French67133410001
    EVANS, Martin John
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    British38925660001
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    JENKINS, Barry Charles
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    Geschäftsführer
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish97730910001
    JONES, Richard David
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Geschäftsführer
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritish45933780006
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Geschäftsführer
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    British70496800002
    SOMMERS, Michael John
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish115290220001
    SUSSFIELD, Alain
    9 Boulevard Delessert
    Paris, 75016
    FOREIGN France
    Geschäftsführer
    9 Boulevard Delessert
    Paris, 75016
    FOREIGN France
    French66976410001
    TAYLOR, Margaret
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Geschäftsführer
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Irish46146250002
    VERRECCHIA, Guy
    21 Villa Madrid
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Geschäftsführer
    21 Villa Madrid
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    French66971470001
    WIENER, Stephen Mark
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Geschäftsführer
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomUnited States41603390004
    WRIGHT, David Simon
    The East House
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RQ Wallingford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The East House
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RQ Wallingford
    Oxfordshire
    British40965810001
    YOE, Tony Tsen Wei
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritish140231730002

    Hat CINEWORLD EXHIBITION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 04. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession to a debenture dated 1 december 2004
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 29. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Sept. 1997
    Geliefert am 26. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of each obligor (as defined) to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under each or any of the financing documents (as defined)in each case together with all costs,charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the abc cinema new broadway ealing greater london t/n MX438267 and other f/h properties l/h land and premises k/a the mgm cinema arcadian centre hurst street birmingham and other l/h property please refer to form 395 for full details of charged property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 1996
    Geliefert am 15. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the lenders (as defined therein) (or any of them) on any account whatsoever under each or any of the finance documents (as defined therein) (the "secured liabilities") provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that if it were so included, the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Company (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 1995
    Geliefert am 11. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bankers Trust Companythe "Security Agent"
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release
    Erstellt am 01. Mai 1987
    Geliefert am 20. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all moneys due & to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the credit lyonaise bank nederland nv under the terms of a supplemental security assignment of december 1986 and any other agreement or document as defined in the deeed
    Kurze Angaben
    The benefit of the distribution agreement listed in exhibit 4 therto a copy of which is annexed hereto for fuller details see doc M30/21 may/ln.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonais Bank Nederland Nv
    Transaktionen
    • 20. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Amendments no 1 to the credit agreement dated 19.12.85
    Erstellt am 19. Dez. 1985
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees as defined under the terms of the credit agreement dated 2.12.85 and/or any other agreement or document as defined in the deed
    Kurze Angaben
    All accounts, drafts, letter agreements letters of credits, notes any present or future agreements see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Banks (Rider 1)See Doc for Full Details
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    Amendment no 1 to the credit agreement
    Erstellt am 19. Dez. 1985
    Geliefert am 07. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the banks as defined under the terms of the credit agreement dated 2/12/85 and/or any other agreement or document as defined in the deed
    Kurze Angaben
    All present and future obligations and indebtedness (see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Banks Set Out in Rider 1
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Credit agreement
    Erstellt am 02. Dez. 1985
    Geliefert am 11. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the agreement notes, and this deed
    Kurze Angaben
    All present and future obligations and indebtedness for further details see doc M242.
    Berechtigte Personen
    • The Banks Set Out in Rider 1
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 1985
    Geliefert am 17. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 16/9/85
    Kurze Angaben
    (See doc M240). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 1984
    Geliefert am 03. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a the classic cinema george lane folkestone shepway district in the county of kent floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 1984
    Geliefert am 03. Okt. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the classic cinema king st., Ramsgate in the thanet district of the county of the kent title no k 455890 floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juli 1984
    Geliefert am 12. Juli 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The classic cinema & adjoining car park at queen street deal, kent & assignment of the goodwill & connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 20. Jan. 1984
    Geliefert am 26. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and bldgs on the western side of high street, cosham, portsmouth k/a the classic cinema, high street, cosham, portsmouth assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 1984
    Geliefert am 20. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H the columbia theatre 93 shaftesbury avenue london, W1.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 1984
    Geliefert am 20. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H the picturedrome cinema at the junction of canada grove & linden road, bognor regis, west sussex.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 19. Jan. 1984
    Geliefert am 20. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as focus 1 and focus 2 high street shopping centre, brentwood, essex title no ex 277688.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 13. Sept. 1983
    Geliefert am 15. Sept. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Scala cinema, 25/29 market street, nottiingham floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    Standard security which was presented at the register of saisnes on the 24-6-82
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 13. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Classic cinema, 59 kirk road, wishaw.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 13. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Classi cinema nicolson street edinburgh.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 13. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Classic cinema, 520 sauchiehall street, glasgow.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 13. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 17. Juni 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All those premises comprising a cinematograph theatre situate in parts of both levels of the basement and part of the ground floor of the development.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 17. Juni 1982Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 17. Juni 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cinema premises situate at 65 the haymarket, london, SW1 containing three cinemas with ancillary offices (please doc M21 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 17. Juni 1982Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 11. Juni 1982
    Geliefert am 17. Juni 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill (as per schedule attached hereto please see doc M210).
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 17. Juni 1982Registrierung einer Belastung
    Deed of release & substitution
    Erstellt am 30. Jan. 1981
    Geliefert am 11. Feb. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 7TH june, 1972
    Kurze Angaben
    Classic cinemas 1 and 2 horse fair, banbury, oxfordshire title no on 19304.
    Berechtigte Personen
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1981Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0