CASANOVA CLUB LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CASANOVA CLUB LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00759903 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASANOVA CLUB LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CASANOVA CLUB LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 8EW London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASANOVA CLUB LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TOP OF THE WORLD LIMITED | 06. Mai 1963 | 06. Mai 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASANOVA CLUB LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASANOVA CLUB LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Feb. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for London Clubs Limited as a person with significant control on 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for London Clubs Limited as a person with significant control on 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Ernennung von Mr Krishan Kaushal als Sekretär am 01. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Daniel Cohen als Sekretär am 04. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary William Loveman als Geschäftsführer am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roy Alfred Charles Ramm als Geschäftsführer am 01. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Brick Street London W1J 7HQ zum 55 Baker Street London W1U 8EW am 24. März 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alexis George Oswald am 29. Dez. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Alexis George Oswald als Direktor am 27. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Silberling als Geschäftsführer am 27. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASANOVA CLUB LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUSHAL, Krishan | Sekretär | Baker Street W1U 8EW London 55 England | 240946710001 | |||||||
| OSWALD, Alexis George | Geschäftsführer | Baker Street W1U 8EW London 55 England | United Kingdom | British | 192560850002 | |||||
| ROTHWELL, Michael | Geschäftsführer | Vicentia Court Bridges Court Road SW11 3GY London Apartment 43, | United Kingdom | British | 116799060007 | |||||
| COHEN, Michael Daniel | Sekretär | 10722 Gray Havens Court NV89135 Las Vegas Nevada 89135 Usa | American | 121989990001 | ||||||
| GORMAN, Jeremy Philip | Sekretär | 19 Connaught Square W2 2HJ London | British | 3290440003 | ||||||
| PANNETT, George John Robert | Sekretär | Maytime 9 Woodlands Way KT21 1LH Ashtead Surrey | British | 1961250001 | ||||||
| TALBOT, Richard Ian | Sekretär | Oakwood House Woodlands Court Filton Road Hambrook BS16 1QG Bristol | British | 15269400002 | ||||||
| ATWOOD, Charles Lafayette | Geschäftsführer | One Hughes Centre Drive Las Vegas Nevada Nv89109 Usa | Us | 120659070001 | ||||||
| BRAHAM, Michael Derrick | Geschäftsführer | Mayfield Middle Way Kinston Gorse BN16 1RY East Preston West Sussex | British | 8456390001 | ||||||
| BRAWLEY, James | Geschäftsführer | 3 Sydcote Rosendale Road West Dulwich SE21 8LH London | British | 33732450001 | ||||||
| BRUNS II, John Frederic | Geschäftsführer | 9e Thorney Court Palace Gate W8 5NJ London | Usa | 124522430002 | ||||||
| FREED, Simon Raymond | Geschäftsführer | Rose Court Woodland Lane Chorleywood WD3 5LS Rickmansworth Hertfordshire | British | 1961260001 | ||||||
| HARDY, George Barry Conyers | Geschäftsführer | 6 The Bourne Townsend Lane AL5 2PW Harpenden Hertfordshire | England | British | 38430002 | |||||
| ISAACS, Philip Leonard | Geschäftsführer | 16 Imperial Court NW8 7PT London | British | 12545650001 | ||||||
| KINGSLEY, Max Myer | Geschäftsführer | 13 Hocroft Road NW2 2BP London | British | 24036130002 | ||||||
| LOVEMAN, Gary William | Geschäftsführer | 5 Sabrina Farm Road MA02482 Wellesley Ma 02482 Us | Usa | American | 86449970002 | |||||
| PANNETT, George John Robert | Geschäftsführer | Maytime 9 Woodlands Way KT21 1LH Ashtead Surrey | British | 1961250001 | ||||||
| RAMM, Roy Alfred Charles | Geschäftsführer | 10 Brick Street W1J 7HQ London | United Kingdom | British | 112948830001 | |||||
| SILBERLING, Michael John | Geschäftsführer | Portman Close W1H 6BR London 19 United Kingdom | United Kingdom | Usa | 130048270002 | |||||
| TIMMINS, William | Geschäftsführer | Apartment 8 2-4 Hyde Park Gate SW7 5EW London | British | 64708660004 | ||||||
| DRIVEMADE LIMITED | Geschäftsführer | 10 Brick Street W1Y 8HQ London | 30185160003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASANOVA CLUB LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lci Plc | 06. Apr. 2016 | Baker Street W1U 8EW London 55 United Kingdom | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat CASANOVA CLUB LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Juni 1994 Geliefert am 17. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and overdraft letter both dated 24TH may 1994 and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine mortgage debenture | Erstellt am 07. Apr. 1993 Geliefert am 24. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the mezzanine lenders (as defined) under or in connection with clause 2 of the deed | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Junior/senior mortgage debenture | Erstellt am 07. Apr. 1993 Geliefert am 24. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the banks under clause 2 of the deed | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior mortgage debenture | Erstellt am 07. Apr. 1993 Geliefert am 24. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness,monies,obligations and liabilities now or hereafter due,owing or incurred by each borrower (as defined therein) and each company (as defined therein) to the beneficiaries (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the senior mortgage debenture dated 7.4.93. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Lcm mortgage debenture | Erstellt am 07. Apr. 1993 Geliefert am 07. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing all indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by each company (as defined therein) to the lender (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the lcm mortgage debenture dated 7TH april 1993 | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Sept. 1992 Geliefert am 15. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the charge | |
Kurze Angaben See form 395 ref M82. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental senior guarantee and debenture | Erstellt am 30. März 1992 Geliefert am 07. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement dated 5TH may 1989 (as amended) | |
Kurze Angaben See form 395 ref M175. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed & supplemental charge | Erstellt am 18. Aug. 1989 Geliefert am 08. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben (See form 395 ref M272 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzarine guarantee & debenture | Erstellt am 11. Mai 1989 Geliefert am 23. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Senior guarantee & debenture | Erstellt am 11. Mai 1989 Geliefert am 23. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Junior senior guarantee & debenture | Erstellt am 11. Mai 1989 Geliefert am 23. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0