CASANOVA CLUB LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCASANOVA CLUB LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00759903
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CASANOVA CLUB LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CASANOVA CLUB LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 8EW London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CASANOVA CLUB LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOP OF THE WORLD LIMITED06. Mai 196306. Mai 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASANOVA CLUB LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für CASANOVA CLUB LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 21. Feb. 2018

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for London Clubs Limited as a person with significant control on 01. Feb. 2018

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for London Clubs Limited as a person with significant control on 01. Feb. 2018

    2 SeitenPSC05

    Ernennung von Mr Krishan Kaushal als Sekretär am 01. Nov. 2017

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael Daniel Cohen als Sekretär am 04. Apr. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 01. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 37,500
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Gary William Loveman als Geschäftsführer am 01. Juli 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Roy Alfred Charles Ramm als Geschäftsführer am 01. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Brick Street London W1J 7HQ zum 55 Baker Street London W1U 8EW am 24. März 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 37,500
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Alexis George Oswald am 29. Dez. 2014

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Alexis George Oswald als Direktor am 27. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael John Silberling als Geschäftsführer am 27. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CASANOVA CLUB LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KAUSHAL, Krishan
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Sekretär
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    240946710001
    OSWALD, Alexis George
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    United KingdomBritish192560850002
    ROTHWELL, Michael
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    Geschäftsführer
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    United KingdomBritish116799060007
    COHEN, Michael Daniel
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    Sekretär
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    American121989990001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Sekretär
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    TALBOT, Richard Ian
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    Sekretär
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    British15269400002
    ATWOOD, Charles Lafayette
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Geschäftsführer
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Us120659070001
    BRAHAM, Michael Derrick
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    British8456390001
    BRAWLEY, James
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    Geschäftsführer
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    British33732450001
    BRUNS II, John Frederic
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Geschäftsführer
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Usa124522430002
    FREED, Simon Raymond
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    British1961260001
    HARDY, George Barry Conyers
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish38430002
    ISAACS, Philip Leonard
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    Geschäftsführer
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    British12545650001
    KINGSLEY, Max Myer
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    Geschäftsführer
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    British24036130002
    LOVEMAN, Gary William
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    Geschäftsführer
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    UsaAmerican86449970002
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    RAMM, Roy Alfred Charles
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    Geschäftsführer
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    United KingdomBritish112948830001
    SILBERLING, Michael John
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    United KingdomUsa130048270002
    TIMMINS, William
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    Geschäftsführer
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    British64708660004
    DRIVEMADE LIMITED
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    Geschäftsführer
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    30185160003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASANOVA CLUB LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Lci Plc
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RechtsgrundlageThe Companies Act Of 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CASANOVA CLUB LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Juni 1994
    Geliefert am 17. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and overdraft letter both dated 24TH may 1994 and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 17. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mezzanine mortgage debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1993
    Geliefert am 24. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the mezzanine lenders (as defined) under or in connection with clause 2 of the deed
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Junior/senior mortgage debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1993
    Geliefert am 24. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the banks under clause 2 of the deed
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior mortgage debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1993
    Geliefert am 24. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness,monies,obligations and liabilities now or hereafter due,owing or incurred by each borrower (as defined therein) and each company (as defined therein) to the beneficiaries (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the senior mortgage debenture dated 7.4.93.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Lcm mortgage debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1993
    Geliefert am 07. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by each company (as defined therein) to the lender (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the lcm mortgage debenture dated 7TH april 1993
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • London Clubs Management Limited
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Sept. 1992
    Geliefert am 15. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M82. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Overdraft Bank Andthe Overdraft Guarantors
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental senior guarantee and debenture
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 07. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement dated 5TH may 1989 (as amended)
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M175. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee Thereunder and to the Banks and Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed & supplemental charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 08. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref M272 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mezzarine guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 23. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank as Agent and Trustee for the Lenders
    Transaktionen
    • 23. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 23. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trade for the Banks and the Overdraft Bank
    Transaktionen
    • 23. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Junior senior guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Mai 1989
    Geliefert am 23. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 23. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Nov. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0