THE HOMARK GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE HOMARK GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00763384 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE HOMARK GROUP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HOMARK ASSOCIATES LIMITED | 06. Juni 1963 | 06. Juni 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kachmer als Geschäftsführer am 03. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Adrian David Gray als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Sekretär | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Sekretär | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| ELDRED, Alan Herbert | Sekretär | 20 Broadway Gardens PE1 4DU Peterborough Cambridgeshire | British | 59561230001 | ||||||||||
| FENTON, Nicola Jane | Sekretär | Flat 1 56 Rosslyn Hill NW3 1ND Hampstead London | British | 31440290005 | ||||||||||
| HAMPSON, Michael David | Sekretär | 58 Chestnut Avenue KT10 8JF Esher Surrey | British | 12688630001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| WAYMAN, Graham Charles | Sekretär | Rose Cottage Newtown, Witchampton BH21 5AU Wimborne Dorset | British | 150508280001 | ||||||||||
| WISEMAN, Julian Richard | Sekretär | 37 Elms Avenue Lilliput BH14 8EE Poole Dorset | British | 30890980001 | ||||||||||
| BELL, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | 10 Cellars Farm Road BH6 4DL Bournemouth Dorset | British | 56616870001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| COLDWELL, David John | Geschäftsführer | Oakleys Farmhouse Maiden Street Weston SG4 7DQ Hitchin Hertfordshire | British | 48115910001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Geschäftsführer | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| CORBETT, Robert William | Geschäftsführer | 9 Jupiter Way Corfe Mullen BH21 3XG Wimborne Dorset | British | 30890970001 | ||||||||||
| CRABB, David | Geschäftsführer | 47 Kings Road HP4 3BJ Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 24375840002 | |||||||||
| DAVIES, Ieuan | Geschäftsführer | 38b Vicarage Road BH31 7DP Verwood Dorset | British | 38455660001 | ||||||||||
| DE ST PAER, Michael John | Geschäftsführer | Highway Farm Great Staughton PE19 5BG St. Neots Cambridgeshire | British | 77760720002 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FAIRHURST, Russell | Geschäftsführer | 137 Colworth Road Leytonstone E11 1JE London | British | 44556020001 | ||||||||||
| HARTLEY, Kim | Geschäftsführer | 48 Lulworth Avenue Hamworthy BH15 4DJ Poole Dorset | British | 35511980001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Richard John | Geschäftsführer | The Gables Ledbury Road, Eastnor HR8 1EL Ledbury Herefordshire | British | 79012830002 | ||||||||||
| SPENCER, Peter David | Geschäftsführer | The White House Broome Lane Blakedown DY10 3LP Kidderminster Worcestershire | British | 78077650001 | ||||||||||
| STEWART, Terence Harry Fitzgibbon | Geschäftsführer | 83 Canford Cliffs Road Branksome Park BH13 7AH Poole Dorset | British | 24375850002 | ||||||||||
| WISEMAN, Julian Richard | Geschäftsführer | 37 Elms Avenue Lilliput BH14 8EE Poole Dorset | British | 30890980001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Hat THE HOMARK GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental deposit deed | Erstellt am 02. Feb. 1993 Geliefert am 03. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30.4.79 (as defined) | |
Kurze Angaben Deposit of £22,500 with messrs laytons,st.bartholomews,lewins mead,bristol,BS1 2NH. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Okt. 1992 Geliefert am 27. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 43A pottery road parkstone poole dorset BH14 8RB t/n dti 12864. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 19. Okt. 1992 Geliefert am 21. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Okt. 1992 Geliefert am 21. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 29. Apr. 1983 Geliefert am 18. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current | |
Kurze Angaben 64/64 shares in zerlina ii together with her boats & appurtenances offical no 309988. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Apr. 1983 Geliefert am 05. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north east side of pattery road poole dorset and/or the proceeds of sale thereof title no at 12864. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0