CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00772316 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CULINA GROUP LIMITED Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Shropshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CERT PROPERTIES LIMITED | 05. Dez. 1988 | 05. Dez. 1988 |
| CERT HOLDINGS LIMITED | 09. Feb. 1987 | 09. Feb. 1987 |
| LESLIE F. SMITH (HOLDINGS) LIMITED | 29. Aug. 1963 | 29. Aug. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christian Lee Price als Direktor am 24. Feb. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Arthur Thomas Michael Naylor als Geschäftsführer am 14. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Nigel Stephen Jury als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Naylor als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Thomas Arthur Naylor als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 186262530001 | |||||||
| JURY, Nigel Stephen | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 169320190001 | |||||
| PRICE, Christian Lee | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire | United Kingdom | British | 205439820001 | |||||
| VAN MOURIK, Thomas | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | England | Dutch | 108562780001 | |||||
| JURY, Nigel Stephen | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 169306870001 | |||||||
| NAYLOR, Michael Thomas Arthur | Sekretär | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | 176032220001 | |||||||
| O'BRIEN, Vincent | Sekretär | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | Irish | 138590150001 | ||||||
| TAYLOR, Gregory Robert | Sekretär | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | British | 38832300001 | ||||||
| CERT SECRETARIES LIMITED | Sekretär | St Martins Road EN11 0BT Hoddesdon Cert Octavian House Hertfordshire United Kingdom | 4922810002 | |||||||
| CERT SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Cert House Charlton Mead Lane EN11 0DJ Hoddesdon Hertfordshire | 4922810001 | |||||||
| DANIEL, Stephen Charles | Geschäftsführer | The Byre House Great Fowle Hall Darman Lane TN12 6PW Paddock Wood Kent | British | 43976670001 | ||||||
| FINLAYSON-GREEN, Anthony Raymond | Geschäftsführer | 141 Three Bridges Road Three Bridges RH10 1JT Crawley Woodcroft West Sussex | United Kingdom | British | 128136310001 | |||||
| GORDON, Stuart Linton | Geschäftsführer | 62 Park Head Road S11 9RB Sheffield South Yorkshire | England | British | 155580001 | |||||
| NAYLOR, Arthur Thomas Michael | Geschäftsführer | c/o Culina Group Limited Tern Valley Business Park TF9 3SQ Market Drayton Culina Group Limited Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 169270540001 | |||||
| O'BRIEN, Vincent | Geschäftsführer | Haslemere Avenue EN4 8EY Barnet 17 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138590150001 | |||||
| RENNIE, Barry | Geschäftsführer | Inglewood 36 Hulmes Road Failsworth M35 0PL Manchester Lancashire | British | 1030100001 | ||||||
| SPIBEY, George Arthur | Geschäftsführer | 5 Spicers Close Claverley WV5 7BY Wolverhampton West Midlands | British | 16797520001 | ||||||
| STANTON, Jeffrey | Geschäftsführer | 9 Brownswood Road HP9 2NU Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 41676230001 | |||||
| TAYLOR, Gregory Robert | Geschäftsführer | 37 Clifford Road EN5 5PD New Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 38832300001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culina Group Limited | 06. Apr. 2016 | Shrewsbury Road TF9 3SQ Market Drayton Tern Valley Business Park Shropshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Sept. 1998 Geliefert am 10. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings at charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n's HD165312 HD270148 and HD270149. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a warehouse at hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/n syk 134764 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a warehouse at calver road winwick quay warrington cheshire t/n CH324362 and CH341250 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 01. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 165312. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 270148. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 270149. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 1994 Geliefert am 04. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 20 january 1994 | |
Kurze Angaben Cert house charlton mead lane hoddesdon herts t/nos.HD165312 HD270148 HD2701249. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Feb. 1992 Geliefert am 28. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon herts t/n hd 270148. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Feb. 1992 Geliefert am 28. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon herts t/n hd 270149. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1991 Geliefert am 15. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the south of mill lane winwick quay warrington cheshire t/n-CH324362. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1990 Geliefert am 16. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of hellaby lane hellaby rotherham south yorkshre t/no syk 134764. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Okt. 1990 Geliefert am 16. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land and buildings to the south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/no hd 165312. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Okt. 1990 Geliefert am 11. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or cert PLC under the terms of a facility letter dated 8.10.90 a guarantee dated 9.10.90 and/or this charge to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property situate at and k/a victoria warehouse 40 victoria way charlton london SE7 t/no:- sgl 94429 and any park or parts thereof and all buildings structures and fixtures (including trade fixtures, fixed plant and machinery). (Please see doc 395/m/49/l/ 11/10 for complete details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Sept. 1989 Geliefert am 18. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/no. Hd 165312 and or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmatry charge | Erstellt am 26. Juli 1989 Geliefert am 03. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplementary to a mortgage debenture dated 10/10/86 | |
Kurze Angaben The property and assets as charged by the mortgage debenture dated 20/10/86. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Okt. 1986 Geliefert am 30. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0