CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED

CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00772316
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CULINA GROUP LIMITED
    Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Shropshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CERT PROPERTIES LIMITED05. Dez. 198805. Dez. 1988
    CERT HOLDINGS LIMITED09. Feb. 198709. Feb. 1987
    LESLIE F. SMITH (HOLDINGS) LIMITED29. Aug. 196329. Aug. 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Christian Lee Price als Direktor am 24. Feb. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Arthur Thomas Michael Naylor als Geschäftsführer am 14. Nov. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Juni 2015

    • Kapital: GBP 32,366
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Juli 2014

    • Kapital: GBP 32,366
    SH01

    Ernennung von Mr Nigel Stephen Jury als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Michael Naylor als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. Dez. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Michael Thomas Arthur Naylor als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    186262530001
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish169320190001
    PRICE, Christian Lee
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United KingdomBritish205439820001
    VAN MOURIK, Thomas
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandDutch108562780001
    JURY, Nigel Stephen
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    169306870001
    NAYLOR, Michael Thomas Arthur
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    176032220001
    O'BRIEN, Vincent
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Irish138590150001
    TAYLOR, Gregory Robert
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    Sekretär
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    British38832300001
    CERT SECRETARIES LIMITED
    St Martins Road
    EN11 0BT Hoddesdon
    Cert Octavian House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    St Martins Road
    EN11 0BT Hoddesdon
    Cert Octavian House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    4922810002
    CERT SECRETARIES LIMITED
    Cert House
    Charlton Mead Lane
    EN11 0DJ Hoddesdon
    Hertfordshire
    Sekretär
    Cert House
    Charlton Mead Lane
    EN11 0DJ Hoddesdon
    Hertfordshire
    4922810001
    DANIEL, Stephen Charles
    The Byre House Great Fowle Hall
    Darman Lane
    TN12 6PW Paddock Wood
    Kent
    Geschäftsführer
    The Byre House Great Fowle Hall
    Darman Lane
    TN12 6PW Paddock Wood
    Kent
    British43976670001
    FINLAYSON-GREEN, Anthony Raymond
    141 Three Bridges Road
    Three Bridges
    RH10 1JT Crawley
    Woodcroft
    West Sussex
    Geschäftsführer
    141 Three Bridges Road
    Three Bridges
    RH10 1JT Crawley
    Woodcroft
    West Sussex
    United KingdomBritish128136310001
    GORDON, Stuart Linton
    62 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    62 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish155580001
    NAYLOR, Arthur Thomas Michael
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Culina Group Limited
    Tern Valley Business Park
    TF9 3SQ Market Drayton
    Culina Group Limited
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish169270540001
    O'BRIEN, Vincent
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Haslemere Avenue
    EN4 8EY Barnet
    17
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138590150001
    RENNIE, Barry
    Inglewood 36 Hulmes Road
    Failsworth
    M35 0PL Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Inglewood 36 Hulmes Road
    Failsworth
    M35 0PL Manchester
    Lancashire
    British1030100001
    SPIBEY, George Arthur
    5 Spicers Close
    Claverley
    WV5 7BY Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Spicers Close
    Claverley
    WV5 7BY Wolverhampton
    West Midlands
    British16797520001
    STANTON, Jeffrey
    9 Brownswood Road
    HP9 2NU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    9 Brownswood Road
    HP9 2NU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish41676230001
    TAYLOR, Gregory Robert
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    37 Clifford Road
    EN5 5PD New Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish38832300001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Culina Group Limited
    Shrewsbury Road
    TF9 3SQ Market Drayton
    Tern Valley Business Park
    Shropshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Shrewsbury Road
    TF9 3SQ Market Drayton
    Tern Valley Business Park
    Shropshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer5525931
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CULINA AMBIENT PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Sept. 1998
    Geliefert am 10. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings at charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n's HD165312 HD270148 and HD270149. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 01. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a warehouse at hellaby lane hellaby rotherham south yorkshire t/n syk 134764 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 01. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a warehouse at calver road winwick quay warrington cheshire t/n CH324362 and CH341250 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 01. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 1995
    Geliefert am 14. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 165312.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 1995
    Geliefert am 14. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 270148.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 1995
    Geliefert am 14. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/n hd 270149.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Jan. 1994
    Geliefert am 04. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 20 january 1994
    Kurze Angaben
    Cert house charlton mead lane hoddesdon herts t/nos.HD165312 HD270148 HD2701249.
    Berechtigte Personen
    • Haworth Company Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 28. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon herts t/n hd 270148.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 28. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the south of charlton mead lane hoddesdon herts t/n hd 270149.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1991
    Geliefert am 15. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of mill lane winwick quay warrington cheshire t/n-CH324362.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1990
    Geliefert am 16. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of hellaby lane hellaby rotherham south yorkshre t/no syk 134764.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1990
    Geliefert am 16. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/no hd 165312.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 1990
    Geliefert am 11. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or cert PLC under the terms of a facility letter dated 8.10.90 a guarantee dated 9.10.90 and/or this charge to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property situate at and k/a victoria warehouse 40 victoria way charlton london SE7 t/no:- sgl 94429 and any park or parts thereof and all buildings structures and fixtures (including trade fixtures, fixed plant and machinery). (Please see doc 395/m/49/l/ 11/10 for complete details).
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Sept. 1989
    Geliefert am 18. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings south east of charlton mead lane hoddesdon hertfordshire t/no. Hd 165312 and or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    Confirmatry charge
    Erstellt am 26. Juli 1989
    Geliefert am 03. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplementary to a mortgage debenture dated 10/10/86
    Kurze Angaben
    The property and assets as charged by the mortgage debenture dated 20/10/86.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Okt. 1986
    Geliefert am 30. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1986Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0