SECKLOE 183 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSECKLOE 183 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00776237
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SECKLOE 183 LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich SECKLOE 183 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SECKLOE 183 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BART SPICES LIMITED07. März 198807. März 1988
    BART PRINTS LIMITED04. Okt. 196304. Okt. 1963

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SECKLOE 183 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für SECKLOE 183 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2018

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Damien Mead als Geschäftsführer am 01. März 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Jörg Herden als Direktor am 19. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Ernennung von Mr Damien Mead als Direktor am 08. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Keith James Crossley als Sekretär am 29. Jan. 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Keith James Crossley als Geschäftsführer am 29. Jan. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 60,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 60,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 007762370015

    31 SeitenMR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 60,000
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von SECKLOE 183 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLLARD, David John
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Geschäftsführer
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish109277440001
    HERDEN, Jörg
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    Geschäftsführer
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    GermanyGerman239484930001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Sekretär
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    English4433650001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Sekretär
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    169652300001
    MARTIN, Alan Renwick
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    British1776940001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Sekretär
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    British95053190001
    THOMAS, Keith Leslie
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    Sekretär
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    British16622820001
    WAINE, Deborah Lynne
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    Sekretär
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    British95095690001
    BARD, Stanley
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    Geschäftsführer
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    British8229370001
    BARTLAM, Andrew James
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    British39431620001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Geschäftsführer
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    English4433650001
    BARTLAM, Reginald Joseph
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Geschäftsführer
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    British4433670001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Geschäftsführer
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritish142394800001
    BRENNAN, John Edward
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48192180002
    CAMPION, David Bardsley
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish9623060001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Geschäftsführer
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish169651660001
    FORD, Peter Michael
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    Geschäftsführer
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    EnglandBritish16613000001
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglish3661150002
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglish3661150002
    JOYNER, Gene Austin
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    Geschäftsführer
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    United KingdomBritish95053150002
    MEAD, Damien
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Geschäftsführer
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    EnglandBritish189835980001
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Geschäftsführer
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    SHAW, Edward Clive Vernon
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    Geschäftsführer
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    British41937220002
    SHAW, Matthew
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Geschäftsführer
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish163272250001
    STOTT, Keith John
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    EnglandBritish180692390001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Geschäftsführer
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish95053190001
    TAPE, Julie
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    Geschäftsführer
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    United KingdomBritish95053190001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SECKLOE 183 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    06. Apr. 2016
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04937130
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat SECKLOE 183 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 01. Apr. 2014
    Geliefert am 09. Apr. 2014
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2010
    Geliefert am 14. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 30. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 2009
    Geliefert am 21. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Warehouse premises fronting mead street,york road and st lukes rd,bedminster,bristol; AV215197. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 24. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Warehouse premises fronting mead street and york road,bedminster,bristol; BL63264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of accession pursuant to a debenture dated 5TH october 2001
    Erstellt am 15. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by each obligor to the chargees under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.Atrading as Rabobank International London Branch, as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Mai 2000
    Geliefert am 12. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 12. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 10. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. März 1993
    Geliefert am 01. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. März 1993
    Geliefert am 01. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the south east side of york road bedminster bristol avon t/no.AV215197 and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Aug. 1984
    Geliefert am 13. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    • 29. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1980
    Geliefert am 08. Juli 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land at premises at mead st, york road & st lukes road bristol together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1980Registrierung einer Belastung
    • 29. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over agreement to lease
    Erstellt am 02. Feb. 1979
    Geliefert am 07. Feb. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the right title & interest of the company in the property being leasehold land situate at & having frontage on to mead street. York road & st. Lukes road bristol by virtue of an agreement dated 1.1.79 made between the company & the city council of bristol.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1979Registrierung einer Belastung
    • 29. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. Feb. 1979
    Geliefert am 07. Feb. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1979Registrierung einer Belastung
    • 29. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0