SECKLOE 183 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SECKLOE 183 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00776237 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SECKLOE 183 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SECKLOE 183 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SECKLOE 183 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BART SPICES LIMITED | 07. März 1988 | 07. März 1988 |
| BART PRINTS LIMITED | 04. Okt. 1963 | 04. Okt. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SECKLOE 183 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SECKLOE 183 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damien Mead als Geschäftsführer am 01. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jörg Herden als Direktor am 19. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Damien Mead als Direktor am 08. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith James Crossley als Sekretär am 29. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith James Crossley als Geschäftsführer am 29. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 007762370015 | 31 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SECKLOE 183 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLARD, David John | Geschäftsführer | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | United Kingdom | British | 109277440001 | |||||
| HERDEN, Jörg | Geschäftsführer | Industriestrabe 49201 Dissen 25 Germany | Germany | German | 239484930001 | |||||
| BARTLAM, Josephine | Sekretär | Longwood House Clevedon Road Failand BS8 3TL Bristol | English | 4433650001 | ||||||
| CROSSLEY, Keith James | Sekretär | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | 169652300001 | |||||||
| MARTIN, Alan Renwick | Sekretär | 2b The Crosspath WD7 8HN Radlett Hertfordshire | British | 1776940001 | ||||||
| TAPE, Julie | Sekretär | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | British | 95053190001 | ||||||
| THOMAS, Keith Leslie | Sekretär | 62 Old Dover Road Capel Le Ferne CT18 7HW Folkestone Kent | British | 16622820001 | ||||||
| WAINE, Deborah Lynne | Sekretär | 560 Wells Road Whitchurch BS14 9BB Bristol | British | 95095690001 | ||||||
| BARD, Stanley | Geschäftsführer | 7 Crooked Usage N3 3HD London | British | 8229370001 | ||||||
| BARTLAM, Andrew James | Geschäftsführer | 25 St Oswalds Court St Oswalds Road BS6 7HX Bristol Avon | British | 39431620001 | ||||||
| BARTLAM, Josephine | Geschäftsführer | Longwood House Clevedon Road Failand BS8 3TL Bristol | English | 4433650001 | ||||||
| BARTLAM, Reginald Joseph | Geschäftsführer | Longwood House Clevedon Road Failand BS8 3TL Bristol | British | 4433670001 | ||||||
| BOYD, Stephen Alexander | Geschäftsführer | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | England | British | 142394800001 | |||||
| BRENNAN, John Edward | Geschäftsführer | Sagamore House Hedgerley Lane SL9 7NP Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 48192180002 | |||||
| CAMPION, David Bardsley | Geschäftsführer | Monarchy Hall Farm Utkinton CW6 0JZ Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 9623060001 | |||||
| CROSSLEY, Keith James | Geschäftsführer | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | United Kingdom | British | 169651660001 | |||||
| FORD, Peter Michael | Geschäftsführer | White Strake Hawksdown Road Walmer CT14 7PW Deal Kent | England | British | 16613000001 | |||||
| GARLAND, Roderick John | Geschäftsführer | Huntleigh Hadham Cross SG10 6AL Much Hadham Hertfordshire | United Kingdom | English | 3661150002 | |||||
| GARLAND, Roderick John | Geschäftsführer | Huntleigh Hadham Cross SG10 6AL Much Hadham Hertfordshire | United Kingdom | English | 3661150002 | |||||
| JOYNER, Gene Austin | Geschäftsführer | Brook House Mill Lane Compton Martin BS40 6NA Bristol Bath And North Somerset | United Kingdom | British | 95053150002 | |||||
| MEAD, Damien | Geschäftsführer | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | England | British | 189835980001 | |||||
| SHARPE, Clive Richard | Geschäftsführer | Knighton Rise LE2 2RE Leicester 18 Leics | England | British | 134995270001 | |||||
| SHAW, Edward Clive Vernon | Geschäftsführer | The Old Barn 4 Seavale Mews BS21 7QB Clevedon North Somerset | British | 41937220002 | ||||||
| SHAW, Matthew | Geschäftsführer | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | United Kingdom | British | 163272250001 | |||||
| STOTT, Keith John | Geschäftsführer | Whitecroft Church Lane SG8 0SE Abington Pigotts Cambridgeshire | England | British | 180692390001 | |||||
| TAPE, Julie | Geschäftsführer | C/O Barts Spices Limited York Road BS3 4AD Bedminster Bristol | United Kingdom | British | 95053190001 | |||||
| TAPE, Julie | Geschäftsführer | The Garden House Butcombe Court BS40 5TR Redhill North Somerset | United Kingdom | British | 95053190001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SECKLOE 183 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bart Ingredients Co. Limited | 06. Apr. 2016 | York Road Bedminster BS3 4AD Bristol Bart Ingredients England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SECKLOE 183 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Apr. 2014 Geliefert am 09. Apr. 2014 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Mai 2010 Geliefert am 14. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 2009 Geliefert am 21. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 24. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 24. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Warehouse premises fronting mead street,york road and st lukes rd,bedminster,bristol; AV215197. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 24. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Warehouse premises fronting mead street and york road,bedminster,bristol; BL63264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession pursuant to a debenture dated 5TH october 2001 | Erstellt am 15. Jan. 2002 Geliefert am 05. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by each obligor to the chargees under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Mai 2000 Geliefert am 12. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 10. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. März 1993 Geliefert am 01. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. März 1993 Geliefert am 01. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings on the south east side of york road bedminster bristol avon t/no.AV215197 and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Aug. 1984 Geliefert am 13. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Juli 1980 Geliefert am 08. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land at premises at mead st, york road & st lukes road bristol together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over agreement to lease | Erstellt am 02. Feb. 1979 Geliefert am 07. Feb. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the right title & interest of the company in the property being leasehold land situate at & having frontage on to mead street. York road & st. Lukes road bristol by virtue of an agreement dated 1.1.79 made between the company & the city council of bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 02. Feb. 1979 Geliefert am 07. Feb. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0