ROWITE PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROWITE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00780682 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROWITE PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ROWITE PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street London W1U 1PB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROWITE PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STUDFAIR LIMITED | 12. Nov. 1963 | 12. Nov. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWITE PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROWITE PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROWITE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor | 135403030001 | |||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Sekretär | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Sekretär | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| GILBERT, Nicholas Jay | Sekretär | Woodville 14 Carlton Park Avenue WF8 3HQ Pontefract West Yorkshire | British | 81344240001 | ||||||
| JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Sekretär | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | British | 58693930003 | ||||||
| BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||
| BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||
| BEST, George Laidler | Geschäftsführer | Kiddall Hall Farm York Road Barwick In Elmet LS14 3AE Leeds West Yorkshire | British | 2748600001 | ||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Geschäftsführer | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||
| EVANS, Andreas Frederick | Geschäftsführer | Leathley Grange LS21 2LA Leathley North Yorkshire | United Kingdom | British | 9485290003 | |||||
| EVANS, Dominic Redvers | Geschäftsführer | Pine Lodge 9 Sandmoor Avenue LS17 7DW Leeds West Yorkshire | British | 7095590001 | ||||||
| EVANS, Frederick Redvers | Geschäftsführer | 16 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | British | 4409160001 | ||||||
| EVANS, Roderick Michael | Geschäftsführer | Oakhill House Roundhay Park Lane LS17 8AR Leeds | British | 40175270002 | ||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Geschäftsführer | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||
| HELLIWELL, David Alistair | Geschäftsführer | 8 Farndale Close Spofforth Hill LS22 4XE Wetherby West Yorkshire | England | British | 15578740001 | |||||
| HORSBROUGH, Pauline Elizabeth | Geschäftsführer | 30 The Orchard Wrenthorpe WF2 0LL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 4961270001 | |||||
| MCKENDRICK, Charles | Geschäftsführer | St Anns Main Street LS22 5EB Kirk Deighton North Yorkshire | United Kingdom | British | 173983190001 | |||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | United Kingdom | British | 58693930003 | |||||
| TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | 66424440001 | ||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat ROWITE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 19. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 28. Jan. 2002 Geliefert am 01. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985 | |
Kurze Angaben Blackrod industrial estate bolton t/n-GM801644 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999) | Erstellt am 03. Aug. 1999 Geliefert am 16. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of equitable charge | Erstellt am 08. Mai 1989 Geliefert am 10. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for the banks as defined) under the terms of the loan agreement | |
Kurze Angaben All that l/hold land situate in or near to and partly fronting to petre street, sheffield containing approx 10,470 sq. Yds including all fixtures fittings (other than trade fixtures & fittings) plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1968 Geliefert am 31. Juli 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing 100,000 together with a premium of not less than 1% payable in certain events secured by another charge dt. 24/7/68 | |
Kurze Angaben Policies of assurance on the life of michael white evans & mrs. Helga I. Evans. Each for £50,000. (see doc 23). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Aug. 1965 Geliefert am 12. Aug. 1965 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. from evans amalgamated estates limited | |
Kurze Angaben Land near to and partly fronting petre street, sheffield with all fixtures present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0