HAVELOCK EUROPA PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHAVELOCK EUROPA PLC
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00782546
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HAVELOCK EUROPA PLC?

    • Herstellung von Büromöbeln und Laden­einrichtungen (31010) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich HAVELOCK EUROPA PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAVELOCK EUROPA PLC?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2018
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2019
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HAVELOCK EUROPA PLC?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. Juni 2019
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung04. Juli 2019
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. Juni 2018
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für HAVELOCK EUROPA PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    25 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    21 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    21 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    24 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    25 SeitenAM10

    Vorschlag des Verwalters

    32 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom I2 Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park Mansfield Nottinghamshire NG18 5FB zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 26. Sept. 2018

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    31 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    71 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Hakeem Oluwatosin Yesufu als Direktor am 18. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Donald William Borland als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Bruce Middleton als Sekretär am 06. Apr. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Donald William Borland als Sekretär am 06. Apr. 2018

    1 SeitenTM02

    Eintragung der Belastung 007825460008, erstellt am 02. März 2018

    25 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 007825460007, erstellt am 08. März 2018

    7 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Shaun Allen Ormrod als Direktor am 27. Sept. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Alexander Ritchie als Geschäftsführer am 26. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HAVELOCK EUROPA PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MIDDLETON, Bruce
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Sekretär
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    245012540001
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritish132405720006
    GODDEN, Ian Adam
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United Arab EmiratesBritish223235130001
    ORMROD, Shaun Allen
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish238467880001
    SWEETMAN, Richard John
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritish123777750001
    YESUFU, Hakeem Oluwatosin
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    CanadaNigerian247751120001
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    230319390001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    British65759080002
    GRAY, Alexander Duncan
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    British187835130001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    188761690001
    MACSPORRAN, Graham
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    Sekretär
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    British71376370001
    SMITH, Eric Macdonald
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    Sekretär
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    British76035570001
    WEBSTER, John Strachan
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    British718070001
    ASLET, Peter Michael
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British73615130003
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    Geschäftsführer
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    United KingdomBritish132405720001
    BELL, Simon Leonard Lawrance
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    Geschäftsführer
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    British31486540002
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish66010670002
    BUDDEN, John Michael
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    British22057580001
    BURGESS, Andrew Elliott
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    FranceBritish184199220001
    DERBYSHIRE, Michael Joseph Christian
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish11458180003
    DILLON, Peter Marshall
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    EnglandBritish201559530001
    DUNCAN, Robert Alexander
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    Geschäftsführer
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    British48510002
    FAIRWEATHER, James Henry Whitton
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    Geschäftsführer
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    United KingdomBritish693160001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish65759080002
    GODDEN, Ian Adam
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    Geschäftsführer
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    United KingdomBritish35852610002
    GOURLAY, John Malcolm
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    Geschäftsführer
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    United KingdomBritish574590003
    HAMILL, Ronald Gordon
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish116784830001
    HURCOMB, David Stuart
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    Geschäftsführer
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    United KingdomBritish34516340004
    JEMMETT-PAGE, Shonaid Christina Ross
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    United KingdomBritish133875880001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    ScotlandIrish43853920002
    KENNEDY, William Michael Clifford
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    Geschäftsführer
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    British295080001
    KERR, Alastair Gibson
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish124295480001
    LESSELS, Norman
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Geschäftsführer
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    British681350002
    LONGWORTH, Edward Nicholas
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    Geschäftsführer
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish22057570001
    LOWERY, Richard
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish4842970001

    Hat HAVELOCK EUROPA PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. März 2018
    Geliefert am 09. März 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects on the south side of mitchelston drive, kirkcaldy, registered in the land register of scotland under title number FFE93583.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. März 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 02. März 2018
    Geliefert am 14. März 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All property charged under clause 3.1 of the charge, including:. (1) by way of legal mortgage all estates or interests in the freehold and leasehold property described in the schedule to the charge, together with all present and future buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures), which are at any time on or attached to the property; and. (2) by way of fixed charge: (I) all estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to the company now or at any time after the date of the charge (other than any property charged in terms of (1) above) together with all buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property; (ii) all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it and all present and future licences of the company to enter upon or use land; (iii) the benefit of all other agreements relating to land which the company is or may become party to or otherwise entitled; (iv) all patents, utility models, registered and unregistered trade and service marks, rights in passing off, copyright, registered and unregistered rights in designs and database rights in each case now or in the future held by the company (whether alone or jointly with others) anywhere in the world and including any extensions and renewals of, and any application for such rights; (v) the benefit of all agreements and licences now or in the future entered into or enjoyed by the company relating to the use or exploitation by or on behalf of the company in any part of the world of any such rights as are referred to in (iv) above but owned by others; (vi) all the company's rights now or in the future in relation to trade secrets, confidential information and know how in any part of the world.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Scottish Enterprise
    Transaktionen
    • 14. März 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2010
    Geliefert am 07. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Apr. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant charges with full title guarantee its interest in the deposit account with payment of the liabilities.
    Berechtigte Personen
    • Co-Operative Group (Cws) Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 08. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the south side of bailey grove road eastwood parish t/n NT75472 nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of substitution
    Erstellt am 07. Feb. 1991
    Geliefert am 09. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £360,000 and further advances
    Kurze Angaben
    Land at bailey grove road, eastwood nottinghamshire title no. Nt 75472.
    Berechtigte Personen
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transaktionen
    • 09. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 22. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 1988
    Geliefert am 28. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £400,000 and further advances due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    37, marylebourne lane, london W1.
    Berechtigte Personen
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 03. Dez. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 22. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 21/1/86
    Erstellt am 21. Jan. 1986
    Geliefert am 07. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Block 1 barnsford road inchinnan industrial estate, inchinnan, renfrew PA4 9RE.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HAVELOCK EUROPA PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Juli 2021Ende der Verwaltung
    03. Juli 2018Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Graham Douglas Frost
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praktiker
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0