HAVELOCK EUROPA PLC
Überblick
| Unternehmensname | HAVELOCK EUROPA PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 00782546 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAVELOCK EUROPA PLC?
- Herstellung von Büromöbeln und Ladeneinrichtungen (31010) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich HAVELOCK EUROPA PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAVELOCK EUROPA PLC?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2018 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HAVELOCK EUROPA PLC?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Juni 2019 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Juli 2019 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Juni 2018 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAVELOCK EUROPA PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 25 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 21 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 21 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 22 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 24 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Vorschlag des Verwalters | 32 Seiten | AM03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom I2 Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park Mansfield Nottinghamshire NG18 5FB zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 26. Sept. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 31 Seiten | AM02 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 71 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Hakeem Oluwatosin Yesufu als Direktor am 18. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Donald William Borland als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Bruce Middleton als Sekretär am 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Donald William Borland als Sekretär am 06. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Eintragung der Belastung 007825460008, erstellt am 02. März 2018 | 25 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 007825460007, erstellt am 08. März 2018 | 7 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mr Shaun Allen Ormrod als Direktor am 27. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von David John Alexander Ritchie als Geschäftsführer am 26. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von HAVELOCK EUROPA PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLETON, Bruce | Sekretär | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | 245012540001 | |||||||
| BALFOUR, Hew Edward Ogilvy | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | Scotland | British | 132405720006 | |||||
| GODDEN, Ian Adam | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | United Arab Emirates | British | 223235130001 | |||||
| ORMROD, Shaun Allen | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | England | British | 238467880001 | |||||
| SWEETMAN, Richard John | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | Scotland | British | 123777750001 | |||||
| YESUFU, Hakeem Oluwatosin | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | Canada | Nigerian | 247751120001 | |||||
| BORLAND, Donald William | Sekretär | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | 230319390001 | |||||||
| FINDLAY, Grant Mcdowall | Sekretär | 114 Duchy Road HG1 2HB Harrogate North Yorkshire | British | 65759080002 | ||||||
| GRAY, Alexander Duncan | Sekretär | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire United Kingdom | British | 187835130001 | ||||||
| KENNEDY, Ciaran Anthony | Sekretär | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | 188761690001 | |||||||
| MACSPORRAN, Graham | Sekretär | Rydal 103 Old Greenock Road PA7 5BB Bishopton Renfrewshire | British | 71376370001 | ||||||
| SMITH, Eric Macdonald | Sekretär | 21 Buchanan Drive G61 2EW Glasgow | British | 76035570001 | ||||||
| WEBSTER, John Strachan | Sekretär | 7 Boclair Road Bearsden G61 2AE Glasgow Lanarkshire | British | 718070001 | ||||||
| ASLET, Peter Michael | Geschäftsführer | Burnbrae Horsewood Road PA11 3AT Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 73615130003 | ||||||
| BALFOUR, Hew Edward Ogilvy | Geschäftsführer | Vicars Bridge Blairingone FK14 7NT Dollar The Mains Of Arndean Clackmannanshire | United Kingdom | British | 132405720001 | |||||
| BELL, Simon Leonard Lawrance | Geschäftsführer | 16 Coleherne Mews SW10 9EA London | British | 31486540002 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Geschäftsführer | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BUDDEN, John Michael | Geschäftsführer | 29 Six Hills Road Walton Le Wolds LE12 8JF Loughborough Leicestershire | British | 22057580001 | ||||||
| BURGESS, Andrew Elliott | Geschäftsführer | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire United Kingdom | France | British | 184199220001 | |||||
| DERBYSHIRE, Michael Joseph Christian | Geschäftsführer | The Hill Whitmore ST5 5HU Newcastle Under Lyme Staffordshire | England | British | 11458180003 | |||||
| DILLON, Peter Marshall | Geschäftsführer | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | England | British | 201559530001 | |||||
| DUNCAN, Robert Alexander | Geschäftsführer | 21 Rubislaw Den South AB15 4BD Aberdeen Scotland | British | 48510002 | ||||||
| FAIRWEATHER, James Henry Whitton | Geschäftsführer | The Hoolets Yett Pencaitland EH34 5EY Tranent East Lothian | United Kingdom | British | 693160001 | |||||
| FINDLAY, Grant Mcdowall | Geschäftsführer | 114 Duchy Road HG1 2HB Harrogate North Yorkshire | England | British | 65759080002 | |||||
| GODDEN, Ian Adam | Geschäftsführer | 9 Drax Avenue SW20 0EG London | United Kingdom | British | 35852610002 | |||||
| GOURLAY, John Malcolm | Geschäftsführer | 57 Dick Place EH9 2JA Edinburgh | United Kingdom | British | 574590003 | |||||
| HAMILL, Ronald Gordon | Geschäftsführer | Cavendish House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 116784830001 | |||||
| HURCOMB, David Stuart | Geschäftsführer | Moss Way Hillend Industrial Estate KY11 9JS Dalgety Bay Havelock Europa Plc Fife | United Kingdom | British | 34516340004 | |||||
| JEMMETT-PAGE, Shonaid Christina Ross | Geschäftsführer | Adams Lane Northiam TN31 6JR Rye Spanyards Farm East Sussex | United Kingdom | British | 133875880001 | |||||
| KENNEDY, Ciaran Anthony | Geschäftsführer | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire | Scotland | Irish | 43853920002 | |||||
| KENNEDY, William Michael Clifford | Geschäftsführer | Oak Lodge Inveresk EH21 7TE Musselburgh | British | 295080001 | ||||||
| KERR, Alastair Gibson | Geschäftsführer | Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park NG18 5FB Mansfield I2 Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 124295480001 | |||||
| LESSELS, Norman | Geschäftsführer | 11 Forres Street EH3 6BJ Edinburgh | British | 681350002 | ||||||
| LONGWORTH, Edward Nicholas | Geschäftsführer | 23 Tennent Park Mid Calder EH53 0RF Livingston West Lothian | Scotland | British | 22057570001 | |||||
| LOWERY, Richard | Geschäftsführer | 93 Taverham Road Taverham NR8 6SE Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 4842970001 |
Hat HAVELOCK EUROPA PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. März 2018 Geliefert am 09. März 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects on the south side of mitchelston drive, kirkcaldy, registered in the land register of scotland under title number FFE93583. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. März 2018 Geliefert am 14. März 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All property charged under clause 3.1 of the charge, including:. (1) by way of legal mortgage all estates or interests in the freehold and leasehold property described in the schedule to the charge, together with all present and future buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures), which are at any time on or attached to the property; and. (2) by way of fixed charge: (I) all estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to the company now or at any time after the date of the charge (other than any property charged in terms of (1) above) together with all buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property; (ii) all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it and all present and future licences of the company to enter upon or use land; (iii) the benefit of all other agreements relating to land which the company is or may become party to or otherwise entitled; (iv) all patents, utility models, registered and unregistered trade and service marks, rights in passing off, copyright, registered and unregistered rights in designs and database rights in each case now or in the future held by the company (whether alone or jointly with others) anywhere in the world and including any extensions and renewals of, and any application for such rights; (v) the benefit of all agreements and licences now or in the future entered into or enjoyed by the company relating to the use or exploitation by or on behalf of the company in any part of the world of any such rights as are referred to in (iv) above but owned by others; (vi) all the company's rights now or in the future in relation to trade secrets, confidential information and know how in any part of the world. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 2010 Geliefert am 07. Mai 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 12. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant charges with full title guarantee its interest in the deposit account with payment of the liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 08. Sept. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the south side of bailey grove road eastwood parish t/n NT75472 nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of substitution | Erstellt am 07. Feb. 1991 Geliefert am 09. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £360,000 and further advances | |
Kurze Angaben Land at bailey grove road, eastwood nottinghamshire title no. Nt 75472. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 25. Apr. 1988 Geliefert am 28. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 and further advances due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben 37, marylebourne lane, london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 21/1/86 | Erstellt am 21. Jan. 1986 Geliefert am 07. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Block 1 barnsford road inchinnan industrial estate, inchinnan, renfrew PA4 9RE. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HAVELOCK EUROPA PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0