TRANSTAR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRANSTAR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00785717
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRANSTAR LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich TRANSTAR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Tyne And Wear
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRANSTAR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRANSTAR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Kapitalaufstellung am 24. Juli 2018

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Barry Wilson als Geschäftsführer am 15. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Ejupi als Direktor am 13. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Ms Svetlana Vinokur als Direktor am 13. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Ian Hudson als Direktor am 13. Okt. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Turner als Geschäftsführer am 13. Okt. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Turner als Sekretär am 13. Okt. 2017

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Notification of Victor Products Holdings Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF zum Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ am 17. Juli 2017

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Stephen Paul Turner als Direktor am 25. Aug. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Guy Hetherington als Geschäftsführer am 10. Mai 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 06. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 40,400
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. März 2015

    Kapitalaufstellung am 24. März 2015

    • Kapital: GBP 40,400
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TRANSTAR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EJUPI, Michael
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Geschäftsführer
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican212491340001
    HUDSON, Ian
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Geschäftsführer
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238992200001
    VINOKUR, Svetlana
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Geschäftsführer
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238990610001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CRAIG, Charles Thomas
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699370001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    JORDAN, Margaret Elizabeth
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    Sekretär
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    British47125150001
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Sekretär
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Sekretär
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    British109249450003
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    ALLAN, Gerard
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    Geschäftsführer
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    British44566730001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    GUILE, Peter Richard
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    Geschäftsführer
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    British56096610002
    HANKINS, Michael Freeman
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    Geschäftsführer
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    British12578790001
    HEARNE, John Thomas
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Geschäftsführer
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Usa Citizen70629260001
    HETHERINGTON, Guy
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish109820740003
    JACKSON, Hugh Graham
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699390001
    JORDAN, Keith Stuart
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    Geschäftsführer
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    EnglandBritish139201050001
    MARSH, Anthony Richard
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Irish34189400002
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    PICKERING, James Gordon
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British37974600001
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Geschäftsführer
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Great BritainBritish212939770001
    WILSON, Barry
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Geschäftsführer
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    UsaBritish79691350003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRANSTAR LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Victor Products Holdings Ltd
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    06. Apr. 2016
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House, Cardiff
    Registrierungsnummer00241316
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für TRANSTAR LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    16. März 2017Das Unternehmen hat eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, jedoch wurden nicht alle erforderlichen Angaben zu dieser Person bestätigt.

    Hat TRANSTAR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1994
    Geliefert am 04. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement
    Kurze Angaben
    The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 1994
    Geliefert am 04. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and collateral debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1994
    Geliefert am 08. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Plcas Agent
    Transaktionen
    • 08. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 1964
    Geliefert am 05. Okt. 1964
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc.
    Kurze Angaben
    Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10).
    Berechtigte Personen
    • Martins Bank LTD
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1964Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0