TRANSTAR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRANSTAR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00785717 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRANSTAR LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TRANSTAR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Tyne And Wear England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRANSTAR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRANSTAR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. Juli 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Barry Wilson als Geschäftsführer am 15. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Ejupi als Direktor am 13. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Svetlana Vinokur als Direktor am 13. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Hudson als Direktor am 13. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Turner als Geschäftsführer am 13. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Paul Turner als Sekretär am 13. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Victor Products Holdings Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF zum Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ am 17. Juli 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Paul Turner als Direktor am 25. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Guy Hetherington als Geschäftsführer am 10. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRANSTAR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJUPI, Michael | Geschäftsführer | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 212491340001 | |||||
| HUDSON, Ian | Geschäftsführer | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238992200001 | |||||
| VINOKUR, Svetlana | Geschäftsführer | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238990610001 | |||||
| CLAY, David Nicholas | Sekretär | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CLAY, David Nicholas | Sekretär | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CRAIG, Charles Thomas | Sekretär | 18 Manor House Road Jesmond NE2 2LU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699370001 | ||||||
| DIXON, John | Sekretär | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| JORDAN, Margaret Elizabeth | Sekretär | 63 Harington Green L37 1PN Formby Merseyside | British | 47125150001 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Sekretär | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Sekretär | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Sekretär | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | British | 109249450003 | ||||||
| WARREN, John Emmerson | Sekretär | 1 Gellesfield Chare Whickham NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne | British | 796200001 | ||||||
| ALLAN, Gerard | Geschäftsführer | 2 Glastonbury Close Priors Green DL16 6XP Spennymoor Durham | British | 44566730001 | ||||||
| CONE, Harry Douglas | Geschäftsführer | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||
| DIXON, John | Geschäftsführer | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| GUILE, Peter Richard | Geschäftsführer | 516 Durham Drive Frankfort Il 60423 Usa | British | 56096610002 | ||||||
| HANKINS, Michael Freeman | Geschäftsführer | Flat 2 Guisnes Court Chapel Road Tolleshunt Darcy CM9 8TL Maldon Essex | British | 12578790001 | ||||||
| HEARNE, John Thomas | Geschäftsführer | 16947 Pineview Drive Lockport Illinois 60441 Usa | Usa Citizen | 70629260001 | ||||||
| HETHERINGTON, Guy | Geschäftsführer | New York Way New York Industrial Park NE27 0QF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 109820740003 | |||||
| JACKSON, Hugh Graham | Geschäftsführer | 41 Eastern Way Ponteland NE20 9RD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699390001 | ||||||
| JORDAN, Keith Stuart | Geschäftsführer | 63 Harington Green Formby L37 1PN Liverpool Silverdale | England | British | 139201050001 | |||||
| MARSH, Anthony Richard | Geschäftsführer | 197 Melton Road NG12 4BU Nottingham Nottinghamshire | Irish | 34189400002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Geschäftsführer | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Geschäftsführer | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| PICKERING, James Gordon | Geschäftsführer | Silverhill House 270a Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | British | 37974600001 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Geschäftsführer | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Great Britain | British | 212939770001 | |||||
| WILSON, Barry | Geschäftsführer | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Usa | British | 79691350003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRANSTAR LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Products Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für TRANSTAR LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 16. März 2017 | Das Unternehmen hat eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, jedoch wurden nicht alle erforderlichen Angaben zu dieser Person bestätigt. |
Hat TRANSTAR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Feb. 1994 Geliefert am 04. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement | |
Kurze Angaben The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Feb. 1994 Geliefert am 04. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and collateral debenture | Erstellt am 27. Feb. 1994 Geliefert am 08. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Sept. 1964 Geliefert am 05. Okt. 1964 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys due etc. | |
Kurze Angaben Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0