MW (OLDCO) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MW (OLDCO) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00785935 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MW (OLDCO) LIMITED?
- Herstellung von Farben, Lacken und ähnlichen Beschichtungen, Dichtmitteln und Abdichtmitteln (20301) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich MW (OLDCO) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MW (OLDCO) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MORRELLS WOODFINISHES LIMITED | 06. Juni 1996 | 06. Juni 1996 |
| F.T. MORRELL & CO LIMITED | 24. Dez. 1963 | 24. Dez. 1963 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MW (OLDCO) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MW (OLDCO) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Morrells Woodfinishes Limited as a person with significant control on 30. Juli 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd zum 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX am 30. Juli 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for F T Morrwll & Company Limited as a person with significant control on 27. Feb. 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Johnny W. Green Jr als Direktor am 28. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lesley Philippa Bridgwater als Geschäftsführer am 28. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Stuart O'connor als Geschäftsführer am 28. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 34 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen James Knoop als Geschäftsführer am 15. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MW (OLDCO) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAYTON, Scott Geoffrey Cameron | Geschäftsführer | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | England | British | 64518310003 | |||||
| GREEN JR, Johnny W. | Geschäftsführer | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 269441510001 | |||||
| HOLMAN, Ronnie Gene | Geschäftsführer | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | United States | American | 197026090001 | |||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Sekretär | St. Margarets Street CT1 2TU Canterbury 37 Kent England | 148880010001 | |||||||
| MORRELL, Graham | Sekretär | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Peter Henry | Sekretär | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| PRIOR, Michael John | Sekretär | 9 Gaddum Road Bowdon WA14 3PD Altrincham Cheshire | British | 69677460003 | ||||||
| BOYLE, Alexander Stewart | Geschäftsführer | 5 Forge Close Kirklington NG22 8GZ Newark Nottinghamshire | British | 1106110003 | ||||||
| BRANDON, Robin Nichol | Geschäftsführer | High Field Woodhouse End Road, Gawsworth SK11 9QS Macclesfield Cheshire | British | 66402440001 | ||||||
| BRIDGWATER, Lesley Philippa | Geschäftsführer | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | England | British | 95186950001 | |||||
| CAMPBELL, Anthony Reginald | Geschäftsführer | Manor Farm Barn Little Hadham SG11 2DD Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | 127223200001 | |||||
| CHURCHMAN, Anthony | Geschäftsführer | 13a Eastfield Road SG8 7ED Royston Hertfordshire | British | 48018980001 | ||||||
| FYNN, Jeremy Martin Newnham | Geschäftsführer | 7 Richmond Road Heaton Hersey SK4 3BZ Stockport Cheshire | England | British | 98086980001 | |||||
| KNOOP, Stephen James | Geschäftsführer | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 197026110001 | |||||
| MOORE, Edward Winslow | Geschäftsführer | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 151290070001 | |||||
| MORRELL, Graham | Geschäftsführer | 24 Davenport Park Road SK2 6JS Stockport Cheshire | British | 39067760002 | ||||||
| MORRELL, Joseph Bertram | Geschäftsführer | 15 Chipperfield Road WD4 9JB Kings Langley Herts | England | British | 12082830001 | |||||
| MORRELL, Peter Henry | Geschäftsführer | 5 Tollgate Close Bromham MK43 8QN Bedford Bedfordshire | British | 12082820001 | ||||||
| O'CONNOR, Anthony Stuart | Geschäftsführer | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United Kingdom | British | 71023900003 | |||||
| POOLEY, John | Geschäftsführer | 5 Hampshire Close SK13 8SA Glossop Derbyshire | British | 66402360001 | ||||||
| RICE, Ronald Albert | Geschäftsführer | 1 Hays Lane SE1 2RD London Hays Galleria | United States | American | 115014650001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MW (OLDCO) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrells Woodfinishes Limited | 06. Apr. 2016 | Chamberlain Square Cs B3 3AX Birmingham 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MW (OLDCO) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 04. Aug. 2017 Geliefert am 04. Aug. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2010 Geliefert am 28. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Jan. 2002 Geliefert am 05. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Feb. 2001 Geliefert am 07. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Dez. 2000 Geliefert am 08. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. März 1997 Geliefert am 18. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 1994 Geliefert am 29. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Wood house (formerly alban court) being part of brownfields welwyn garden city t/n HD232337. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Dez. 1993 Geliefert am 14. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Botany mill and land lying north of woodlands drive woodley greater manchester title no GM107143. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1989 Geliefert am 09. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 212 acton lane l/b of brent title no ngl 458972. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 1977 Geliefert am 20. Dez. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 214 acton lane, harlesden, brent, london, nw 10 as comprised in a lease dated 11.11.76. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0