HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00787488 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Bridewell Street BS1 2AA Bristol |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HAMWORTHY COMPRESSOR SYSTEMS LIMITED | 03. Mai 1989 | 03. Mai 1989 |
WILLIAMS & JAMES (ENGINEERS) LIMITED | 12. Juli 1982 | 12. Juli 1982 |
WILJAY LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
WILLIAMS & JAMES CONSTRUCTION EQUIPMENTLIMITED | 09. Jan. 1964 | 09. Jan. 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2010 | 7 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Warr als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Warr als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Chequers Bridge Lower Barton Street Gloucester GL1 4LL am 17. Nov. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a |
Wer sind die Geschäftsführer von HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORNELL, Helen Wright | Geschäftsführer | 205 South 16th Street Quincy Illinois 62301 Usa | United States | American | Vice President | 103330150001 | ||||
GRUMMETT, Mark Elliott | Geschäftsführer | 21 Lowther Drive Garforth LS25 1EW Leeds West Yorkshire | England | United Kingdom | Chartered Accountant | 114840200001 | ||||
ATKINSON, Robert Leslie | Sekretär | 2 St Andrews Way B61 7NR Bromsgrove Worcestershire | British | Director | 102336700001 | |||||
DUNNING, Neil Martin | Sekretär | 36 St Bartholomews Close Cam GL11 5UR Dursley Gloucestershire | British | Company Director | 27700870001 | |||||
RICHARDSON, Geoffrey | Sekretär | 173 Golf Links Road BH22 8BX Ferndown Dorset | British | 3231480001 | ||||||
WARR, Jonathan Peter | Sekretär | 4 Evesham Road GL52 2AB Cheltenham Gloucestershire | British | 73742130003 | ||||||
ATKINSON, Robert Leslie | Geschäftsführer | 2 St Andrews Way B61 7NR Bromsgrove Worcestershire | England | British | Director | 102336700001 | ||||
BARKER, Christopher Paul | Geschäftsführer | 8 Lowe Lane Alveley WV15 6HX Bridgnorth Shropshire | England | British | Company Director | 55161370003 | ||||
BARKER, Christopher Paul | Geschäftsführer | 8 Tutbury Avenue Perton WV6 7UR Wolverhampton West Midlands | British | Director | 55161370001 | |||||
BURKE, Rex | Geschäftsführer | 6 Water Tower Road BH18 8LL Broadstone Dorset | British | Company Director | 30356710001 | |||||
CAHILL, John Anthony | Geschäftsführer | Painswick View Back Edge Lane Edge GL6 6PE Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 10923330002 | ||||
DUNNING, Neil Martin | Geschäftsführer | 36 St Bartholomews Close Cam GL11 5UR Dursley Gloucestershire | British | Company Director | 27700870001 | |||||
FEENEY, Brian Michael | Geschäftsführer | 3 Moorsom Way Aston Fields B60 3SH Bromsgrove Worcestershire | British | Company Director | 44230330001 | |||||
HARFIELD, Walter Maurice | Geschäftsführer | 119 Lynwood Drive BH21 1UU Wimborne Dorset | British | Company Director | 3231500001 | |||||
HARPER, David Joseph | Geschäftsführer | 101 Tewkesbury Road Longford GL2 9BG Gloucester | British | Director | 53263170001 | |||||
HOLMES, Derek | Geschäftsführer | 32a Oxstalls Drive Longlevens GL2 9DB Gloucester Gloucestershire | British | General Manager | 44230390001 | |||||
LEECE, Norman Kay | Geschäftsführer | Grists Orchard High Street, Welford On Avon CV37 8EF Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | Director | 69994620001 | ||||
MARRIOTT, James | Geschäftsführer | Cherry Acre Dingle Road, Leigh WR6 5JX Worcester Worcestershire | British | Manufacturing Director | 65310630001 | |||||
MCCARTHY, Brian | Geschäftsführer | Thumpers Cottage Sheepscombe Painswick BS0 0PH Gloucester Gloucs | British | Company Director | 11811200001 | |||||
NASH, Michael | Geschäftsführer | 136 Woodlands Road Charfield GL12 8LU Wotton Under Edge Gloucestershire | British | Director And General Manager | 44230440001 | |||||
NOAKES, Michael | Geschäftsführer | Arden House 72 Hamilton Road HP13 5BQ High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1534620001 | |||||
PAGLIARA, Tracy D | Geschäftsführer | 2722 Wild Horse Quincy Adams Illinois 62301 Usa | American | General Counsel | 103411450001 | |||||
PAULEY, Christopher James | Geschäftsführer | Alderley Tamesis Drive Kemble GL7 6AD Cirencester Gloucestershire | England | British | Engineer | 76301390001 | ||||
POWELL, John | Geschäftsführer | 5 Hedgerley Becton Green Becton Lane Barton-On-Sea Dorset | British | Company Director | 10923340001 | |||||
RICHARDSON, Geoffrey | Geschäftsführer | 173 Golf Links Road BH22 8BX Ferndown Dorset | United Kingdom | British | Company Director | 3231480001 | ||||
ROTH, Philip Randolph | Geschäftsführer | 2028 Sherwood Lake Estates Quincy Illinois 62301 Usa | American | Cfo Gardner Denver Inc | 93918740001 | |||||
SHULL, John Dennis | Geschäftsführer | 2112 Curved Creek Road Quincy Illinois 62301 United States Of America | American | Vp Of Production | 78485430001 | |||||
STEELE, Jeremy | Geschäftsführer | Breckenridge Drive 62305 Quincy 1528 Illinois Usa | American | Attorney | 133323030001 | |||||
WARR, Jonathan Peter | Geschäftsführer | 4 Evesham Road GL52 2AB Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 73742130003 |
Hat HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 28. Aug. 2002 Geliefert am 02. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Its interest in the account by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 01. Nov. 2001 Geliefert am 06. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 71157573 with the bank and any deposit or account of any other currency description which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A first supplemental deed between amongst others, the company and deutsche bank ag london as security agent (as defined) (supplemental to a composite guarantee and debenture dated 21 december 2000 between amongst others, the company and the security agent) | Erstellt am 13. März 2001 Geliefert am 23. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined), to deutsche bank ag london as senior arranger, securitisation bridge arranger, lng arranger, to deutsche bank ag london and/or all and any under lenders participating in the working capital facility the senior facilities agreement (as defined) and pursuant to various documents and agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite guarantee and debenture between amongst others, the company and deutsche bank ag london as security agent (as defined) | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 02. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined), to deutsche bank ag london as senior arranger, securitisation bridge arranger, lng arranger, to deutsche bank ag london and/or all and any lenders participating in the working capital facility under the senior facilities agreement (as defined) and pursuant to various documents and agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral mortgage | Erstellt am 21. Dez. 1984 Geliefert am 22. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from william & james (properties) limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage on:- 1) all that factory and industrial premises and the land forming the site thereof known as chequers bridge gloucester together with all buildings fixed plant machinery (I) all that factoryard industrial premises and the land forming the site thereof known as no. 2 factory india road gloucester. Together with all buildings and fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Aug. 1984 Geliefert am 30. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H factory no. 2 india road barton st. Gloucester, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Aug. 1984 Geliefert am 30. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H factory & industrial premises & the land formingh the site thereof known as chequers bridge gloucester, and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 25. Okt. 1982 Geliefert am 04. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the companys f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereon fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HAMWORTHY BELLISS & MORCOM LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0