SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00794984 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
- Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row LS1 5AB Leeds England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SUBURBAN & COUNTY HOTELS LIMITED | 06. März 1964 | 06. März 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Part Ground Floor & First Floor Two Parklands Great Park Rubery Rednal Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 30. Juni 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 28 Welbeck Street London W1G 8EW* am 06. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Perry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Treon Anoup als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jaynee Treon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds C/O Pinsent Masons Llp England | United Kingdom | British | Director | 167628190001 | ||||
AMLANI, Pritesh | Sekretär | Birling Road Ryarsh ME19 5LS West Malling Ryarsh Oast House Kent United Kingdom | British | Accountant | 125206220002 | |||||
KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel | Sekretär | Two Parklands Great Park Rubery Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | 160376210001 | |||||||
REBACK, Ivan | Sekretär | 5 Priory Field Drive HA8 9PT Edgware Middlesex | British | 6500010001 | ||||||
AMLANI, Pritesh | Geschäftsführer | Birling Road Ryarsh ME19 5LS West Malling Ryarsh Oast House Kent United Kingdom | England | British | Accountant | 125206220002 | ||||
ANOUP, Treon | Geschäftsführer | Apt 1 7 Cambridge Gate Regents Park NW1 4JX London | United Kingdom | British | Director | 110454990001 | ||||
LEE, Patricia Lesley | Geschäftsführer | Two Parklands Great Park Rubery Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor | United Kingdom | British | Chief Executive | 192233540001 | ||||
PERRY, David William | Geschäftsführer | 28 Welbeck Street London W1G 8EW | England | British | Director | 33988060002 | ||||
REBACK, Bradley Adam | Geschäftsführer | Lindos 45 Dennis Lane HA7 4JU Stanmore Middlesex | England | British | Administrator | 35450230005 | ||||
REBACK, Ivan | Geschäftsführer | 5 Priory Field Drive HA8 9PT Edgware Middlesex | British | Administrative Executive | 6500010001 | |||||
REBACK, Jerome Scott | Geschäftsführer | 99 Marsh Lane NW7 4LE London | British | Management & Consultant | 95949410001 | |||||
SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Two Parklands Great Park Rubery Rednal B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | England | British | Director | 77631340001 | ||||
TREON, Jaynee Sunita | Geschäftsführer | 28 Welbeck Street London W1G 8EW | United Kingdom | British | Director | 42532090004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embrace Realty (Uk) Ltd | 06. Apr. 2016 | Parklands Rednal B45 9PZ Birmingham Two Parklands England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession and charge | Erstellt am 25. März 2011 Geliefert am 06. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2005 Geliefert am 06. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Juli 1999 Geliefert am 14. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 35 cloister gardens edgware midd'x HA8 9QJ. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Bill of sale and deed | Erstellt am 02. Juli 1998 Geliefert am 14. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £990,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All and singular the several chattels and things described in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Mai 1997 Geliefert am 24. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent charge agreement | Erstellt am 01. Apr. 1997 Geliefert am 10. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rents now owing or hereafter to become owing to it in respect of the property k/a 18 19 & 20 sillwood road brighton east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over credit balance | Erstellt am 01. Apr. 1997 Geliefert am 09. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies held to the credit of any account with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1997 Geliefert am 09. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18 & 19 sillwood road, brighton, east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 1997 Geliefert am 09. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 20 sillwood road, brighton, east sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1993 Geliefert am 03. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 9 ranelagh court glendale avenue edgware middx. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1993 Geliefert am 03. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All credit balances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1993 Geliefert am 03. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 37 golders rise hendon london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 26. Juli 1993 Geliefert am 03. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The benefit of the income and rents received from 9 ranelagh court glendale avenue edgware and 37 golders rise london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1993 Geliefert am 03. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All credit balances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 15. Juli 1985 Geliefert am 23. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 21, sillwood road, brighton, title no. Sx 142807 and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 15. Juli 1985 Geliefert am 23. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 20, sillwood road brighton. Title no: esx 18824 and/or proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Dez. 1976 Geliefert am 30. Dez. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 19 sillwood road, brighton surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Dez. 1976 Geliefert am 30. Dez. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18, sillwood road, brighton sussex.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 22. Aug. 1975 Geliefert am 03. Sept. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 15, brunswick square, hove sussex.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SUBURBAN & COUNTY CARE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0