NEELIA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEELIA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00798021
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEELIA LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich NEELIA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    269 Church Street
    FY1 3PB Blackpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEELIA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEELIA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 112/114 Whitegate Drive Blackpool FY3 9XH zum 269 Church Street Blackpool FY1 3PB am 19. Juli 2017

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Juli 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 24. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 15,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Margaret Jameson als Geschäftsführer am 05. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 15,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Margaret Jameson am 29. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    5 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Siobhan Elizabeth Butler als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 15,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 209 Church Street Blackpool Lancashire FY1 3TE* am 29. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von NEELIA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PILKINGTON, Carolyn Anne Pilkington
    31 Levens Drive
    FY6 8EZ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Sekretär
    31 Levens Drive
    FY6 8EZ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British33039620002
    BUTLER, Siobhan Elizabeth
    Elletson Street
    FY6 7AE Poulton-Le-Fylde
    25
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Elletson Street
    FY6 7AE Poulton-Le-Fylde
    25
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishCompany Director185147100001
    SMITH, Martyn Ronald
    342 Carr Road
    UB5 4RW Northolt
    Middlesex
    Sekretär
    342 Carr Road
    UB5 4RW Northolt
    Middlesex
    British35697330001
    JAMESON, Margaret
    Whitegate Drive
    FY3 9XH Blackpool
    112/114
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Whitegate Drive
    FY3 9XH Blackpool
    112/114
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director19210650003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NEELIA LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Siobhan Elizabeth Butler As Exec. Of Mrs M Jameson Deceased
    Elletson Street
    FY6 7AE Poulton-Le-Fylde
    25
    Lancs
    England
    12. Aug. 2016
    Elletson Street
    FY6 7AE Poulton-Le-Fylde
    25
    Lancs
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat NEELIA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 27. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    26 whittaker road, blackpool,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Aug. 2001
    Geliefert am 07. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 cross street blackpool. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Mai 1999
    Geliefert am 12. Mai 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    92 enfield road blackpool lancashire t/n-LA477549.. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Mai 1999
    Geliefert am 12. Mai 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 healey street layton blackpool lancashire t/n-LA449910.. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. März 1997
    Geliefert am 03. Apr. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 healey street layton blackpool lancashire, assigns the related rights (as defined), assigns the goodwill of the business,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Feb. 1975
    Geliefert am 26. Feb. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    67 breck road poulton -le-fylde lancs. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank LTD
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1975Registrierung einer Belastung
    • 20. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEELIA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Juli 2017Beginn der Liquidation
    18. Sept. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Rosalind Mary Hilton
    269 Church Street
    FY1 3PB Blackpool
    Praktiker
    269 Church Street
    FY1 3PB Blackpool

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0