PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED

PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00798370
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2019

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2018

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2017

    14 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 19. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2016

    10 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2015

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2014

    14 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harworth Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* am 19. Juli 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Martin Terence Alan Purvis als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Derek Parkin als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Harworth Secretariat Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Sekretärs für Uk Coal Secretariat Services Limited am 17. Apr. 2013

    1 SeitenCH04

    Beendigung der Bestellung von Simon Taylor als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Simon Gareth Taylor am 12. Dez. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Jan. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Jan. 2013

    • Kapital: GBP 1,010
    SH01

    Ernennung von Colin Frederick Reed als Direktor

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PURVIS, Martin Terence Alan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Sekretär
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    177797480001
    PARKIN, Derek
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Sekretär
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Sekretär
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    British169990550001
    SUMMERSALL, Kevin David
    17 Forest Avenue
    NE12 9AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    17 Forest Avenue
    NE12 9AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British48451880001
    WILSON, Christopher John
    4 The Paddock
    NE43 7PH Stocksfield
    Northumberland
    Sekretär
    4 The Paddock
    NE43 7PH Stocksfield
    Northumberland
    British28089530002
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8223049
    172322000002
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish96416100003
    CALVER, Brian
    4 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HE Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    4 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HE Basingstoke
    Hampshire
    British52475850001
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Geschäftsführer
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritish58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18761260001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Geschäftsführer
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritish95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    British35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Geschäftsführer
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    American101195530002
    TAYLOR, Simon Gareth
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    EnglandBritish177290460002
    WILSON, Keith
    63 St Marys Avenue
    NE26 1TB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    63 St Marys Avenue
    NE26 1TB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British4281530001
    YOUNG, Robert
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    Geschäftsführer
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    EnglandBritish3899280001

    Hat PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 15. Dez. 1993
    Geliefert am 05. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Apr. 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Lazard Brothers & Co Limited
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1991
    Geliefert am 04. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at holywood lane silverdale staffordshire t/n sf 236832 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1991
    Geliefert am 04. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the north west of holywood lane, finney green leycett staffordshire t/n sf 175724 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1991
    Geliefert am 04. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the north of mansfield road, heath derbyshire t/n dy 154932 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 17. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1991
    Geliefert am 04. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings lying to the north of holywood lane finney green, leycett staffordshire t/n sf 164308.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1991
    Geliefert am 04. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bank top farm silverdale staffordshire t/n sf 169360.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 02. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 1989
    Geliefert am 15. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land forming part of the drive apedale, newcastle under lyme, & land N.W. of the drive apedale, newcastle under lyme. The proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 17. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 1989
    Geliefert am 15. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land S.E. of high st. Leycett, newcastle under lyme the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 17. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Apr. 1989
    Geliefert am 28. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 30. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 08. Apr. 1988
    Geliefert am 22. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, nsmplc, hallam all overseas limited, northern strip mining limited, the mining investment corporation limited, any "charging company" (as defined in the security agreement) the ship owning company (as likewise defined) or mincorps shipping & finance limited to barclays bank PLC or any other secured creditor (as likewise defined) under any financing document (as likewise defined)
    Kurze Angaben
    All intellectual property rights etc (for full particulars of all property charged please refer to form M395 and attached continuation sheets thereto ref- M250). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    Deed initial security package
    Erstellt am 22. Apr. 1985
    Geliefert am 09. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to barclays bank PLC as trustee under the terms of the security package as defined in the charge
    Kurze Angaben
    All f/hold and l/hold property with all fixtures thereon all book and other debts floating charge over the see doc for fuller details. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 29. März 1983
    Geliefert am 18. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18/3/83
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement sale agreement dated 18 march 83 (see doc M40 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 29. März 1983
    Geliefert am 14. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 13 mar 83 or a master conditional sale agreement dated 18 mar 83.
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M39 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 29. März 1983
    Geliefert am 14. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed by charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18 mar 83.
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in aconditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M38 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 29. März 1983
    Geliefert am 13. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18.3.83 and a master conditional sale agreement dated 18.3.83
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M37).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 22. März 1983
    Geliefert am 29. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers right title or interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M36).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1983Registrierung einer Belastung
    Security schedule
    Erstellt am 22. März 1983
    Geliefert am 29. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18.3.83 (for full details see doc M35).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited
    Transaktionen
    • 29. März 1983Registrierung einer Belastung
    Deed of charge
    Erstellt am 18. März 1983
    Geliefert am 29. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master conditional sale agreement dated 18 march 1983
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all the buyers right, title & interest present & future. (For full details see doc M33).
    Berechtigte Personen
    • Sumstock Limited.
    Transaktionen
    • 29. März 1983Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 27. Apr. 1981
    Geliefert am 12. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Charge over all bookdebts
    Erstellt am 08. Dez. 1980
    Geliefert am 12. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts & other debts now or hereafter due owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Juli 2013Beginn der Liquidation
    28. Dez. 2020Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0