PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00798370 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2019 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2018 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2017 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 19. Apr. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2016 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 9 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2015 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juli 2014 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Harworth Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* am 19. Juli 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Martin Terence Alan Purvis als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Derek Parkin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harworth Secretariat Services Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Uk Coal Secretariat Services Limited am 17. Apr. 2013 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Taylor als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Gareth Taylor am 12. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Colin Frederick Reed als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | 177797480001 | |||||||||||
| PARKIN, Derek | Geschäftsführer | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square | England | British | 177788390001 | |||||||||
| REED, Colin Frederick | Geschäftsführer | Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire England | England | British | 174641750001 | |||||||||
| COLE, Richard Andrew | Sekretär | Lodge Farm Eakring Road, Wellow NG22 0EG Newark Nottinghamshire | British | 58361870002 | ||||||||||
| GARNESS, Melvin | Sekretär | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | British | 18761260001 | ||||||||||
| RHODES, Jeremy | Sekretär | Harworth Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster South Yorkshire | British | 169990550001 | ||||||||||
| SUMMERSALL, Kevin David | Sekretär | 17 Forest Avenue NE12 9AH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 48451880001 | ||||||||||
| WILSON, Christopher John | Sekretär | 4 The Paddock NE43 7PH Stocksfield Northumberland | British | 28089530002 | ||||||||||
| HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Blyth Road Harworth DN11 8DB Doncaster Harworth Park South Yorkshire United Kingdom |
| 172322000002 | ||||||||||
| BROCKSOM, David Graham | Geschäftsführer | 7 York Road HG1 2QA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 96416100003 | |||||||||
| CALVER, Brian | Geschäftsführer | 4 Park Lane Old Basing RG24 7HE Basingstoke Hampshire | British | 52475850001 | ||||||||||
| COLE, Richard Andrew | Geschäftsführer | Eakring Road Wellow NG22 0EG Newark Lodge Farm | England | British | 58361870002 | |||||||||
| GARNESS, Melvin | Geschäftsführer | 11 The Drive DN22 6SD Retford Nottinghamshire | United Kingdom | British | 18761260001 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Simon | Geschäftsführer | Orchard House Marton Cum Grafton YO51 9QY York | United Kingdom | British | 95211330002 | |||||||||
| MAWE, Christopher | Geschäftsführer | 5 Back Lane Whixley YO26 8BG York North Yorkshire | British | 99084660001 | ||||||||||
| MCPHIE, Gordon Allister | Geschäftsführer | Wigley Green Farmhouse S42 7JJ Old Brampton Derbyshire | British | 35904020001 | ||||||||||
| RHODES, Jeremy | Geschäftsführer | Harworth Blyth Road DN11 8DB Harworth Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 170032420001 | |||||||||
| SPINDLER, Garold Ralph | Geschäftsführer | Manor House Westhaugh Tumbling Hill Carleton WF8 2RP Pontefract | American | 101195530002 | ||||||||||
| TAYLOR, Simon Gareth | Geschäftsführer | The Bent Curbar S32 3YD Hope Valley Robinhill England England | England | British | 177290460002 | |||||||||
| WILSON, Keith | Geschäftsführer | 63 St Marys Avenue NE26 1TB Whitley Bay Tyne & Wear | British | 4281530001 | ||||||||||
| YOUNG, Robert | Geschäftsführer | Townhead Farm Iveston DH8 7TD Consett Co Durham | England | British | 3899280001 |
Hat PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 15. Dez. 1993 Geliefert am 05. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Apr. 1992 Geliefert am 13. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 04. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at holywood lane silverdale staffordshire t/n sf 236832 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 04. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the north west of holywood lane, finney green leycett staffordshire t/n sf 175724 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 04. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the north of mansfield road, heath derbyshire t/n dy 154932 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 04. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the north of holywood lane finney green, leycett staffordshire t/n sf 164308. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Feb. 1991 Geliefert am 04. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Bank top farm silverdale staffordshire t/n sf 169360. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Apr. 1989 Geliefert am 15. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land forming part of the drive apedale, newcastle under lyme, & land N.W. of the drive apedale, newcastle under lyme. The proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Apr. 1989 Geliefert am 15. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land S.E. of high st. Leycett, newcastle under lyme the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Apr. 1989 Geliefert am 28. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 08. Apr. 1988 Geliefert am 22. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, nsmplc, hallam all overseas limited, northern strip mining limited, the mining investment corporation limited, any "charging company" (as defined in the security agreement) the ship owning company (as likewise defined) or mincorps shipping & finance limited to barclays bank PLC or any other secured creditor (as likewise defined) under any financing document (as likewise defined) | |
Kurze Angaben All intellectual property rights etc (for full particulars of all property charged please refer to form M395 and attached continuation sheets thereto ref- M250). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed initial security package | Erstellt am 22. Apr. 1985 Geliefert am 09. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to barclays bank PLC as trustee under the terms of the security package as defined in the charge | |
Kurze Angaben All f/hold and l/hold property with all fixtures thereon all book and other debts floating charge over the see doc for fuller details. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 29. März 1983 Geliefert am 18. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18/3/83 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement sale agreement dated 18 march 83 (see doc M40 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 29. März 1983 Geliefert am 14. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 13 mar 83 or a master conditional sale agreement dated 18 mar 83. | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M39 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 29. März 1983 Geliefert am 14. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed by charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18 mar 83. | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in aconditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M38 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 29. März 1983 Geliefert am 13. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18.3.83 and a master conditional sale agreement dated 18.3.83 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M37). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 22. März 1983 Geliefert am 29. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers right title or interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M36). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security schedule | Erstellt am 22. März 1983 Geliefert am 29. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18.3.83 (for full details see doc M35). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 18. März 1983 Geliefert am 29. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master conditional sale agreement dated 18 march 1983 | |
Kurze Angaben First fixed charge over all the buyers right, title & interest present & future. (For full details see doc M33). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 27. Apr. 1981 Geliefert am 12. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over all bookdebts | Erstellt am 08. Dez. 1980 Geliefert am 12. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts & other debts now or hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0