CALIGEN FOAM LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CALIGEN FOAM LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00800311 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CALIGEN FOAM LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CALIGEN FOAM LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALIGEN FOAM LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CALIGEN FOAM LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2020 bis 28. Feb. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian William Robb am 16. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Nov. 2020
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Paul Roby als Direktor am 12. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Mohammed Omar Shafi Khan als Direktor am 12. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Christopher Skinner als Geschäftsführer am 06. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ian William Robb als Direktor am 07. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Cheele als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Oldham Road Middleton Manchester M24 2DB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CALIGEN FOAM LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED | Sekretär | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England |
| 110906090002 | ||||||||||
O'RIORDAN, Daniel Joseph | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | Company Director | 176979900001 | ||||||||
ROBB, Ian William | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | Director | 263073080001 | ||||||||
ROBY, Stuart Paul | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | Company Director | 257247520001 | ||||||||
SHAFI KHAN, Mohammed Omar | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | Company Director | 239506860001 | ||||||||
STIRZAKER, Mark Robert | Sekretär | Lower Dunishbooth House Lane Head OL12 6BH Rochdale Lancashire | British | 78366970002 | ||||||||||
TEAGUE, Alan Richard | Sekretär | 26 Orchard Street Stockton Heath WA4 6LH Warrington | British | 290650004 | ||||||||||
BUCHANAN, Peter Michael Richmond | Geschäftsführer | 2 Oriel Road S10 3TF Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 125843960001 | ||||||||
BURLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | Accountant | 122799590001 | ||||||||
BUTTERWORTH, Laurence Harry | Geschäftsführer | 1 Oaklands Park Grasscroft OL4 4JY Oldham | British | Company Director | 8941280001 | |||||||||
CAMPBELL, David Arthur | Geschäftsführer | 19 Tandle Hill Road Royton OL2 5UU Oldham | British | Director | 49442610001 | |||||||||
CHEELE, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | England | British | Company Director | 127959950003 | ||||||||
CHEELE, Jonathan Mark | Geschäftsführer | 3 Harestones Wynyard Woods TS22 5QT Billingham Cleveland | United Kingdom | British | Manager | 127959950001 | ||||||||
DAVID, Peter John | Geschäftsführer | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | Managing Director | 69738470002 | ||||||||
DAVID, Peter John | Geschäftsführer | Kingswood House Accommodation Road KT16 0EQ Longcross Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 69738470002 | ||||||||
EATON, Francis Joseph | Geschäftsführer | Croichley Fold Hawkshaw BL8 4JE Bury Lancashire | British | Director | 915070001 | |||||||||
FRANCE, Anthony | Geschäftsführer | 123 Chatterton Road BL0 0PQ Ramsbottom Lancashire | England | British | Company Director | 122164090001 | ||||||||
FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Belvedere Lodge 18 Highbury Road Wimbledon Village SW19 7PR London | England | British | Accountant | 105961550001 | ||||||||
HANSFORD, Frederick Albert | Geschäftsführer | 48 Hesketh Drive PR9 7JG Southport Merseyside | British | Director | 8360980001 | |||||||||
HARRIS, Howard Elliott | Geschäftsführer | 15 Queen's Gate Gardens SW7 5LY London | British | Company Director | 93378750001 | |||||||||
HINE, David Randolph | Geschäftsführer | Yarwood Farm Bollington Lane SK10 4TB Nether Alderley Cheshire | English | Director | 6965090001 | |||||||||
LUCAS, Barry James | Geschäftsführer | 29 Thanet Lee Close Cliviger BB10 4TX Burnley Lancashire | British | Director | 37515710001 | |||||||||
MANSFIELD, Reginald Bardsley | Geschäftsführer | 3 Oaks Avenue Hayfield SK4 4EU Stockport Cheshire | British | Company Director | 8585390001 | |||||||||
MAUNDRELL, Graham Lloyd | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | Hr Manager | 56093930002 | ||||||||
MELTHAM, John David | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | Accountant | 74570910001 | ||||||||
MENENDEZ, Joseph Henry | Geschäftsführer | c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester N/A England | Usa | American | Company Director | 127225800003 | ||||||||
OLIVER, John Lancaster | Geschäftsführer | The Croft House 4 Hawkshill Close KT10 8JY Esher Surrey | United Kingdom | United Kingdom | Partner | 116941050001 | ||||||||
SKINNER, John Christopher | Geschäftsführer | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | Managing Director | 200170600001 | ||||||||
STEVENSON, Barry Alan | Geschäftsführer | 208 Brooklands Road M33 3PH Sale Cheshire | British | Director | 37554790001 | |||||||||
TAYLOR, Steven Michael | Geschäftsführer | 13 Victoria Avenue Didsbury M20 2GY Manchester | British | Director | 68164080001 | |||||||||
VAN BEIJEREN, Hubertus Josephus Johannes | Geschäftsführer | Dijkstraat 161 3906 Dd Veenevdaal Netherlands | Netherlands | Director | 74583150003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CALIGEN FOAM LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita (Group) Unlimited | 06. Apr. 2016 | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CALIGEN FOAM LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 23. Apr. 2009 Geliefert am 01. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2007 Geliefert am 21. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Aug. 2005 Geliefert am 12. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation | Erstellt am 04. Dez. 1978 Geliefert am 20. Dez. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Increasing the monies advanced under the terms of a charge dated 12/3/74 from 4,600,000 dutch guilders to all monies due or to become due. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property all fixtures, fixed plant and machinery and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0