RECORD SHOP 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRECORD SHOP 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00805812
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RECORD SHOP 1 LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HMV UK LIMITED01. Jan. 198901. Jan. 1989
    HMV LIMITED23. Nov. 198823. Nov. 1988
    HMV LIMITED14. März 198614. März 1986

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Apr. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Juni 2015

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 26. Juni 2015

    22 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Mai 2015

    25 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Nov. 2014

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Mai 2014

    23 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Nov. 2013

    36 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Juli 2013

    32 Seiten2.24B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed hmv uk LIMITED\certificate issued on 30/04/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name30. Apr. 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 29. Apr. 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    67 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Trevor Moore als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Wer sind die Geschäftsführer von RECORD SHOP 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CARNEY, Shaun David
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish112335150001
    HODGKINSON, Mark Philip
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish163797530001
    NEIL, Michael Hugh
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish129915950001
    TAYLOR, Neil Alan
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish113208460002
    WEST, Stephen
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish113208550002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Sekretär
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Sekretär
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Sekretär
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Sekretär
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British40470020001
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Sekretär
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Sekretär
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Geschäftsführer
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARKE, Andrew James
    22 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    22 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish64152230003
    COATES, David Peter
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    Stamford Lodge
    37 Priestlands Park Road
    DA15 7HJ Sidcup
    Kent
    British56148130001
    DONNELLY, Liam Dermot
    4 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish76875440002
    DOUGLAS, Simon Terence
    16 Cannon Street
    AL3 5JS St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    16 Cannon Street
    AL3 5JS St. Albans
    Hertfordshire
    British77003930001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GALLANT, Stephen John
    12 Ibis Lane
    Hartington Road Chiswick
    W4 3UP London
    Geschäftsführer
    12 Ibis Lane
    Hartington Road Chiswick
    W4 3UP London
    UkBritish160305600001
    HILL, Peter Martin
    Flat 6
    30 Cleveland Square
    W2 6DD London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    30 Cleveland Square
    W2 6DD London
    British79516940001
    KING, Martyn Paul
    16 Poplar Road
    B91 3AB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    16 Poplar Road
    B91 3AB Solihull
    West Midlands
    British48606220003
    KNOTT, Stephen John
    Old Coppice
    Gallowstree Road Peppard Common
    RG9 5HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Old Coppice
    Gallowstree Road Peppard Common
    RG9 5HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish90862330001
    KNOTT, Stephen John
    Old Coppice
    Gallowstree Road Peppard Common
    RG9 5HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Old Coppice
    Gallowstree Road Peppard Common
    RG9 5HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish90862330001
    LASK, Gideon
    32 Thorne Street
    SW13 0PR London
    Geschäftsführer
    32 Thorne Street
    SW13 0PR London
    United KingdomBritish117073930001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MCLAUGHLIN, Brian Finbar
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pangbourne Lodge
    Tidmarsh Road
    RG8 7AZ Pangbourne
    Berkshire
    United KingdomBritish9950470002
    MOORE, Trevor Philip
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish113047410001
    NAPLETON, Steven David
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish92726690001
    NEWLYN, Nigel Charles
    6 Deborah Crescent
    HA4 7TB Ruislip
    Middlesex
    Geschäftsführer
    6 Deborah Crescent
    HA4 7TB Ruislip
    Middlesex
    British27683360001
    PECK, Simon
    Lancaster House
    61 Lancaster Road
    AL1 4ER St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Lancaster House
    61 Lancaster Road
    AL1 4ER St. Albans
    Hertfordshire
    British93035650002
    PRYDE, David John
    11 Saint Albans Avenue
    Chiswick
    W4 5LL London
    Geschäftsführer
    11 Saint Albans Avenue
    Chiswick
    W4 5LL London
    British75876390001
    RIMMER, David Christopher
    15 Sandhurst Road
    Yateley
    GU17 7UU Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Sandhurst Road
    Yateley
    GU17 7UU Camberley
    Surrey
    British27683370001
    ROCHE, David Lawrence
    36 Eaton Drive
    Kingston Hill
    KT2 7QT Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    36 Eaton Drive
    Kingston Hill
    KT2 7QT Kingston Upon Thames
    Surrey
    British42817500001

    Hat RECORD SHOP 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The interest in the deposit balance with payment of the liabilities.
    Berechtigte Personen
    • Dominion Corporate Trustees Limited and Dominion Trust Limited
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Trading terms contract
    Erstellt am 30. Sept. 2011
    Geliefert am 07. Okt. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The supplier retains full title to and ownership of the goods unless and until they are sold to the end consumer see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Universal Pictures (UK) Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Juni 2011
    Geliefert am 01. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 01. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h & l/h property, rights in respect of the contracts or policies of insurance and all rights in respect of know-how, patent, trade amrk, service mark, design, business name, topographical or similar right. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 2003
    Geliefert am 21. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all the assets and the whole of the undertaking present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 11TH june 2002
    Erstellt am 24. Mai 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    129 and 130 princes street edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Facility Agent and Trustee in Terms of the Creditagreement Dated 24TH April 2002
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 11 june 2002 and
    Erstellt am 24. Mai 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects and others registered under t/no gla 47497. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Facility Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 11 june 2002 and
    Erstellt am 24. Mai 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects and others registered under title no gla 47489. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Facility Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the secured parties (the "facility agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28TH march 1998
    Erstellt am 13. Aug. 2001
    Geliefert am 14. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as defined in the debenture) on the terms and conditions set out in the senior facility agreement dated 25TH february 1998 (the "security agent") under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in resepct of any further advances made thereunder
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a 360 to 366 oxford street and 17/20 stratford place london W1; l/h properties k/a unit 4 norwich union buildings high street sheffield t/nos: NGL787974 SYK427442 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 1999
    Geliefert am 02. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the fixed charge over the other principal property being real property owned by the company being l/h premises k/a unit 1 51/53 east street derby t/no;-DY261720 l/h premises units 1/54 metro centre swalwell tyne & wear and l/h premises units 68A and 68S metro centre swalwell tyne & wear together with equitable interest in the other principal property and all assignments of property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag(As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 02. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1998
    Geliefert am 23. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may now or in the future have to the chargee as trustee for the beneficiaries ("the security agent") or any of the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture)including any liability in respect of further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum now or hereafter owing,due or incurred by the company
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a 22/36 church street liverpool and l/h premises k/a 21 gentleman's walk norwich (the other principal property) and all rights and claims which the company may have in relation to the other principal property see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of deposit
    Erstellt am 14. Sept. 1998
    Geliefert am 23. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Kurze Angaben
    Deposit £62,250.00.
    Berechtigte Personen
    • Pearl Assurance (Unit Funds) Limited
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 25TH august 1998 and
    Erstellt am 14. Juni 1998
    Geliefert am 03. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the debenture dated 28TH march 1998 as amended varied supplemented or novated from time to time
    Kurze Angaben
    All and whole interest in a lease of 154-160 sauchiehall street glasgow t/no GLA71206.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation as Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to the debenture of even date
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 08. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior facility agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    (I) l/hold premises known as units 51/53 and 251/253 merseyway,stockport; t/no gm 619834 and (ii) l/hold premises known as units F11 and F12,the bentall centre,kingston-u-thames;all rights and claims and benefit of agreements for sale/lease; all covenants,undertakings or obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 08. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 04. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 03. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND june 1998
    Erstellt am 19. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Kurze Angaben
    Lease of unit 5 argyle street glasgow GLA47497.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND june 1998
    Erstellt am 19. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Kurze Angaben
    Lease of unit 6 argyle street glasgow GLA47489.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Erstellt am 14. Mai 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the senior facility agreement
    Kurze Angaben
    L/H 12/15 lion yard cambridge t/n CB19466 48-50 foregate street chester t/n CH346077 32 new george street plymouth T.n DN123346 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation(Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Trustee for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RECORD SHOP 1 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Jan. 2013Beginn der Verwaltung
    26. Juni 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0