M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00808976 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hilton Road Cobbs Wood Industrial Estate TN23 1EW Ashford Kent |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| M J ALLEN(ELECTRICAL CONTRACTORS)LIMITED | 15. Juni 1964 | 15. Juni 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Robert Ealham als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan Charles Gibson am 14. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gary Robert Ealham am 14. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy John Allen am 14. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Allen am 14. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alan Charles Gibson am 13. Juli 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Alan Charles | Sekretär | Hilton Road Cobbs Wood Industrial Estate TN23 1EW Ashford Kent | British | 43724570002 | ||||||
| ALLEN, Michael John | Geschäftsführer | Bellropes Biddenden Road TN27 8QG Smarden Ashford Kent | England | British | 27989920001 | |||||
| ALLEN, Timothy John | Geschäftsführer | Rose Cottage Southenay Lane, Sellindge TN25 6EW Ashford Kent | England | British | 159002510001 | |||||
| GIBSON, Alan Charles | Geschäftsführer | 7 The Maltings Walmer CT14 7AR Deal Kent | England | British | 43724570002 | |||||
| GORDON, Graham | Sekretär | Flat 104 The Metropole CT20 2LU Folkestone Kent | British | 117843740001 | ||||||
| CROMBIE, Thomas Ronald | Geschäftsführer | 78 Downs Road CT19 5PT Folkestone Kent | British | 12492360001 | ||||||
| EALHAM, Gary Robert | Geschäftsführer | 17 Highfield Road Willesborough TN24 0JJ Ashford Kent | England | English | 16475180001 | |||||
| GORDON, Graham | Geschäftsführer | Flat 104 The Metropole CT20 2LU Folkestone Kent | England | British | 117843740001 | |||||
| RANDALL, Michael George | Geschäftsführer | 14 Sevington Park Loose ME15 9SB Maidstone Kent | England | British | 28098770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M J Allen Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Hilton Road TN23 1EW Ashford M J Allen Holdings Ltd England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat M.J. ALLEN (PATTERN MAKERS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture deed | Erstellt am 17. Mai 2002 Geliefert am 20. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. März 1997 Geliefert am 17. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 18. Dez. 1991 Geliefert am 04. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £110733.50 | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all sums payable under the insurance please see doc M1223C for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juni 1989 Geliefert am 28. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben And heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 16. Juli 1985 Geliefert am 29. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 19. Sept. 1984 Geliefert am 01. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 11. Sept. 1979 Geliefert am 02. Okt. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies uhdue or to become due from the company and/or all or and of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property, undertaking and deeds charged by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 09. Dez. 1974 Geliefert am 24. Dez. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any of the other existing companies and/or M.J. allen (charters) LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property, undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Jan. 1974 Geliefert am 16. Jan. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and or/all any of the four other companies named therein to barclays bank LTD | |
Kurze Angaben By way of fixed and floating charge undertaking goodwill all property and assets present and future including uncalled capital together with all buildings fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery (for full details see doc 24 please). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0