MULGATE INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMULGATE INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00809506
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 5,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    16 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2011

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Auth dirs re sect 175(5)a of ca 2006 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von MULGATE INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Sekretär
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Geschäftsführer
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat MULGATE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Sixth supplemental trust deed
    Erstellt am 14. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a sinfin lane industrial estate, sinfin, derbyshire t/no's DY361077 and DY22024 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land on north west side of sinfin lane,derby; DY22024 with all buildings and fixtures thereon.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 06. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold land known as dollis hill research station t/no. MX122172 and the freehold land known as land and buildings on the west side of stoneferry road, kingston upon hull t/no. HS125192. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 11. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evan of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto (as defined)
    Kurze Angaben
    Dollis hill estate brook road dollis hill london t/n-MX122172 together with all buildings and erections or fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Erstellt am 03. Aug. 1999
    Geliefert am 16. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 04. Dez. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Juni 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Jan. 1999
    Geliefert am 08. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Dollis hill research station l/b brent-MX122172. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release & substitution
    Erstellt am 18. Sept. 1997
    Geliefert am 22. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Land at 9 grape lane york t/n NYK191013 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 20. Sept. 1996
    Geliefert am 24. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025.
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a 34 to 42 even and 42A and 42B washway road and oaklands house oaklands drive sale t/n GM478629.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 08. Sept. 1995
    Geliefert am 25. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and the memorandum of deposit
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 9 grape lane york t/n NYK30372 with all fixtures fittings plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 08. Sept. 1995
    Geliefert am 25. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee under the loan agreement (as defined) and this memorandum of deposit
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n NYK56126 with title absolute with all fixtures and fittings.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental trust deed
    Erstellt am 04. Nov. 1993
    Geliefert am 19. Nov. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £100,000,000 (being the aggregate principal amount of the original stock and the new stock) 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due under the terms of the principal trust deed and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Various properties as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 22. Jan. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 7 colliergate york t/n nyk 56126 and land and buildings k/a 9 grape lane york t/n nyk 30372.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC as Security Trustee for Itself the Banks the Agents and Arranger
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Juli 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 08. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Various properties as specified in form 395 ref M655C.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 28. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 27. Juli 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Aug. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 17. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Erstellt am 07. Jan. 1992
    Geliefert am 09. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 7TH december 1988 and this charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on north west side of sinfin lane, derby comprising the whole of the property registered at h m land registry under t/n dy 30545. land lying to the north of wordsworth avenue derby comprising the whole of the property registered at H.M. land registry under t/ndy 215291.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memerandum of equitable & charge
    Erstellt am 04. März 1991
    Geliefert am 09. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under the loan ageement and under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings on the east side of walney road barrow in furness, cumbria title no:- cu 6053.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memerandum of equitable charge
    Erstellt am 27. Okt. 1989
    Geliefert am 08. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 7/12/88
    Kurze Angaben
    F/H land situate to the north east of low lane horsforth title no wyk 269133 including all fixtures fitings (other than trade fixtures & fittings plant & machinery (see from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memarandum of equitable charge
    Erstellt am 27. Okt. 1989
    Geliefert am 30. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the banks (as defined therein) under a loan agreement dated 7/12/88 and amended by a first supplemented agreement dated 23/1/89 under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land situate to the south of feltham rd, ashford, surrey title no:- sy 479887 (including all fixtures fittings other than trade fixtures fittings & including the benifit of all agreements (see from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 13. Dez. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of equitable charge
    Erstellt am 17. Feb. 1989
    Geliefert am 20. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Kurze Angaben
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinery (see from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Nov. 1991Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. Jan. 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 21. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memerandum & equitable charge
    Erstellt am 07. Dez. 1988
    Geliefert am 13. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 7/12/88 and the charge
    Kurze Angaben
    All the property listed on the schedule including fixtures fittings plant and machinary (see from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Security Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 11. Mai 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 07. Apr. 1988
    Geliefert am 08. Apr. 1988
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Original stock created by a trust deed dated 20 september 1985
    Kurze Angaben
    Roman house, sittingbourne, kent title no 4568386.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 27. Juli 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Trust deed
    Erstellt am 20. Sept. 1985
    Geliefert am 08. Okt. 1985
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 12,000,000 11% first mortgate debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and other moneys payable pursuant to the trust deed or intended to be secured thereby
    Kurze Angaben
    Premises adjoining brook road, dollis hill, willesdon NW2 l/b of brent title no mx 122172 premises at feltham road, ashford, surrey title no. Sy 479887 premises at low lane, horsforth, leeds. Title no. Wyk 269133 (see doc M41 for full details) together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings, fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 02. Okt. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Juli 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Juli 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Juli 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 30. Jan. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Apr. 1973
    Geliefert am 17. Apr. 1973
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    64 and 66 vicar lane no 6 and 8 sydney st no 5 & 7 hanwood st leeds.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank LTD
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1973Registrierung einer Belastung
    • 18. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Apr. 1973
    Geliefert am 17. Jan. 1973
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from evans of leeds LTD to yorkshire bank LTD. On any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land containing 97 sq. Yards or thereabouts in vicar lane leeds no 60 and 62 vicar lane leeds.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank LTD
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1973Registrierung einer Belastung
    • 18. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0