FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00814782 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DUNCAN POCOCK (INSURANCE BROKERS) LIMITED | 02. Juli 1990 | 02. Juli 1990 |
| DONALD DUNCAN (INSURANCE BROKERS) LIMITED | 06. Aug. 1964 | 06. Aug. 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 11. Sept. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Egan als Geschäftsführer am 14. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Stephen Mugge als Direktor am 11. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Steven Hodges als Geschäftsführer am 17. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Jennifer Owens als Sekretär am 25. Nov. 2013 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | 222043460001 | |||||||
| MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 162920630005 | |||||
| ROSS, David Christopher | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| BROWN, Jeffrey Marson | Sekretär | 4 Johnsdale RH8 0BW Oxted Surrey | British | 6406870001 | ||||||
| CLARK, Darryl | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | 152541050001 | |||||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | 161869930001 | |||||||
| CRATON, Timothy Charles | Sekretär | Downings Quarry Close RH8 9HG Oxted Surrey | British | 76055420004 | ||||||
| HOMEWOOD, Stephen Kenneth | Sekretär | 92 Canterbury Avenue DA15 9AS Sidcup Kent | British | 17243950001 | ||||||
| HUNTER, Andrew Stewart | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | 156624940001 | |||||||
| MARTIN, Kim Ian | Sekretär | Little Dene 13 Manor Rise ME14 4DB Maidstone Kent | British | 11165290001 | ||||||
| OWENS, Jennifer | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | 183300440001 | |||||||
| CHAPPELL, Michael John | Geschäftsführer | 18 St Johns Meadow Blindley Heath RH7 6JU Lingfield Surrey | British | 7661880001 | ||||||
| CLARKE, Benjamin David | Geschäftsführer | 46 Crossways Avenue RH19 1HZ East Grinstead West Sussex | British | 74723790001 | ||||||
| CULLUM, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | England | British | 59873490009 | |||||
| DESSENT, Peter John | Geschäftsführer | Roundhouse Cottage Woodhurst Lane RH8 9ED Oxted Surrey | England | British | 7661890004 | |||||
| EGAN, Scott | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | England | British | 170703910001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| HOMER, Andrew Charles | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | England | British | 13483140003 | |||||
| HOMEWOOD, Stephen Kenneth | Geschäftsführer | 92 Canterbury Avenue DA15 9AS Sidcup Kent | British | 17243950001 | ||||||
| IBBS, John Albert | Geschäftsführer | 89 Phoenix Drive Wateringbury ME18 5RS Maidstone Kent | United Kingdom | British | 123795360001 | |||||
| LOFTUS, Joseph | Geschäftsführer | 28 Willow Ridge Turners Hill RH10 4PN Crawley West Sussex | British | 19601860001 | ||||||
| MACIVER, Kenneth | Geschäftsführer | 12 Norfolk Heights Church Road TN1 1JD Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 70920700003 | |||||
| MARSHGREEN, John William | Geschäftsführer | Marringdean Manor Marringdean Road RH14 9HF Billingshurst West Sussex | British | 6406900004 | ||||||
| MARTIN, Kim Ian | Geschäftsführer | Little Dene 13 Manor Rise ME14 4DB Maidstone Kent | England | British | 11165290001 | |||||
| PALMER, Julian Claude | Geschäftsführer | 12 Cyprus Road Hatch Warren RG22 4UY Basingstoke Hampshire | British | 51776320001 | ||||||
| PALMER-MINNIS, Nigel Anthony | Geschäftsführer | 138 Limpsfield Road CR2 9EF Sanderstead Surrey | British | 51776240004 | ||||||
| PHILIP, Timothy Duncan | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent | United Kingdom | British | 99066410001 | |||||
| STEPHENS, Michael John | Geschäftsführer | 8 Pine Walk CR3 5EN Caterham Surrey | British | 19601880001 | ||||||
| WHITE, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 15 Firlands Langshott RH6 9BL Horley Surrey | British | 74723740001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Pocock (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 18. Okt. 2002 Geliefert am 24. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £16,159.77. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 2002 Geliefert am 17. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank and the hedging bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juli 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,517,000 together with interest due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a the l/h premises 110 station road east oxted surrey, 145STATION road east oxted surrey, sheldon house station road east oxted surrey (as demised in the leases). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 27. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 26 october 1998 (as defined) | |
Kurze Angaben The interest in the deposit of £12,043.75. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 19. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Twelve thousand forty three pounds and seventy five pence (£12,043.75). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. Apr. 1999 Geliefert am 30. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 436 limpsfield road warlingham. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 23. Feb. 1996 Geliefert am 29. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 23. Feb. 1996 Geliefert am 29. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over deposit | Erstellt am 01. Nov. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums standing to the credit of account number 7510903 of the company with lloyds bank PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over deposit | Erstellt am 01. Nov. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums standing to the credit of account number 7510903 with lloyds bank PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 07. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of deposit account moneys | Erstellt am 28. Feb. 1991 Geliefert am 07. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit of £150,000 with lloyds banks PLC, elephant and castle branch, london, SE1 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 1984 Geliefert am 20. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises situate at 106 grove vale, east dulwich, london SE22 T.N. ln 80024 l/h property situate at 67 nottingham road, nottingham london SE9 4QZ T.N. sgl 269463 fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat FOLGATE RISK SOLUTIONS (OXTED) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0