SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00830572 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
- Sonstige Nebentätigkeiten im Versicherungs- und Altersvorsorgewesen (66290) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LINCOLN ASSURANCE LIMITED | 01. Jan. 1997 | 01. Jan. 1997 |
| LAURENTIAN LIFE PLC | 23. Jan. 1989 | 23. Jan. 1989 |
| IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED | 01. Juli 1987 | 01. Juli 1987 |
| TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 03. Juli 1986 | 03. Juli 1986 |
| IMPERIAL TRIDENT LIFE LIMITED | 01. Juni 1986 | 01. Juni 1986 |
| TRIDENT LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 09. Dez. 1964 | 09. Dez. 1964 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 18 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. Aug. 2017 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT zum 4th Floor Cumberland House 15-17 Cumberland Place Southampton SO15 2BG am 05. Dez. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Matrix House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4DZ zum Imperial House 18-21 Kings Park Road Southampton Hampshire SO15 2AT am 16. Aug. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 01. Aug. 2016
| 6 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 27 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 28 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 29 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Neville Dean Kent als Direktor am 03. Mai 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Donald Alexander Stewart als Geschäftsführer am 03. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Mark Coombes als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOBBS, Margaret Fleur | Sekretär | Limmeridge Colwall Green WR13 6DX Malvern Worcestershire | British | 74951990001 | ||||||
| GARNER, Katherine Angela | Geschäftsführer | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton 4th Floor Cumberland House | United Kingdom | British | 149006830001 | |||||
| KENT, Neville Dean | Geschäftsführer | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton 4th Floor Cumberland House | United Kingdom | British | 44753820002 | |||||
| DAWBARN, Mark Lupton | Sekretär | Brambletye High Street OX7 6AW Ascott Under Wychwood Chipping Norton | British | 3920290005 | ||||||
| GARNELL, Mary Elizabeth Jane | Sekretär | Cyprus House High Street Chalford GL6 8DR Stroud Gloucestershire | British | 6101450001 | ||||||
| HOBBS, Margaret Fleur | Sekretär | Limmeridge Colwall Green WR13 6DX Malvern Worcestershire | British | 74951990001 | ||||||
| WILSON, Malcolm George William | Sekretär | Kings Ride House HP18 9RP Brill Buckinghamshire | British | 72397640001 | ||||||
| ALDER, Bernard Henry | Geschäftsführer | Inglewood Elkstone GL53 9PB Cheltenham Gloucestershire | British | 57055620002 | ||||||
| ANSTEE, Eric Edward | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 76479900001 | |||||
| ASKARI, Hasan | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 41444890001 | |||||
| BERRYMAN, Malcolm Leonard | Geschäftsführer | Kiln Lane Otterbourne SO21 2EN Winchester Otterbourne Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 114331270002 | |||||
| BOSCIA, Jon Andrew | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | Usa | American | 153770970001 | |||||
| BOSCIA, Jon Andrew | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | Usa | American | 153770970001 | |||||
| BROWN, Bernard George | Geschäftsführer | Long Hop House 52 New Road KT10 9NU Esher Surrey | British | 8598360002 | ||||||
| COOMBES, Stephen Mark | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | England | British | 101470950001 | |||||
| DAVIDSON, Anthony Beverley | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 61933730002 | |||||
| DAVIES, David Wyndham | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | England | British | 10487980001 | |||||
| DAWBARN, Mark Lupton | Geschäftsführer | Brambletye High Street OX7 6AW Ascott Under Wychwood Chipping Norton | British | 3920290005 | ||||||
| FRANKLIN, Christina | Geschäftsführer | Front Street Nympsfield GL10 3TY Stroud Four Wells Cottage Gloucestershire Uk | United Kingdom | British | 85575860002 | |||||
| FULLER, Janet Christine | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British Canadian | 146458800001 | |||||
| GARNER, Katherine Angela | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 149006830001 | |||||
| GREEN, Michael Anthony | Geschäftsführer | 23 Wolsey Road KT10 8NT Esher Surrey | British | 51805960002 | ||||||
| HOLSTEIN, Phillip | Geschäftsführer | 8 Wells Rise NW8 7LH London | American | 69671760001 | ||||||
| KENT, Neville Dean | Geschäftsführer | Great Washbourne House Great Washbourne GL20 7AR Tewkesbury Gloucester | United Kingdom | British | 44753820002 | |||||
| MARSH, Richard William, Lord Marsh Of Mannington | Geschäftsführer | 25 Moreton Terrace SW1V 2NS London | British | 12558860001 | ||||||
| MCMATH, Michael Edward | Geschäftsführer | 1 Hibberts Way SL9 8UD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 40388880001 | ||||||
| MOSS, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 144991950001 | |||||
| NICK, Jeffrey Joseph | Geschäftsführer | 6 Frognal Close Hampstead NW3 6YB London | American | 58634090002 | ||||||
| PARKINSON, Stephen David | Geschäftsführer | Chestnut Coppice Furzefield Chase, Dormans Park RH19 2LU East Grinstead West Sussex | England | British | 89576180001 | |||||
| REED, Gregory Edward | Geschäftsführer | Appleshaw Cheltenham Road, Pitchcombe GL6 6LZ Stroud Gloucestershire | American | 54583630004 | ||||||
| ROGERS, Derek John | Geschäftsführer | Woodlands High Street Wanborough SN4 0AE Swindon Wiltshire | British | 51815620001 | ||||||
| ROWE, Benjamin Nathan | Geschäftsführer | 214 Hendon Way NW4 3NE London | United Kingdom | British | 5648270001 | |||||
| SHAHEEN, Gabriel L | Geschäftsführer | Hollywood Vicarage Lane SL9 8AS Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 50946320003 | ||||||
| SHARKEY, Robert John | Geschäftsführer | Basing View RG21 4DZ Basingstoke Matrix House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 134441240001 | |||||
| SHERRIFF, John Baird | Geschäftsführer | 6 Bracken Avenue SW12 8BH London | British | 6203290001 |
Hat SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge deed | Erstellt am 20. Juni 2002 Geliefert am 08. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 43 old queen st,london; t/no 65657; f/hold property known as 10-14 bank st,carlisle,cumbria; t/no cu 171028 with all buildings trade and other fixtures,fixed plant and machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 09. März 2000 Geliefert am 22. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 23/01/89 and the deed | |
Kurze Angaben By way of charge £13,860 and the amount standing to the credit of the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 27. Okt. 1993 Geliefert am 28. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 149 belgrave road leicester t/n LT172956ASSIGNS the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. Juli 1993 Geliefert am 14. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 36A chapel lane formby together with all buildings and fixtures thereon assings goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Apr. 1992 Geliefert am 15. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 3 wood street, earl shilton, leicester title no. LT180811 together with all buildings and fixturesthereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Dez. 1991 Geliefert am 10. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 5, 2 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT222433 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Dez. 1991 Geliefert am 10. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 4, 1 station road, earl shilton, leicestershire title no. LT239939 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1991 Geliefert am 21. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 st johns square glastonbury somerset title no st 66850 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1991 Geliefert am 15. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H unit 14 the talina centre bagleys lane fulham london SW6 assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Jan. 1991 Geliefert am 08. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 7/8 the brittox devizes wiltshire together with all buildings & fixtures thereonassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Apr. 1988 Geliefert am 28. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 15,15A, & 16 silver street, eastern house bradford on avon wiltshire together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 11. Nov. 1987 Geliefert am 30. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 21 & 22 (formerly units 5B & 5C) westfield road, kineton road estate southam, stratford on avon, warwickshire assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Juli 1985 Geliefert am 12. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings at bristol road south llongbridge birmingham west midlands title no wm 233089 and or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Mai 1985 Geliefert am 29. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land or buildings halton station road, sutton weaver chester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge pursuant to on order of court dated 4/7/85 | Erstellt am 20. Feb. 1985 Geliefert am 09. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012, ln 53974, 413310, 413291. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1984 Erworben am 18. März 1985 Geliefert am 15. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,606.40 | |
Kurze Angaben All that property situate at and known as 50 nottingham road, stapleford nottingham title no nt 51870. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Okt. 1984 Geliefert am 26. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 69 high street bagshot surrey title no sy 453934. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Sept. 1984 Geliefert am 01. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10 station road, earl shilton leicester title no lt 74505. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Sept. 1984 Geliefert am 01. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cross enderby leicester including all fixtures & fittings (other than trade fixtures a fittings) plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 19. März 1984 Geliefert am 20. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from john beynon david william hill and stephen martin welsh to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 42 market place dewsbury kirkless west yorkshire title no wk 130185. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Juli 1983 Erworben am 30. Okt. 1984 Geliefert am 01. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £80,000 | |
Kurze Angaben 48/48A high street marlow bucks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Mai 1983 Geliefert am 19. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from davivd william hill, john beynon and/or midland bank trust company not exceeding ukp 75,000 | |
Kurze Angaben 42 market pl dewsbury w yorks tn wyk 130186. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 25. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £122,971.38 due or to become due from midland bank trust company limited to the chargees | |
Kurze Angaben 77 parkway london NW1 title nos 421616 ln 53012 ln 53974 413310 431291. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Okt. 1982 Geliefert am 15. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from midland bank trust company limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 77 parkway london NW1 title nos 421616, ln 53012 ln 53974, 413310 & 413291. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Aug. 1982 Erworben am 09. Apr. 1984 Geliefert am 07. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £22750.28 | |
Kurze Angaben 20 nelson street bradford title no wyk 114486. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SLFC ASSURANCE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0