CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00839154 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLAVERHAM LIMITED | 09. Juni 1999 | 09. Juni 1999 |
| F H LIMITED | 26. Jan. 1998 | 26. Jan. 1998 |
| FAIREY HYDRAULICS LIMITED | 26. Feb. 1965 | 26. Feb. 1965 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution insolvency:res re statement of account | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Claverham Bristol BS49 4NF zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Evan Francis Smith als Direktor am 15. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christian Bruno Jean Idczak-Descat als Direktor am 15. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andreas Schell als Geschäftsführer am 15. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Rajinder Singh Kullar als Direktor am 15. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Andrew Fowler als Geschäftsführer am 15. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Robert Charles Buxton als Geschäftsführer am 06. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Juni 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 28. Mai 2013
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 28. Mai 2013
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Andreas Schell als Direktor am 19. Feb. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN COE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Stone Buildings Lincolns Inn WC2A 3TH London 2 United Kingdom |
| 139112420001 | ||||||||||
| IDCZAK, Christian Bruno Jean | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | French | 129935690010 | |||||||||
| KULLAR, Rajinder Singh | Geschäftsführer | Poyle Road SL3 0HB Colnbrook Mathisen Way Berkshire England | Untied Kingdom | British | 74999290008 | |||||||||
| SMITH, Evan Francis | Geschäftsführer | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | American,Irish | 73647690004 | |||||||||
| BOORMAN, Colin | Sekretär | The Arches Westhay BA6 9TR Glastonbury Somerset | British | 27456790001 | ||||||||||
| BUTTERWORTH, Philip | Sekretär | 4 Glebe Close Long Ashton BS41 9DB Bristol | British | 75347870001 | ||||||||||
| DORE, Geoffrey William | Sekretär | 16a Druid Stoke Avenue Stoke Bishop BS9 1DD Bristol | British | 77864400001 | ||||||||||
| HUTCHINGS, Mark Alexander | Sekretär | Rose Cottage 2 Royal Farm Mews Royal Lane CW6 9XE Eaton Cheshire | British | 57349970001 | ||||||||||
| MCCARTHY, Richard Thomas | Sekretär | Strathearn Drive Brentry BS10 6TS Bristol 85 | American | 128751220001 | ||||||||||
| PACKHAM, Robert William | Sekretär | 21 Salisbury Road Redland BS6 7AN Bristol Craigthorne | British | 137923770001 | ||||||||||
| ANTHONY, Michael John | Geschäftsführer | Warners Close Pilcorn Street BS28 4AP Wedmore Somerset | British | 41660490001 | ||||||||||
| ANTHONY, Michael John | Geschäftsführer | Warners Close Pilcorn Street BS28 4AP Wedmore Somerset | British | 41660490001 | ||||||||||
| BEAN, Alan David | Geschäftsführer | Lancet House Ashwick Oak Hill Radstock BA3 5BB Bath North East Somerset | British | 66656720002 | ||||||||||
| BOORMAN, Colin | Geschäftsführer | The Arches Westhay BA6 9TR Glastonbury Somerset | British | 27456790001 | ||||||||||
| BROWN, Trevor Ambrose | Geschäftsführer | Romana 12 Knole Park Almondsbury BS12 4BS Bristol | British | 37438480002 | ||||||||||
| BUTTERWORTH, Philip | Geschäftsführer | 4 Glebe Close Long Ashton BS41 9DB Bristol | England | British | 75347870001 | |||||||||
| BUXTON, Roger Robert Charles | Geschäftsführer | 20 Kings Croft Long Ashton BS41 9EE Bristol | United Kingdom | British | 78210300002 | |||||||||
| CALDERBANK, Martin Nicholas | Geschäftsführer | 2 Burleigh Place SW15 6ES London | British | 66234230001 | ||||||||||
| DORE, Geoffrey William | Geschäftsführer | 16a Druid Stoke Avenue Stoke Bishop BS9 1DD Bristol | England | British | 77864400001 | |||||||||
| FOWLER, Peter Andrew | Geschäftsführer | 259 Stowey Road BS49 4QX Yatton North Somerset | United Kingdom | British | 241110830001 | |||||||||
| FROST, Simon Richard | Geschäftsführer | Combedown Farm Combe Florey TA4 3JD Taunton Somerset | British | 87291390001 | ||||||||||
| GARDINER, Michael Charles | Geschäftsführer | Claverham Bristol BS49 4NF | United Kingdom | Uk | 172073870001 | |||||||||
| GINGRICH, James Lee | Geschäftsführer | 12214 Sleepy Hollow Road Roscoe Illinois 61073 Usa | Us Citizen | 77865030001 | ||||||||||
| GUTTRIDGE, Nicholas James | Geschäftsführer | The Manor BS39 5AN Hinton Blewett North Somerset | England | British | 27456810004 | |||||||||
| HUTCHINGS, Mark Alexander | Geschäftsführer | Rose Cottage 2 Royal Farm Mews Royal Lane CW6 9XE Eaton Cheshire | British | 57349970001 | ||||||||||
| KINGSBURY, Derek John | Geschäftsführer | Sparnal Stitch Trewint Lane Rock PL27 6LU Wadebridge Cornwall | British | 18255570002 | ||||||||||
| LEDUC, Robert Francis | Geschäftsführer | 42 Kaya Lane Mansfield Center Connecticut 06250 Usa | Usa | Us Citizen | 103629560001 | |||||||||
| MCDONALD, Mark | Geschäftsführer | 10 The Fielders Worle BS22 7HH Weston Super Mare Avon | British | 103638740001 | ||||||||||
| MITCHELL, Henry George | Geschäftsführer | 1 Bruddel Grove SN3 1PW Swindon Wiltshire | British | 8307520002 | ||||||||||
| PAGE, Stephen John | Geschäftsführer | Orchard Hse Titlands Lane, Wookey Hole BA5 1BD Wells Somerset | British | 92689630001 | ||||||||||
| POULTER, John William | Geschäftsführer | 28 Sydney Road TW9 1UB Richmond Surrey | British | 4333730002 | ||||||||||
| SAXE, Thomas William | Geschäftsführer | Hamilton Road Ms 1-2-Bc21 Windsor Locks One Ct 06096-1010 Usa | Usa | American | 155680740001 | |||||||||
| SCHELL, Andreas | Geschäftsführer | Harrison Avenue 61125 Rockford 4747 Illinois Usa | Usa | German | 176150890001 | |||||||||
| SYMONDS, Philip Gerard | Geschäftsführer | Boundary Cottage Fen Pond Road Ightham TN15 9JF Sevenoaks Kent | England | British | 38887120002 | |||||||||
| TAYLOR, David John | Geschäftsführer | Fairlie Lawn Sidcot Lane BS25 1LP Winscombe Avon | British | 27456820001 |
Hat CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Letter of offset (executed by the company formerly known as fairey hydraulics limited) | Erstellt am 23. Jan. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the "principal debtors" (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and all other charges and expenses subject at all times to the provisions of the senior finance documents (as defined in the facilities agreement dated 23 january 1998 (as defined)) | |
Kurze Angaben All moneys at the date of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 23. Jan. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as fairey hydraulics limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Juni 1987 Geliefert am 16. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and all moneys due from fairey group limited on any account whatsoever toe security pacific ever of maince (U.K.) limited | |
Kurze Angaben F/Hold pieces or parcels of land situate at claversham in the county of avon with factory buildings messuagge outbuildings and premises erected thereon and k/as court de wyck tannery claverham 9.938 acres or the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures see doc M33/17JUL/lh.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Jan. 1987 Geliefert am 04. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from fairey group limited to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the loan agreement dated 31/12/86 and for securing all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and/or all or any of the other companies named therein to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the aforesaid loan agreement dated 31/12/1986 | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all those freehold pieces of land or parcels of land situate at claverham in the county of avon with the factory building message outbuildings and premises known as court-de-wyck, tannery, claverham. A specific equitable charge over all freehold and lease hold property fixed and floating charge over all debts and other sums, benefits of all securities, stocks, shares goodwill, uncalled capital. Patents, trademarks, copyrights undertaking and assets (see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 16. Jan. 1987 Geliefert am 27. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over f/h land with factory building messuage and buildings and premises erected thereon and known as court-de-wyer tarmery, claveham, having on area of 9.938 acres or thereabouts and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0