CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCLAVERHAM HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00839154
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CLAVERHAM LIMITED09. Juni 199909. Juni 1999
    F H LIMITED26. Jan. 199826. Jan. 1998
    FAIREY HYDRAULICS LIMITED26. Feb. 196526. Feb. 1965

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Insolvenzbeschluss

    Resolution insolvency:res re statement of account
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Claverham Limited Bishops Road Claverham BS49 4NF geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Claverham Bristol BS49 4NF zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 05. Sept. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Ernennung von Mr Evan Francis Smith als Direktor am 15. Juli 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christian Bruno Jean Idczak-Descat als Direktor am 15. Juli 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andreas Schell als Geschäftsführer am 15. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Rajinder Singh Kullar als Direktor am 15. Juli 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Andrew Fowler als Geschäftsführer am 15. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1.000004
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Roger Robert Charles Buxton als Geschäftsführer am 06. Apr. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2012

    13 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 28. Juni 2013

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 25/06/2013
    RES13

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 28. Mai 2013

    • Kapital: GBP 500,002
    4 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 28. Mai 2013

    • Kapital: GBP 500,001.00
    4 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von Andreas Schell als Direktor am 19. Feb. 2013

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDWIN COE SECRETARIES LIMITED
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Sekretär
    Stone Buildings
    Lincolns Inn
    WC2A 3TH London
    2
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerOC326366
    139112420001
    IDCZAK, Christian Bruno Jean
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandFrench129935690010
    KULLAR, Rajinder Singh
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Poyle Road
    SL3 0HB Colnbrook
    Mathisen Way
    Berkshire
    England
    Untied KingdomBritish74999290008
    SMITH, Evan Francis
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Geschäftsführer
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican,Irish73647690004
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Sekretär
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BUTTERWORTH, Philip
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    Sekretär
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    British75347870001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Sekretär
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    British77864400001
    HUTCHINGS, Mark Alexander
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    Sekretär
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    British57349970001
    MCCARTHY, Richard Thomas
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    Sekretär
    Strathearn Drive
    Brentry
    BS10 6TS Bristol
    85
    American128751220001
    PACKHAM, Robert William
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    Sekretär
    21 Salisbury Road
    Redland
    BS6 7AN Bristol
    Craigthorne
    British137923770001
    ANTHONY, Michael John
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    British41660490001
    ANTHONY, Michael John
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Warners Close Pilcorn Street
    BS28 4AP Wedmore
    Somerset
    British41660490001
    BEAN, Alan David
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    Geschäftsführer
    Lancet House Ashwick
    Oak Hill Radstock
    BA3 5BB Bath
    North East Somerset
    British66656720002
    BOORMAN, Colin
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Arches
    Westhay
    BA6 9TR Glastonbury
    Somerset
    British27456790001
    BROWN, Trevor Ambrose
    Romana 12 Knole Park
    Almondsbury
    BS12 4BS Bristol
    Geschäftsführer
    Romana 12 Knole Park
    Almondsbury
    BS12 4BS Bristol
    British37438480002
    BUTTERWORTH, Philip
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    Geschäftsführer
    4 Glebe Close
    Long Ashton
    BS41 9DB Bristol
    EnglandBritish75347870001
    BUXTON, Roger Robert Charles
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    Geschäftsführer
    20 Kings Croft
    Long Ashton
    BS41 9EE Bristol
    United KingdomBritish78210300002
    CALDERBANK, Martin Nicholas
    2 Burleigh Place
    SW15 6ES London
    Geschäftsführer
    2 Burleigh Place
    SW15 6ES London
    British66234230001
    DORE, Geoffrey William
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    Geschäftsführer
    16a Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DD Bristol
    EnglandBritish77864400001
    FOWLER, Peter Andrew
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    Geschäftsführer
    259 Stowey Road
    BS49 4QX Yatton
    North Somerset
    United KingdomBritish241110830001
    FROST, Simon Richard
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Combedown Farm
    Combe Florey
    TA4 3JD Taunton
    Somerset
    British87291390001
    GARDINER, Michael Charles
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    Geschäftsführer
    Claverham
    Bristol
    BS49 4NF
    United KingdomUk172073870001
    GINGRICH, James Lee
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Geschäftsführer
    12214 Sleepy Hollow Road
    Roscoe
    Illinois 61073
    Usa
    Us Citizen77865030001
    GUTTRIDGE, Nicholas James
    The Manor
    BS39 5AN Hinton Blewett
    North Somerset
    Geschäftsführer
    The Manor
    BS39 5AN Hinton Blewett
    North Somerset
    EnglandBritish27456810004
    HUTCHINGS, Mark Alexander
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rose Cottage 2 Royal Farm Mews
    Royal Lane
    CW6 9XE Eaton
    Cheshire
    British57349970001
    KINGSBURY, Derek John
    Sparnal Stitch
    Trewint Lane Rock
    PL27 6LU Wadebridge
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Sparnal Stitch
    Trewint Lane Rock
    PL27 6LU Wadebridge
    Cornwall
    British18255570002
    LEDUC, Robert Francis
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    Geschäftsführer
    42 Kaya Lane
    Mansfield Center
    Connecticut 06250
    Usa
    UsaUs Citizen103629560001
    MCDONALD, Mark
    10 The Fielders
    Worle
    BS22 7HH Weston Super Mare
    Avon
    Geschäftsführer
    10 The Fielders
    Worle
    BS22 7HH Weston Super Mare
    Avon
    British103638740001
    MITCHELL, Henry George
    1 Bruddel Grove
    SN3 1PW Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    1 Bruddel Grove
    SN3 1PW Swindon
    Wiltshire
    British8307520002
    PAGE, Stephen John
    Orchard Hse
    Titlands Lane, Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    Orchard Hse
    Titlands Lane, Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    British92689630001
    POULTER, John William
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Sydney Road
    TW9 1UB Richmond
    Surrey
    British4333730002
    SAXE, Thomas William
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    Geschäftsführer
    Hamilton Road
    Ms 1-2-Bc21
    Windsor Locks
    One
    Ct 06096-1010
    Usa
    UsaAmerican155680740001
    SCHELL, Andreas
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    Geschäftsführer
    Harrison Avenue
    61125 Rockford
    4747
    Illinois
    Usa
    UsaGerman176150890001
    SYMONDS, Philip Gerard
    Boundary Cottage
    Fen Pond Road Ightham
    TN15 9JF Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Boundary Cottage
    Fen Pond Road Ightham
    TN15 9JF Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish38887120002
    TAYLOR, David John
    Fairlie Lawn
    Sidcot Lane
    BS25 1LP Winscombe
    Avon
    Geschäftsführer
    Fairlie Lawn
    Sidcot Lane
    BS25 1LP Winscombe
    Avon
    British27456820001

    Hat CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Letter of offset (executed by the company formerly known as fairey hydraulics limited)
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 06. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the "principal debtors" (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and all other charges and expenses subject at all times to the provisions of the senior finance documents (as defined in the facilities agreement dated 23 january 1998 (as defined))
    Kurze Angaben
    All moneys at the date of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books by way of fixed and specific charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Jan. 1998
    Geliefert am 06. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as fairey hydraulics limited) and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Juni 1987
    Geliefert am 16. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and all moneys due from fairey group limited on any account whatsoever toe security pacific ever of maince (U.K.) limited
    Kurze Angaben
    F/Hold pieces or parcels of land situate at claversham in the county of avon with factory buildings messuagge outbuildings and premises erected thereon and k/as court de wyck tannery claverham 9.938 acres or the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures see doc M33/17JUL/lh.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific Ever of Maince (U.K.) Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Jan. 1987
    Geliefert am 04. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from fairey group limited to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the loan agreement dated 31/12/86 and for securing all moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and/or all or any of the other companies named therein to samuel montagu & co limited as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the aforesaid loan agreement dated 31/12/1986
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all those freehold pieces of land or parcels of land situate at claverham in the county of avon with the factory building message outbuildings and premises known as court-de-wyck, tannery, claverham. A specific equitable charge over all freehold and lease hold property fixed and floating charge over all debts and other sums, benefits of all securities, stocks, shares goodwill, uncalled capital. Patents, trademarks, copyrights undertaking and assets (see doc for full details).
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for Itself and All Banks Which May from Time to Time Be Joined as Parties to the Loan Agreement.
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Jan. 1987
    Geliefert am 27. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over f/h land with factory building messuage and buildings and premises erected thereon and known as court-de-wyer tarmery, claveham, having on area of 9.938 acres or thereabouts and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1987Registrierung einer Belastung

    Hat CLAVERHAM HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Aug. 2014Beginn der Liquidation
    05. Juni 2015Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0