MISYS B & S DIVISION LIMITED

MISYS B & S DIVISION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMISYS B & S DIVISION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00844354
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    APRICOT COMPUTERS P.L.C.13. Aug. 198513. Aug. 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013

    11 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Elizabeth Mary Collins als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Joanna Hawkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Sanjay Patel als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 16. Aug. 2012

    16 SeitenRP04

    Ernennung von Thomas Edward Timothy Homer als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Joanna Marageret Hawkes als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bijal Patel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr Bijal Mahendra Patel als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Farrimond als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    27. Aug. 2013A second filed AR01 was registered on 27/08/2013

    Ernennung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Sarah Brain als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    Sekretär
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    146626180001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Sekretär
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Sekretär
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Sekretär
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Sekretär
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Sekretär
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Sekretär
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Sekretär
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer07036299
    170448780001
    BURY, Lindsay Claude Neils
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish67103750001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FOSTER, Roger Keith
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    Geschäftsführer
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    EnglandBritish2551760001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HARFORD, John Timothy, Sir
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    British15932250001
    HART, Michael John
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    Geschäftsführer
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    British118672700001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JONES, Miah Gwynfor
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    Geschäftsführer
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    British66161140001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MACPHERSON, Philip Strone Stewart
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish42864500001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Geschäftsführer
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NEWTON, Richard Paul
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    British2551790001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PEDDER, Clive Thomas
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritish71955460001
    SOLOMONS, Anthony Nathan
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    Geschäftsführer
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    United KingdomBritish8116770001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001

    Hat MISYS B & S DIVISION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Erstellt am 17. Sept. 2003
    Geliefert am 01. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 24. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Erstellt am 29. Juli 2003
    Geliefert am 12. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Erstellt am 23. Okt. 2002
    Geliefert am 13. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 25. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge
    Erstellt am 22. Juni 1993
    Geliefert am 01. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility letter, the guarantee and/or the counter indemnity
    Kurze Angaben
    All the company's rights to receive payment for or in respect of the new ordinary shares as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trade marks mortgage
    Erstellt am 05. März 1990
    Geliefert am 20. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All trade marks of the company. (See form M525C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1990Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 1990
    Geliefert am 20. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 1990Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 1986
    Geliefert am 16. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 11 february 1986.
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as and being ground & upper basement floors 18/19 pall mall london SW1.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    Standard security
    Erstellt am 17. Feb. 1986
    Geliefert am 20. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1.513 hectares at rutherford rd, southfield industrial estate, glenrothes, fife with factory buildings thereon k/a 29 rutherford road, glenrothes. 0.340 hectare comprising car park at rutherford road, southfield industrial estate.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 21. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The research and development centre at vincent drive, edgbaston, b'ham. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 05. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and of present and future copyright by way of security charge
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 14. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The charged rights is defined to mean all the copyrights, rights in the nature of copyright and other rights, causes of action and interests assured assigned or charged. For fuller details see doc M78.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Charge over goodwill trademarks & tradenames.
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 14. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any accounts whatsoever.
    Kurze Angaben
    "The charged rights is defined to mean all trademarks, applications for trademarks, tradenames and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. For fuller details see DOCM77.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment and of patents by way of security charge
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 14. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The charged rights is defined to mean all patents patent applications and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. See doc M76 for fuller details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks.
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment and of registered designs by way of security charge
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 14. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The charged rights is defined to mean all registered designs applications for registered designs and other rights causes of action and interests assured assigned or charged. For further details see doc M75.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    • 05. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Feb. 1986
    Geliefert am 12. Feb. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures see doc M74 for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juli 1985
    Geliefert am 23. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Act house, 111 hagley road, edgbaston, birmingham, w mids t/n wk 50832.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Letter of charge
    Erstellt am 10. Juni 1985
    Geliefert am 26. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank (whether in the name of the company or not) on the company's behalf with some 3RD party for the deposit of moneys of the company.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 1985
    Geliefert am 18. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Elizabeth house 17 westbourne road, and the lodge 17A, westbourne road, edgbaston, w midlands. T/n WM28511 wm 312841.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 1983
    Geliefert am 05. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H 111 hagley road edgbaston birmingham title no wk 50832.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1980Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juli 1983
    Geliefert am 19. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property situate at & known as shenstone house, halesowen west midlands.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1980
    Geliefert am 06. Okt. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat MISYS B & S DIVISION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Juli 2014Aufgelöst am
    19. Dez. 2013Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praktiker
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0