MISYS B & S DIVISION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MISYS B & S DIVISION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00844354 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MISYS B & S DIVISION LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| APRICOT COMPUTERS P.L.C. | 13. Aug. 1985 | 13. Aug. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Mary Collins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanna Hawkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Sanjay Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 16. Aug. 2012 | 16 Seiten | RP04 | ||||||||||
Ernennung von Thomas Edward Timothy Homer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Joanna Marageret Hawkes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bijal Patel als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Bijal Mahendra Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Farrimond als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sarah Brain als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MISYS B & S DIVISION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| BRAIN, Sarah Elizabeth Highton | Sekretär | Portwood Cottage The Street Warninglid RH17 5SZ Haywards Heath No 1 West Sussex England | 146626180001 | |||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||||||
| TAYLOR, David | Sekretär | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| WILSON, Kevin Michael | Sekretär | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 10 | Other | 138835080001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Kingdom Street Paddington W2 6BL London One United Kingdom |
| 170448780001 | ||||||||||
| BURY, Lindsay Claude Neils | Geschäftsführer | Millichope Park Munslow SY7 9HA Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | 67103750001 | |||||||||
| EVANS, Robert Owen | Geschäftsführer | Field House Ashow CV8 2LE Kenilworth Warwickshire | British | 57011000002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue WD17 4NU Watford 51 Hertfordshire England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| FOSTER, Roger Keith | Geschäftsführer | Seisdon Hall Seisdon WV5 7ER South Staffordshire | England | British | 2551760001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HARFORD, John Timothy, Sir | Geschäftsführer | South House South Littleton WR11 5TJ Evesham Worcestershire | British | 15932250001 | ||||||||||
| HART, Michael John | Geschäftsführer | The White House Lower Illey B62 0HJ West Midlands | British | 118672700001 | ||||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| JONES, Miah Gwynfor | Geschäftsführer | Box Farm Reynoldston SA3 1AA Swansea | British | 66161140001 | ||||||||||
| LOMAX, John Kevin | Geschäftsführer | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||||||
| MACPHERSON, Philip Strone Stewart | Geschäftsführer | Armsworth Park House Armsworth Park SO24 9RH Old Alresford Hampshire | United Kingdom | British | 42864500001 | |||||||||
| MARTIN, Ivan | Geschäftsführer | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | 123233030001 | |||||||||
| MOLONEY, Barry William | Geschäftsführer | Little Chantry Bull Lane SL9 8RH Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 48187880001 | |||||||||
| NAGLE, Kieran Matthew | Geschäftsführer | Rustic Lodge Carrick Hill Portmarnock Co Dublin Ireland | Irish | 43947240001 | ||||||||||
| NEWTON, Richard Paul | Geschäftsführer | 21 Priory Road Edgbaston B5 7UG Birmingham West Midlands | British | 2551790001 | ||||||||||
| OLDERSHAW, Peter Alan | Geschäftsführer | Wellesbourne 80 Newfield Road West Hagley DY9 0HY Stourbridge West Midlands | British | 2546430001 | ||||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PEDDER, Clive Thomas | Geschäftsführer | Chuck Hatch House Chuck Hatch TN7 4EX Hartfield East Sussex | United Kingdom | British | 71955460001 | |||||||||
| SOLOMONS, Anthony Nathan | Geschäftsführer | 10 Constable Close NW11 6TY London | United Kingdom | British | 8116770001 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| WHITTY, Brian Howard | Geschäftsführer | Ruxley House Rowney Green Lane Rowney Green B48 7QF Alvechurch Worcestershire | British | 36622750002 | ||||||||||
| WINN, Christopher | Geschäftsführer | Willow Bank Halls Farm Lane Trimpley DY12 1NP Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 15932260001 |
Hat MISYS B & S DIVISION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 22. Juni 1993 Geliefert am 01. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility letter, the guarantee and/or the counter indemnity | |
Kurze Angaben All the company's rights to receive payment for or in respect of the new ordinary shares as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trade marks mortgage | Erstellt am 05. März 1990 Geliefert am 20. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All trade marks of the company. (See form M525C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 05. März 1990 Geliefert am 20. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Aug. 1986 Geliefert am 16. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 11 february 1986. | |
Kurze Angaben Leasehold property known as and being ground & upper basement floors 18/19 pall mall london SW1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 17. Feb. 1986 Geliefert am 20. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 1.513 hectares at rutherford rd, southfield industrial estate, glenrothes, fife with factory buildings thereon k/a 29 rutherford road, glenrothes. 0.340 hectare comprising car park at rutherford road, southfield industrial estate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 21. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The research and development centre at vincent drive, edgbaston, b'ham. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and of present and future copyright by way of security charge | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 14. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The charged rights is defined to mean all the copyrights, rights in the nature of copyright and other rights, causes of action and interests assured assigned or charged. For fuller details see doc M78. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over goodwill trademarks & tradenames. | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 14. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any accounts whatsoever. | |
Kurze Angaben "The charged rights is defined to mean all trademarks, applications for trademarks, tradenames and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. For fuller details see DOCM77. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and of patents by way of security charge | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 14. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The charged rights is defined to mean all patents patent applications and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. See doc M76 for fuller details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and of registered designs by way of security charge | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 14. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The charged rights is defined to mean all registered designs applications for registered designs and other rights causes of action and interests assured assigned or charged. For further details see doc M75. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Feb. 1986 Geliefert am 12. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade fixtures see doc M74 for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Juli 1985 Geliefert am 23. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Act house, 111 hagley road, edgbaston, birmingham, w mids t/n wk 50832. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 10. Juni 1985 Geliefert am 26. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank (whether in the name of the company or not) on the company's behalf with some 3RD party for the deposit of moneys of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Feb. 1985 Geliefert am 18. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Elizabeth house 17 westbourne road, and the lodge 17A, westbourne road, edgbaston, w midlands. T/n WM28511 wm 312841. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Sept. 1983 Geliefert am 05. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H 111 hagley road edgbaston birmingham title no wk 50832. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juli 1983 Geliefert am 19. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property situate at & known as shenstone house, halesowen west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 24. Sept. 1980 Geliefert am 06. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MISYS B & S DIVISION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0