HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED

HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00850883
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    • (1581) /

    Wo befindet sich HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SARA LEE BAKERIES UK LIMITED04. Mai 199904. Mai 1999
    KITCHENS OF SARA LEE - UK LIMITED31. Dez. 197731. Dez. 1977
    SARA LEE LIMITED03. Juni 196503. Juni 1965

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2002
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Jan. 2003
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis18. Juni 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung02. Juli 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Jan. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2010

    2 Seiten3.6

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , 2 Cornwall Street, Birmingham, West Midlands, B3 2DL am 22. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2009

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Statement of affairs
    49 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    14 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten288b

    Verschiedenes

    Form 3.2 - statement of affairs
    17 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    14 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return17. Juli 2003

    legacy

    363(288)

    Wer sind die Geschäftsführer von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MURPHY, Oliver
    46 Merrion Square
    Dublin 2
    Ireland
    Geschäftsführer
    46 Merrion Square
    Dublin 2
    Ireland
    IrishDirector54197800003
    BROWN, Katharine Jane
    41 Anxey Way
    Haddenham
    HP17 8DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    41 Anxey Way
    Haddenham
    HP17 8DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor64457200001
    DAVISON, Stephen Francis
    45 Milne Road
    HU9 4UG Hull
    Humberside
    Sekretär
    45 Milne Road
    HU9 4UG Hull
    Humberside
    BritishFinance Director40111530001
    DELVES, Colm
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Sekretär
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    IrishDirector54197880005
    RUBENSTEIN, Howard Justin
    25 Meadow Drive
    Hendon
    NW4 1SD London
    Sekretär
    25 Meadow Drive
    Hendon
    NW4 1SD London
    British66642870001
    SCHOUTEN, Ted Anthony
    Park Dene
    34 Main Street Wetwang
    YO25 9XJ Driffield
    North Humberside
    Sekretär
    Park Dene
    34 Main Street Wetwang
    YO25 9XJ Driffield
    North Humberside
    Dutch/CanadianFinancial Director70226830001
    YOUNG, Brian
    Cherry Tree Cottage 31 Westgate
    Nafferton
    YO25 4LJ Driffield
    East Yorkshire
    Sekretär
    Cherry Tree Cottage 31 Westgate
    Nafferton
    YO25 4LJ Driffield
    East Yorkshire
    British12545660001
    ALLEN, Nicholas George
    25 Whistley Close
    RG12 9LQ Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    25 Whistley Close
    RG12 9LQ Bracknell
    Berkshire
    BritishAccountant46190320001
    ANAND, Rooney
    40a York Street
    Dunnington
    YO19 5QT York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    40a York Street
    Dunnington
    YO19 5QT York
    North Yorkshire
    BritishManaging Director67358830002
    ANAND, Rooney
    Sutton House
    Full Sutton
    YO4 1HW York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sutton House
    Full Sutton
    YO4 1HW York
    Yorkshire
    BritishMarketing Director67358830001
    BAINES, David
    Church Street
    Dunnington
    YO19 5PW York
    20
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Church Street
    Dunnington
    YO19 5PW York
    20
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director70235200002
    BROWN, Katharine Jane
    41 Anxey Way
    Haddenham
    HP17 8DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    41 Anxey Way
    Haddenham
    HP17 8DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor64457200001
    DAVISON, Stephen Francis
    45 Milne Road
    HU9 4UG Hull
    Humberside
    Geschäftsführer
    45 Milne Road
    HU9 4UG Hull
    Humberside
    BritishGroup Controller40111530001
    DELVES, Colm
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    Geschäftsführer
    Rose Hall
    Killineer
    IRISH Drogheda
    County Louth
    Ireland
    IrishDirector54197880005
    DUNSTAN, Andrea Margaret
    Sand House
    North Street Nafferton
    Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Sand House
    North Street Nafferton
    Driffield
    North Humberside
    BritishPersonnel Director56933680001
    KENNEDY, Denise Yvonne
    3 Hamilton Lodge
    Kings Road
    SL4 2AS Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    3 Hamilton Lodge
    Kings Road
    SL4 2AS Windsor
    Berkshire
    BritishSolicitor43844440001
    LIVINGSTON, Osmund Piers
    2 Shaftsbury Way
    Strawberry Hill
    TW2 5RP Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Shaftsbury Way
    Strawberry Hill
    TW2 5RP Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director809050001
    MAXWELL, Ruth Emily
    74 Glen Road
    West Cross
    SA3 5PS Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    74 Glen Road
    West Cross
    SA3 5PS Swansea
    West Glamorgan
    BritishH R Director54030020002
    MICKLETHWAITE, Andrew
    Adel Garth
    25 Saint Helens Lane
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Adel Garth
    25 Saint Helens Lane
    LS16 8BR Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant71170600001
    RUBENSTEIN, Howard Justin
    25 Meadow Drive
    Hendon
    NW4 1SD London
    Geschäftsführer
    25 Meadow Drive
    Hendon
    NW4 1SD London
    BritishSolicitor66642870001
    SCHOUTEN, Ted Anthony
    Park Dene
    34 Main Street Wetwang
    YO25 9XJ Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Park Dene
    34 Main Street Wetwang
    YO25 9XJ Driffield
    North Humberside
    Dutch/CanadianFinancial Director70226830001
    SMITH, Timothy John
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Swanland Lodge
    West End, Swanland
    HU14 3PE Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director84729640001
    STEVENS, Bernard William
    4 Fox Glade
    Stamford Bridge
    YO41 1EX York
    Geschäftsführer
    4 Fox Glade
    Stamford Bridge
    YO41 1EX York
    EnglandBritishSales Director81502330001
    WOODALL, Michael John
    Farberry
    Seaton Road
    HU18 1BS Hornsea
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Farberry
    Seaton Road
    HU18 1BS Hornsea
    North Humberside
    BritishOperations Director12545670001
    WOODBRIDGE, Julie
    Springfield House West End
    Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Springfield House West End
    Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    BritishRetail Director67019280001
    YOUNG, Brian
    Cherry Tree Cottage 31 Westgate
    Nafferton
    YO25 4LJ Driffield
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Cottage 31 Westgate
    Nafferton
    YO25 4LJ Driffield
    East Yorkshire
    BritishFinancial Director12545660001

    Hat HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage deed
    Erstellt am 10. Okt. 2003
    Geliefert am 17. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as land lying on the north side of lancaster road carnaby industrial estate bridlington east riding of yorkshire t/nos yea 19695 HS182770 hs 162640 and yea 19694. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 17. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from any charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) unit B2/28 oakesway,hartlepool industrial estate; CE123779; (ii) unit B2 97/6 park view industrial estate,brenda rd,hartlepool; CE87359; (iii) premises at concord way,preston farm,stockton on tees; CE123477 plus other properties listed; all fixtures and proceeds of sale thereon and any covenants or rights; all fixed plant machinery stocks debentures bonds or other securities and all book/other debts and licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited ("Gmac")
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 102. Feb. 2011Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Equipment mortgage
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 02. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage
    Kurze Angaben
    Various items of equipment as described in the form 395 and all right title benefit and interest of the company in and to all insurances and all right title benefit and interest of the company in and to all warranties and other claims under or in connection with the sale to and purchased by the company of the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 27. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north side of lancaster road carnaby industrial estate bridlington t/no's;-HS6281 HS51979 HS162340 HS182770 all buildings and fixtures thereon benefit of all present and future licences in connection with the said business all compensation in relation thereto goodwill the "assigned agreements" benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Equipment mortgage
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 27. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The equipment (as specified in schedule to form 395 relative to the charge) and the insurances and any other property assets or income assigned or charges to the chargee under or pursuant to the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 25. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h and l/h property known as freehold land lying north of lancaster road, carnaby industrial estate, bridlington t/n HS6281, HS51979, HS162340 and HS182770 and all buildings and fixtures (including tenant's and trade fixtures) from time to time on any such property and all plant, machinery, vehicles, computers and office and other equipment from time to time on any such property both present and future (the property). Fixed charge the benefit of all rights and claims of any nature whatsoever against (I) any lessees, licencees or other occupiers (ii) all guarantors and sureties of such lessees or occupiers (iii) any persons who are under any obligation to the company in respect of any works of design construction repair or replacement to on or about the whole or any parts of the property (the claims). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge on book debts
    Erstellt am 13. Sept. 2001
    Geliefert am 20. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all amounts present or future owing or to become owing to the company in respect of the sale of goods or the supply of services by the company in the ordinary course of the company's business (except those vesting in gmac under the factoring or invoice discounting agreement) (including without limitation deposits and credit balances held by third parties from time to time) now or at any time hereafter due or owing to the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. März 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Myles Anthony Halley
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0