HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00850883 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
- (1581) /
Wo befindet sich HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o KPMG LLP One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SARA LEE BAKERIES UK LIMITED | 04. Mai 1999 | 04. Mai 1999 |
KITCHENS OF SARA LEE - UK LIMITED | 31. Dez. 1977 | 31. Dez. 1977 |
SARA LEE LIMITED | 03. Juni 1965 | 03. Juni 1965 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2002 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Jan. 2003 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 18. Juni 2017 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 02. Juli 2017 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Jan. 2011 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | LQ02 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2010 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 2 Cornwall Street, Birmingham, West Midlands, B3 2DL am 22. Dez. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2009 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Okt. 2008 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 3 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Verschiedenes Statement of affairs | 49 Seiten | MISC | ||||||||||
Bericht des Verwaltungsverwalters | 14 Seiten | 3.10 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Verschiedenes Form 3.2 - statement of affairs | 17 Seiten | MISC | ||||||||||
Bericht des Verwaltungsverwalters | 14 Seiten | 3.10 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 405(1) | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURPHY, Oliver | Geschäftsführer | 46 Merrion Square Dublin 2 Ireland | Irish | Director | 54197800003 | |||||
BROWN, Katharine Jane | Sekretär | 41 Anxey Way Haddenham HP17 8DJ Aylesbury Buckinghamshire | British | Solicitor | 64457200001 | |||||
DAVISON, Stephen Francis | Sekretär | 45 Milne Road HU9 4UG Hull Humberside | British | Finance Director | 40111530001 | |||||
DELVES, Colm | Sekretär | Rose Hall Killineer IRISH Drogheda County Louth Ireland | Irish | Director | 54197880005 | |||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Sekretär | 25 Meadow Drive Hendon NW4 1SD London | British | 66642870001 | ||||||
SCHOUTEN, Ted Anthony | Sekretär | Park Dene 34 Main Street Wetwang YO25 9XJ Driffield North Humberside | Dutch/Canadian | Financial Director | 70226830001 | |||||
YOUNG, Brian | Sekretär | Cherry Tree Cottage 31 Westgate Nafferton YO25 4LJ Driffield East Yorkshire | British | 12545660001 | ||||||
ALLEN, Nicholas George | Geschäftsführer | 25 Whistley Close RG12 9LQ Bracknell Berkshire | British | Accountant | 46190320001 | |||||
ANAND, Rooney | Geschäftsführer | 40a York Street Dunnington YO19 5QT York North Yorkshire | British | Managing Director | 67358830002 | |||||
ANAND, Rooney | Geschäftsführer | Sutton House Full Sutton YO4 1HW York Yorkshire | British | Marketing Director | 67358830001 | |||||
BAINES, David | Geschäftsführer | Church Street Dunnington YO19 5PW York 20 North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 70235200002 | ||||
BROWN, Katharine Jane | Geschäftsführer | 41 Anxey Way Haddenham HP17 8DJ Aylesbury Buckinghamshire | British | Solicitor | 64457200001 | |||||
DAVISON, Stephen Francis | Geschäftsführer | 45 Milne Road HU9 4UG Hull Humberside | British | Group Controller | 40111530001 | |||||
DELVES, Colm | Geschäftsführer | Rose Hall Killineer IRISH Drogheda County Louth Ireland | Irish | Director | 54197880005 | |||||
DUNSTAN, Andrea Margaret | Geschäftsführer | Sand House North Street Nafferton Driffield North Humberside | British | Personnel Director | 56933680001 | |||||
KENNEDY, Denise Yvonne | Geschäftsführer | 3 Hamilton Lodge Kings Road SL4 2AS Windsor Berkshire | British | Solicitor | 43844440001 | |||||
LIVINGSTON, Osmund Piers | Geschäftsführer | 2 Shaftsbury Way Strawberry Hill TW2 5RP Twickenham Middlesex | British | Company Director | 809050001 | |||||
MAXWELL, Ruth Emily | Geschäftsführer | 74 Glen Road West Cross SA3 5PS Swansea West Glamorgan | British | H R Director | 54030020002 | |||||
MICKLETHWAITE, Andrew | Geschäftsführer | Adel Garth 25 Saint Helens Lane LS16 8BR Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 71170600001 | |||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Geschäftsführer | 25 Meadow Drive Hendon NW4 1SD London | British | Solicitor | 66642870001 | |||||
SCHOUTEN, Ted Anthony | Geschäftsführer | Park Dene 34 Main Street Wetwang YO25 9XJ Driffield North Humberside | Dutch/Canadian | Financial Director | 70226830001 | |||||
SMITH, Timothy John | Geschäftsführer | Swanland Lodge West End, Swanland HU14 3PE Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 84729640001 | ||||
STEVENS, Bernard William | Geschäftsführer | 4 Fox Glade Stamford Bridge YO41 1EX York | England | British | Sales Director | 81502330001 | ||||
WOODALL, Michael John | Geschäftsführer | Farberry Seaton Road HU18 1BS Hornsea North Humberside | British | Operations Director | 12545670001 | |||||
WOODBRIDGE, Julie | Geschäftsführer | Springfield House West End Lund YO25 9TN Driffield North Humberside | British | Retail Director | 67019280001 | |||||
YOUNG, Brian | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage 31 Westgate Nafferton YO25 4LJ Driffield East Yorkshire | British | Financial Director | 12545660001 |
Hat HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage deed | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 17. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property known as land lying on the north side of lancaster road carnaby industrial estate bridlington east riding of yorkshire t/nos yea 19695 HS182770 hs 162640 and yea 19694. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 | Erstellt am 28. März 2002 Geliefert am 17. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from any charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) unit B2/28 oakesway,hartlepool industrial estate; CE123779; (ii) unit B2 97/6 park view industrial estate,brenda rd,hartlepool; CE87359; (iii) premises at concord way,preston farm,stockton on tees; CE123477 plus other properties listed; all fixtures and proceeds of sale thereon and any covenants or rights; all fixed plant machinery stocks debentures bonds or other securities and all book/other debts and licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Equipment mortgage | Erstellt am 20. Sept. 2001 Geliefert am 02. Okt. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage | |
Kurze Angaben Various items of equipment as described in the form 395 and all right title benefit and interest of the company in and to all insurances and all right title benefit and interest of the company in and to all warranties and other claims under or in connection with the sale to and purchased by the company of the equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Sept. 2001 Geliefert am 27. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land lying to the north side of lancaster road carnaby industrial estate bridlington t/no's;-HS6281 HS51979 HS162340 HS182770 all buildings and fixtures thereon benefit of all present and future licences in connection with the said business all compensation in relation thereto goodwill the "assigned agreements" benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equipment mortgage | Erstellt am 20. Sept. 2001 Geliefert am 27. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The equipment (as specified in schedule to form 395 relative to the charge) and the insurances and any other property assets or income assigned or charges to the chargee under or pursuant to the mortgage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Sept. 2001 Geliefert am 25. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h and l/h property known as freehold land lying north of lancaster road, carnaby industrial estate, bridlington t/n HS6281, HS51979, HS162340 and HS182770 and all buildings and fixtures (including tenant's and trade fixtures) from time to time on any such property and all plant, machinery, vehicles, computers and office and other equipment from time to time on any such property both present and future (the property). Fixed charge the benefit of all rights and claims of any nature whatsoever against (I) any lessees, licencees or other occupiers (ii) all guarantors and sureties of such lessees or occupiers (iii) any persons who are under any obligation to the company in respect of any works of design construction repair or replacement to on or about the whole or any parts of the property (the claims). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge on book debts | Erstellt am 13. Sept. 2001 Geliefert am 20. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all amounts present or future owing or to become owing to the company in respect of the sale of goods or the supply of services by the company in the ordinary course of the company's business (except those vesting in gmac under the factoring or invoice discounting agreement) (including without limitation deposits and credit balances held by third parties from time to time) now or at any time hereafter due or owing to the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat HIBERNIA FOODS BAKERIES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0