PS&N (PROPERTIES)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePS&N (PROPERTIES)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 00869354
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PS&N (PROPERTIES)?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich PS&N (PROPERTIES)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Eighth Floor 6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PS&N (PROPERTIES)?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PHILLIPS,SON & NEALE(PROPERTIES)19. Jan. 196619. Jan. 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PS&N (PROPERTIES)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für PS&N (PROPERTIES)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 008693540054 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    12 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Edward James Rothwell Lee am 23. Mai 2019

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 008693540053 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 008693540054, erstellt am 21. März 2019

    28 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Edward James Rothwell Lee als Direktor am 16. Okt. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher David Watson als Sekretär am 11. Sept. 2018

    1 SeitenTM02

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 101 New Bond St London W1S 1SR United Kingdom zum Q3, the Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW geändert

    1 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Montpelier Galleries Montpelier Street London SW7 1HH zum Eighth Floor 6 New Street Square New Fetter Lane London EC4A 3AQ am 17. Okt. 2018

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    19 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 008693540053, erstellt am 24. Juni 2015

    108 SeitenMR01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    4 SeitenMA

    Wer sind die Geschäftsführer von PS&N (PROPERTIES)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROOKS, Robert
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Geschäftsführer
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    United KingdomBritish77117950001
    LEE, Edward James Rothwell
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Geschäftsführer
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    United KingdomBritish250335380002
    SCHALKEN, Johannes Martinas Adrianus
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Geschäftsführer
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    NetherlandsDutch78804240002
    GOLDSTEIN, Julie Ann
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    Sekretär
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    British102976800001
    MCMULLAN, David Malcom
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    Sekretär
    Brierley Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    British36232820001
    MCNEILL, Victoria
    Flat 12 Transenna Works
    1 Laycock Street
    N1 1SJ London
    Sekretär
    Flat 12 Transenna Works
    1 Laycock Street
    N1 1SJ London
    British85028640001
    PARSONS, John Malcolm
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    Sekretär
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    British17177570001
    WATSON, Christopher David
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    Sekretär
    6 New Street Square
    New Fetter Lane
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    England
    British5629390001
    BARBER, Malcolm John
    Hillbury House 157 Westhall Road
    CR6 9HJ Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hillbury House 157 Westhall Road
    CR6 9HJ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish42014080002
    GOLDSTEIN, Julie Ann
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    Geschäftsführer
    92 Highgate West Hill
    N6 6NU London
    United KingdomBritish102976800001
    HOLLEST, Roger Henry
    The Old Malthouse
    Shaw
    SN12 8EF Melksham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Old Malthouse
    Shaw
    SN12 8EF Melksham
    Wiltshire
    EnglandEnglish126255590001
    NEWALL, Archibald Patrick
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    Geschäftsführer
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    British70430050001
    PARSONS, John Malcolm
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Croft Cottage 16 Broomcroft Road
    Felpham
    PO22 7NJ Bognor Regis
    West Sussex
    British17177570001
    THOMSON, Christopher Norman
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish11591540001
    WESTON, Christopher John
    5 Hillside Close
    Carlton Hill
    NW8 0EF London
    Geschäftsführer
    5 Hillside Close
    Carlton Hill
    NW8 0EF London
    United KingdomBritish35351890001
    WESTON, William Jeremy
    201 Gilbert House
    Barbican Estate
    EC2Y 8BD London
    Geschäftsführer
    201 Gilbert House
    Barbican Estate
    EC2Y 8BD London
    British56113340001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PS&N (PROPERTIES)?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ps&N Limited
    Montpelier Street
    SW7 1HH London
    Montpelier Galleries
    England
    06. Apr. 2016
    Montpelier Street
    SW7 1HH London
    Montpelier Galleries
    England
    Nein
    RechtsformPs&N Limited
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House Uk
    Registrierungsnummer3026473
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat PS&N (PROPERTIES) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. März 2019
    Geliefert am 29. März 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Mortgages over land and property under title numbers WK216616, WK187988, NGL924443, 283993, 267762, 239395, 394583 and NGL919705. See instrument for further details.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Johannes Martinus Adrianus Schalken
    • Hans Tulp
    • Robert Brooks
    • Edward James Rothwell Lee
    Transaktionen
    • 29. März 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 20. Okt. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 24. Juni 2015
    Geliefert am 07. Juli 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of properties charged please refer to form 395) shares, investments, equipment, credit balances, intellectual property rights, goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH august 2005
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 18. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises forming number 63 george street and forty three south west thistle street lane in the city and county of edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cias A.G. as Security Trustee
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 2005
    Geliefert am 05. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee all its present and future right title and interest in the properties 1 old king street bath t/no AV18867 10 and 11 salem road bayswater london t/no LN35119, 17A east parade leeds t/no WYK330813. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cias A.G. (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 30. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilitiesv due or to become due from bonhams 1793 limited (the "debtor") to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    101 new bond street,7 blenheim street and 24 woodstock street and 3 and 4-8 haunch of venison yard,london W.1; t/nos 283993,267762,394583 and 239305. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH january 2003
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 15. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,905,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    63 george street and 43 south west thistle street lane edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 05. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 10-11 salem road, bayswater, city of westminster, greater london t/no. LN135119. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 27TH february 1998
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 13. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    63 george street and 43 south west thistle street lane edinburgh and 65 and 65A george street edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 27. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 4-8 haunch of venison yard london t/n 239305. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings on the south side of christleton road chester t/n CH219607. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a factory premises on the west side of salem road westminster t/n ln 135119. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 26-46 lisson grove and 18 hayes place westminster t/n LN88703. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a hamilton house armdada street plymouth t/n DN88759. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings on the north side of armdada street plymouth t/n DN29407. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a the auction rooms 13 lime tree walk sevenoaks t/n K712049. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings formerly k/a st marys church church street gateshead t/n ty 169860. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a auction sale rooms long street sherborne t/n dt 183070. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 17A east parade leeds t/n wyk 330813. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 31 eastcliffe road par cornwall t/n cl 24775. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 9 and 10 westgate cardiff t/n wa 142691. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 101 new bond street london t/n 283993. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a blenstock house 7 blenheim street and 24 woodstock street london t/n 267762. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 1998
    Geliefert am 19. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 14 station road knowle t/n WK187988. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0