EURAMAX HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEURAMAX HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00873537
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brunel Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JW Corby
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALUMAX HOLDINGS LIMITED04. Feb. 199204. Feb. 1992
    ALUMAX INTERNATIONAL LIMITED10. März 196610. März 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 SeitenSH20

    legacy

    3 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 14/12/2011
    RES13

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011

    1 SeitenAA01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2008

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2005

    12 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von EURAMAX HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WADE, Steve
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    British117491680001
    LEWIS, Mitchell B
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    Geschäftsführer
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    UsaAmerican135352620001
    SMAILES, Nigel Andrew
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish16154490003
    VANSANT, Robert Scott
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    Geschäftsführer
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    UsaAmerican92216760001
    DAVIES, Neil Patrick
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    Sekretär
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    British4079450001
    DAVIES, Neil Patrick
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    Sekretär
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    British4079450001
    PITTENDREIGH, Ian
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    British42432160002
    SILVESTRI, Joseph
    48 West 68th Street
    Apartment 8c
    10023 New York
    New York
    Usa
    Sekretär
    48 West 68th Street
    Apartment 8c
    10023 New York
    New York
    Usa
    American49636400001
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    DAVIES, Neil Patrick
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    Geschäftsführer
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    British4079450001
    DAVIES, Neil Patrick
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    Geschäftsführer
    25 Bispham Road
    NW10 7HB London
    British4079450001
    DRACK, Paul Edward
    5655 Peachtree Parkway
    Norcross Georgia 30092-2812
    U S A
    Geschäftsführer
    5655 Peachtree Parkway
    Norcross Georgia 30092-2812
    U S A
    American52018610001
    EVANS, Vasco Bond
    1760 Portage Road
    Niles
    49120 Michigan
    Usa
    Geschäftsführer
    1760 Portage Road
    Niles
    49120 Michigan
    Usa
    Canadian4079480002
    FEENEY, Helen Gertrude Mccall
    76 Mohawk Trail
    Stamford
    6930 Connecticut
    Usa
    Geschäftsführer
    76 Mohawk Trail
    Stamford
    6930 Connecticut
    Usa
    Us Citizen16926840001
    HEYMAN, Walter Leo
    35 Citrus Court
    Hillsborough California 94010
    U S A
    Geschäftsführer
    35 Citrus Court
    Hillsborough California 94010
    U S A
    American4079470001
    KURVERS, Franciscus Theodorus Henricus
    Kasteelaan 7
    6081 An Haelen
    FOREIGN Netherlands
    Geschäftsführer
    Kasteelaan 7
    6081 An Haelen
    FOREIGN Netherlands
    Dutch9841570001
    LALONDE, Dale Harold
    3423 Pinestream Road
    Atlanta Georgia 30327
    Usa
    Usa
    Geschäftsführer
    3423 Pinestream Road
    Atlanta Georgia 30327
    Usa
    Usa
    American9841580001
    PUGH, David Christopher
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50680510001
    SMITH, John David
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    Geschäftsführer
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    American92216850001
    WALTERS, Roger Anthony
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish50421200001
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002

    Hat EURAMAX HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First lien debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation as Agent and Trustee for Itself and Each of the Securedcreditors (The Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third U.K. consent agreement
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 04. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage....please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third U.K. consent agreement between euramax international limited, euramax international holdings limited, the euramax continental limited, the company, euramax european holdings limited, euramax europe limited, euramax coated products limited, ellbee limited and bnp paribas
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 04. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage....please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    U.K. consent agreement between euramax international inc., Euramax international limited, euramax international holdings limited, euramax continental limited, the company, euramax holdings limited, euramax european holdings limited, euramax coated products limited, ellbee limited and paribas
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    1. the mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage.... "Shares" means any shares in the capital of the company referred to in the schedule to the form 395 and all dividends interest or other monies paid or payable thereon...". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 03. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the "secured obligations" meaning the guarantied obligations of the company and the U.K. operating co. Obligations (each as defined) provided that no obligation or liability shall be included in the defination of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985.
    Kurze Angaben
    (A) by way of first legal mortgage all the property (if any) specified in schedule 1 to the form 395 together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in respect of such covenants;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1996
    Geliefert am 03. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The guarantied obligations of the company and the U.K. operating co. Obligations (as defined)
    Kurze Angaben
    The shares as defined all plant and machinery all moneys all benefits of insurnces all present and future book debts goodwill and uncalled capital and by way of first floating charge all undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Paribas
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0