THE GAME GROUP PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE GAME GROUP PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00875835
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE GAME GROUP PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich THE GAME GROUP PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE GAME GROUP PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE ELECTRONICS BOUTIQUE PLC22. Juli 199622. Juli 1996
    RHINO GROUP PLC16. Okt. 199216. Okt. 1992
    JMD GROUP PLC05. Aug. 198805. Aug. 1988
    JOHN MICHAEL DESIGN PLC31. März 196631. März 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE GAME GROUP PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THE GAME GROUP PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE GAME GROUP PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 25. Sept. 2015

    12 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Sept. 2015

    9 Seiten2.24B

    Kündigung eines Administrators

    1 Seiten2.38B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. März 2015

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Sept. 2014

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. März 2014

    16 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2014

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Aug. 2013

    14 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Vivienne Hemming als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Feb. 2013

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unity House Telford Road Basingstoke Hampshire RG21 6YJ* am 29. Okt. 2012

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2012

    16 Seiten2.24B

    legacy

    3 SeitenMG04

    Beendigung der Bestellung von Ian Shepherd als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin Davies als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Russell Shaw als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ishbel Macpherson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Bell als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Dana Dunne als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG04

    legacy

    10 SeitenMG04

    Wer sind die Geschäftsführer von THE GAME GROUP PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WHITE, Benjamin
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    Geschäftsführer
    The Row
    Redlynch
    SP5 2JT Nr Salisbury
    Anvil Cottage
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritishAccountant133790090002
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Sekretär
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Sekretär
    25 St Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British125932650001
    THOMAS, David Fraser
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    Sekretär
    Glendevon 9 Cheyne Walk
    CR0 7HH Croydon
    Surrey
    British27763020002
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director15237500001
    BEECHAM, Richard Jacob
    Nash House 3 Chester Terrace
    Regent`S Park
    NW1 4ND London
    Geschäftsführer
    Nash House 3 Chester Terrace
    Regent`S Park
    NW1 4ND London
    United KingdomBritishDirector36721180001
    BELL, Christopher
    79 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    79 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    UkBritishCompany Director37952640002
    BURNEY, Cecil, Sir
    5 Lyall Street
    SW1X 8DW London
    Geschäftsführer
    5 Lyall Street
    SW1X 8DW London
    BritishDirector13933800001
    DAVIES, Martin William Oliver
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishDirector98399000002
    DUNNE, Dana Philip
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Unity House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Unity House
    Hampshire
    United KingdomBritishNone186787540002
    FIRESTONE, Joseph
    101 Bay Hill Drive
    Bluebell Pa 19422
    Usa
    Geschäftsführer
    101 Bay Hill Drive
    Bluebell Pa 19422
    Usa
    UsaCompany Director46132520002
    GIRAUD, Jean Paul
    53 Rue De La Tour
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    Geschäftsführer
    53 Rue De La Tour
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    FrenchDirector94164160001
    GREENBURY, Richard, Sir
    Ambarrow Wood
    Ambarrow Lane
    GU47 8JE Sandhurst
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Ambarrow Wood
    Ambarrow Lane
    GU47 8JE Sandhurst
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director4735600002
    GRIFFITHS, Jeffrey William
    1802 Hickory Way
    PA19440 Hatfield
    Usa
    Geschäftsführer
    1802 Hickory Way
    PA19440 Hatfield
    Usa
    AmericanVice President43688420001
    KIRKPATRICK, Ian
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director31693560001
    LEWIS, Henry Nathan
    15 Pavilion Court
    Frognal Rise
    NW3 6PZ London
    Geschäftsführer
    15 Pavilion Court
    Frognal Rise
    NW3 6PZ London
    BritishCompany Director16463020003
    LEWIS, Peter Donald
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director55096310002
    LONG, Martin
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Flyford
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director125885350001
    MACPHERSON, Ishbel Jean Stewart
    West Bradfield House,
    EX15 2QY Bradfield
    Devon
    Geschäftsführer
    West Bradfield House,
    EX15 2QY Bradfield
    Devon
    United KingdomBritishDirector151546810001
    MANSFIELD, David James
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector32585450001
    MORGAN, Lisa Jayne
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Cobwebs
    Longwater Road
    RG27 0NW Eversley
    Hampshire
    BritishCompany Director38420460004
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director8778080001
    PANICHELLO, John Robert
    1432 Monk Road
    Philadelphia
    PA 19035 Gladwyne
    Usa
    Geschäftsführer
    1432 Monk Road
    Philadelphia
    PA 19035 Gladwyne
    Usa
    AmericanVice President43926420003
    PICKUP, Anthony Robert
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    5 Old School Court
    School Lane
    MK18 1WE Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishDirector49762320003
    RIPLEY, Beverley
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Blackmoor Farm
    Ockham Lane
    KT11 4LZ Chobham
    Surrey
    BritishCompany Director23762560001
    SCARDINO, Albert
    Flat 19 Empire House
    Thurloe Place
    SW7 2RU London
    Geschäftsführer
    Flat 19 Empire House
    Thurloe Place
    SW7 2RU London
    UkBritishJournalist51349530001
    SCICLUNA, Terence Joseph
    1 Pennymead Place
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Pennymead Place
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    EnglandBritishChief Operating Officer185155550001
    SHAH, Kishorilal Devchand Gosar
    Pembroke Road
    Moore Park
    HA6 2HR Northwood
    26
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Pembroke Road
    Moore Park
    HA6 2HR Northwood
    26
    Middlesex
    EnglandBritishDirector139458500002
    SHAW, Russell James
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandAmerican,BritishDirector114476920001
    SHEPHERD, Ian
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Unity House
    Telford Road
    RG21 6YJ Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector153448920001
    SLEE, William Robert
    52 South Eaton Place
    SW1W 9JJ London
    Geschäftsführer
    52 South Eaton Place
    SW1W 9JJ London
    DutchBanker7971830001
    STEINBRECHER, John Mark
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    27 St Andrews Gardens
    KT11 1HG Cobham
    Surrey
    AmericanVice President43688810003
    THOMAS, David Fraser
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    Geschäftsführer
    Farm Drive
    The Webb Estate
    CR8 3LP Purley
    Woodlands
    Surrey
    EnglandBritishDirector27763020003
    WOODSIDE, Dennis
    Thomas Place
    W8 5UG London
    8
    Geschäftsführer
    Thomas Place
    W8 5UG London
    8
    UsaVp Google131826080001
    ZEFF, Alf
    The Chantry Spaniards End
    Hampstead
    NW3 7JG London
    Geschäftsführer
    The Chantry Spaniards End
    Hampstead
    NW3 7JG London
    BritishDirector13933820001

    Hat THE GAME GROUP PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of amendment of a deed of creation of right of pledge over quotas
    Erstellt am 10. Juni 2011
    Geliefert am 25. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group (including the company) to the chargee and/or the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first ranking pledge over the quotas see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee), National Westminster Bank PLC, Barclays Bank PLC, Hsbc Bank PLC, Hsbc Bank Australia Limited, the Governor and Company of the Bank of Ireland, Allied Irish Banks P.L.C., Caixa D'estalvis I Pensions De Barcelona and the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 25. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of creation of right of pledge over quotas executed outside the united kingdom over property situated there
    Erstellt am 01. März 2011
    Geliefert am 16. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and/or the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledgor represented and warranted that the quotas are not subject to any lien or emcumbrance other than the pledge,it has capacity,right and title to execute the deed and to pledge the quotas see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,National Westminster Bank PLC,Barclays Bank PLC,Hsbc Bank PLC,Hsbc Bank Australia Limited,the Governor and Company of the Bank of Ireland,Allied Irish Banks P.L.C and Caixa D'estalvis 1 Pensions De Barcelona
    Transaktionen
    • 16. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    First priority pledge agreement relating to all shares
    Erstellt am 01. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the pledged assets as security for the secured obligations. Shares means 50,000 shares and all other shares or other securities issued by the company from time to time and as at 1 march 2011 or in the future owned by the pledgor see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 01. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Juni 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Sept. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Deed of creation of rights of pledge over quotas executed outside the united kingdom over property situated there
    Erstellt am 29. Juli 2009
    Geliefert am 10. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The quotas meaning the 119,775 quotas of the company of the same class and series with a face value of 6.010121 euros each amounting to 100% of the companys share capital see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC, Barclays Bank PLC, Lloyds Tsb Bank PLC, the Governor and Company of the Bank of Ireland and Caxia D'estalvis I Pensions De Barcelona
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2009
    • 25. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 2009
    Geliefert am 04. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2009
    • 25. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of creation of concurrent pledges over quotas
    Erstellt am 21. Mai 2007
    Geliefert am 01. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monieas due or to become from each present or future member of the group to the chargee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The quotas meaning the 119,775 quotas of the company of the same class and series with a face value of 6.010121 euros each amounting to 100% of the companys share capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Rbs or Security Trustee) and National Westminster Bank PLC(Natwest) (the Term Facilty Lenders)
    Transaktionen
    • 01. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 2007
    Geliefert am 11. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (In Such Capacity,the 'Security Trustee')
    Transaktionen
    • 11. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 2000
    Geliefert am 12. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Apr. 1999
    Geliefert am 28. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over account
    Erstellt am 11. Apr. 1999
    Geliefert am 28. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and to all sums standing to the credit of the charged account number 58603778 in the name of the company with the bank designated "eb control account". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 11. Apr. 1999
    Geliefert am 28. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All ordinary shares in the capital of game PLC together with all dividends interest and other distributions and all bonuses benefits and advantages whatsoever, all rights in against and to any crest participant andy account forming part of crest and any payment obligation of any crest settlement bank arising in respect of any uncertificated shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Feb. 1994
    Geliefert am 04. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 1990
    Geliefert am 22. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (For full details refer to doc 393 res M269C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • D Q Henriques Limited
    Transaktionen
    • 22. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Aug. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Gurantee debenture
    Erstellt am 10. Jan. 1990
    Geliefert am 30. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 16. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Gurantee debenture
    Erstellt am 16. Juni 1989
    Geliefert am 03. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Apr. 1988
    Geliefert am 20. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 16. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 1983
    Geliefert am 04. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 198,700 and all other monies due or to become due from the company and/or brombard trustees limited to the chargee.
    Kurze Angaben
    L/H property known as unit 1 comtech william rd camden.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Gereby Trust Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    Gurantee debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1982
    Geliefert am 30. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat THE GAME GROUP PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. März 2012Beginn der Verwaltung
    25. Sept. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart David Maddison
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Praktiker
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Berkshire
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0