ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD
Überblick
Unternehmensname | ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00880172 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham Cheshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ALTAIR FILTERS INTERNATIONAL LIMITED | 19. Juli 1984 | 19. Juli 1984 |
ALTAIR VENTILATION PRODUCTS LIMITED | 26. Mai 1966 | 26. Mai 1966 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Edward Dennison als Geschäftsführer am 01. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Shona Clare Searle als Direktor am 01. Juli 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Ge Energy Services (Uk) Limited as a person with significant control on 03. Mai 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of General Electric Uk Holdings Ltd. as a person with significant control on 03. Mai 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Juli 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von James Edward Dennison zum Geschäftsführer | 3 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Edward Dennison am 31. Juli 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU zum 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT am 31. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Ge Energy Services (Uk) Limited as a person with significant control on 31. Juli 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Robert Hill als Geschäftsführer am 24. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
SEARLE, Shona Clare | Geschäftsführer | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant And Chartered Tax Advisor | 203330870002 | ||||||||
BURKE, Mary | Sekretär | 4471 Chattahoochie Plantation Drive FOREIGN Marietta Georgia 30067 Usa | American | Director | 111641000001 | |||||||||
HEGARTY, Colin Michael | Sekretär | 15 Cornfields GU46 6YT Yateley Hampshire | British | 14062610002 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
BOYCE, Christian Jeremy | Geschäftsführer | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Site Leader | 174484350001 | ||||||||
BURKE, Mary | Geschäftsführer | 4471 Chattahoochie Plantation Drive FOREIGN Marietta Georgia 30067 Usa | American | Director | 111641000001 | |||||||||
CARSON, Candace | Geschäftsführer | 653 Briarleigh Way FOREIGN Woodstock Georgia 30189 America | American | Director | 111758740001 | |||||||||
CHURCH, Ian Harold | Geschäftsführer | 25 Fairlawn Park GU21 4HT Woking Surrey | British | Director | 1750390002 | |||||||||
CLARK, Alyson Margaret | Geschäftsführer | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Legal Counsel | 56868460002 | ||||||||
CLEAVER, Roy Edward | Geschäftsführer | Hill House Brightstone Lane Farringdon GU34 3ET Alton Hampshire | British | Director | 21416960002 | |||||||||
DENNISON, James Edward | Geschäftsführer | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tax Director | 250786800001 | ||||||||
ELSDON, Peter John | Geschäftsführer | Chase Warren Tennysons Lane GU27 3AF Haslemere Surrey | United Kingdom | British | Company Director Accountant | 67751830001 | ||||||||
EVERETT, Peter Daryl | Geschäftsführer | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | Tax Manager | 127244240001 | ||||||||
EVERETT, Peter Daryl | Geschäftsführer | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | Tax Manager | 127244240001 | ||||||||
GRIFFITHS, David Maxwell | Geschäftsführer | 1 Shepherds Down SO24 9PP Alresford Hampshire | British | Engineer | 88087440001 | |||||||||
HEGARTY, Colin Michael | Geschäftsführer | 15 Cornfields GU46 6YT Yateley Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 14062610002 | ||||||||
HEINTZELMAN, Daniel | Geschäftsführer | 5116 Sapphire Drive FOREIGN Marietta Georgia 30066 Usa | American | General Manager | 111641060001 | |||||||||
HILL, Timothy Robert | Geschäftsführer | The Arena Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 2 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 183650700001 | ||||||||
HINTON, David Ian Small | Geschäftsführer | The Old Brewery Hilltop Chichester Road GU29 9PZ Midhurst West Sussex | United Kingdom | British | Director | 21416950001 | ||||||||
KEENAN, John Joseph | Geschäftsführer | 5 Gresham Road CM14 4HN Brentwood Essex | British | Uk Controller Ge Energy | 106985300001 | |||||||||
LEWIS, Peter | Geschäftsführer | Mount Cottage Winchester Road SO21 3DG Micheldever Hampshire | British | Sales Director | 87730480002 | |||||||||
RICHARDSON, Paul | Geschäftsführer | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Global Projects Leader | 174494740001 | ||||||||
ROBERTSON, Moria Ann | Geschäftsführer | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire | United Kingdom | British | Director | 203364460001 | ||||||||
SENNETT, Paul Timothy | Geschäftsführer | Omega Park GU34 2QE Alton 3 Hampshire United Kingdom | England | British | None | 174484310001 | ||||||||
STEEL, Andrew Charles | Geschäftsführer | 9 Clumps Road Lower Bourne GU10 3HF Farnham Surrey | England | British | Managing Director | 33164070002 | ||||||||
WAKE, Hilary Anne, Mrs. | Geschäftsführer | Downshire Way RG12 1PU Bracknell The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tax Manager | 96648390001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric Uk Holdings Ltd. | 03. Mai 2022 | Harry Kerr Drive ST16 1WT Stafford St Leonards Building Staffordshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Ge Energy Services (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
29. Nov. 2016 | 01. Dez. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat ALTAIR FILTER TECHNOLOGY LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2003 Geliefert am 07. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Gurantee & debenture | Erstellt am 21. Sept. 1989 Geliefert am 02. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Sept. 1989 Geliefert am 02. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 3 omega park, wilson road, alton, hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 21. Sept. 1989 Geliefert am 25. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from appfire limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 1987 Geliefert am 01. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the property k/a cherry st. Woking surrey T.N.'s sy- 437983 & sy 479922. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 1987 Geliefert am 20. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a plot 3 omega park alton hampshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Nov. 1986 Geliefert am 04. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the south east of cherry street, woking, surrey, t/no. Sy 479922. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 01. Feb. 1986 Geliefert am 04. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Juni 1985 Geliefert am 12. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Nov. 1983 Geliefert am 24. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the S.E. of cherry st., Woking, surrey. Title no. Sy 479922. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Nov. 1983 Geliefert am 24. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & building lying to the east of cherry street, woking, surrey title no. Sy 437983. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Aug. 1983 Geliefert am 01. Sept. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0