DIXON VEHICLE SALES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DIXON VEHICLE SALES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00882224 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CARNELL MOTOR GROUP LIMITED | 27. Juni 1966 | 27. Juni 1966 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Princes Street London EC2R 8BP England zum 250 Bishopsgate London EC2M 4AA am 04. Nov. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Natwest Group Secretarial Services Limited am 03. Aug. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mark Stevens am 27. Aug. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gary Moore am 27. Aug. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Lombard North Central Plc as a person with significant control on 25. Nov. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rbs Secretarial Services Limited am 16. Sept. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Princes Street London EC2R 8PB zum 1 Princes Street London EC2R 8BP am 07. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mark Stevens als Direktor am 30. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Sally Jane Sutherland als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||
Notification of Lombard North Central Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Gary Moore als Direktor am 01. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew James Nicholson als Geschäftsführer am 31. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| MOORE, Gary | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Scotland | British | 247794910001 | |||||||||
| STEVENS, Mark | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 262912910001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Sekretär | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| CUTHBERTSON, Garry | Sekretär | 8 Croft Park HU14 3JX North Ferriby North Humberside | British | 54577250002 | ||||||||||
| FRANKS, Ian Charles | Sekretär | 89 Swanland Road HU13 0NS Hessle North Humberside | British | 71584820001 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Sekretär | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 34423910002 | ||||||||||
| POTTER, Stephen John | Sekretär | 120 Bromham Road Biddenham MK40 4AH Bedford | British | 104934960001 | ||||||||||
| REAH, Raymond | Sekretär | Gillrae 28 Willow Glen Branton DN3 3JD Doncaster South Yorkshire | British | 16687160001 | ||||||||||
| RUSSELL, Christine Anne | Sekretär | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 164016450001 | |||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Sekretär | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
| BOWLER, Peter Martin | Geschäftsführer | 8 Blenheim Rise Bawtry DN10 6SF Doncaster South Yorkshire | British | 75280390002 | ||||||||||
| BRUSHFIELD, Jocelyn Nadauld | Geschäftsführer | Princes Street EC2R 8PB London 1 | England | British | 160922120001 | |||||||||
| CARNELL, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 21 Queensgate HG1 5RQ Harrogate North Yorkshire | British | 81113960001 | ||||||||||
| CARNELL, Martyn Dennis | Geschäftsführer | The Old Vicarage Church Street Everton DN10 5BB Doncaster South Yorkshire | British | 11237330001 | ||||||||||
| CARNELL, Paul James | Geschäftsführer | 34 Warnington Drive Bessacarr DN4 6SU Doncaster South Yorkshire | British | 11237310001 | ||||||||||
| CARTLEDGE, David Edmund | Geschäftsführer | Raines Lodge Greenway CM13 2NR Brentwood Essex | British | 38897330001 | ||||||||||
| CUTHBERTSON, Garry | Geschäftsführer | 8 Croft Park HU14 3JX North Ferriby North Humberside | England | British | 54577250002 | |||||||||
| DIXON, Paul William Henry | Geschäftsführer | Mill Estate Hotham YO43 4UG Hotham Yorkshire | United Kingdom | British | 153357310001 | |||||||||
| DIXON, Simon Timothy | Geschäftsführer | Main Street Hotham YO43 4UF York St Oswaleds House North Yorkshire | United Kingdom | British | 101291990002 | |||||||||
| HOPKINS, Richard James | Geschäftsführer | Flat 4 Kings View Court 115 Ridgway Wimbledon SW19 4RW London | England | British | 92378040002 | |||||||||
| JACKSON, James Anthony | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 4AA London, 280 England | England | British | 154943750001 | |||||||||
| LAMBERT, Mark Andrew | Geschäftsführer | Owls Castle Cottage Hog Hole Lane, Lamberhurst TN3 8BN Tunbridge Wells | England | British | 150167790001 | |||||||||
| LEWIS, Derek John | Geschäftsführer | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | England | British | 34423910002 | |||||||||
| MACARTHUR, Neil Clark | Geschäftsführer | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | United Kingdom | British | 81529340002 | |||||||||
| NICHOLSON, Andrew James | Geschäftsführer | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 163664680002 | |||||||||
| PEPPARD, Anthony Edward | Geschäftsführer | 63 Green Lane Paddock Wood TN12 6BF Tonbridge Kent | Irish | 76520410001 | ||||||||||
| POTTER, Stephen John | Geschäftsführer | 120 Bromham Road Biddenham MK40 4AH Bedford | England | British | 104934960001 | |||||||||
| RAMANATHAN, Shankar | Geschäftsführer | Mowson Hollow Worrall S35 0AD Sheffield 3 South Yorkshire | England | British | 125663610001 | |||||||||
| REAH, Raymond | Geschäftsführer | Gillrae 28 Willow Glen Branton DN3 3JD Doncaster South Yorkshire | British | 16687160001 | ||||||||||
| SHIRLEY, Victor Frederick | Geschäftsführer | 1 Norman Road Hatfield DN7 6AF Doncaster South Yorkshire | British | 43337920001 | ||||||||||
| STANWORTH, Mark | Geschäftsführer | 45 Park Avenue Shelley HD8 8JY Huddersfield | United Kingdom | British | 67885350001 | |||||||||
| STEWART, Gary Robert Mcneilly | Geschäftsführer | Burnbrae Avenue EH12 8AU Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | 128173150002 | |||||||||
| SUTHERLAND, Sally Jane | Geschäftsführer | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 166757310001 | |||||||||
| TEALE, Andrew Richard | Geschäftsführer | 98 The Stray Littlewold Lane HU15 2AL South Cave North Humberside | British | 75058100001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIXON VEHICLE SALES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard North Central Plc | 06. Apr. 2016 | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DIXON VEHICLE SALES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture between dixon motors PLC certain of its subsidiaries (including the company) and the royal bank of scotland PLC as security agent and trustee for the lenders (as defined) | Erstellt am 01. Feb. 1999 Geliefert am 03. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each designated finance document (as defined) and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south side of market street grimsby t/no: HS199863; f/h land k/a 271-291 bury new road and 8, 10 and 12 hilton street salford t/no: GM118716; f/h land k/a 206-206(a) great clowes street salford t/no: LA70372. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 21. Aug. 1997 Geliefert am 09. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) due or to become due from the company to the chargee and to each lender (as defined) under each designated finance document (as defined) | |
Kurze Angaben All of the property listed in schedule 2 to the debenture and/or in the schedule to the deed of accession .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of sub-leasing agreements | Erstellt am 21. Mai 1997 Geliefert am 22. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company in sub leases now made or hereafter to be made by the company in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements now or hereafter made between the chargee and the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Mai 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Showroom and garage premises at park road glasshoughton castleford west yorkshire with all fixtures and fittings plant and machinery and with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1994 Geliefert am 10. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben Land east of low lane leeds west yoks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Mai 1994 Geliefert am 21. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms off the deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All monies owing to the company in respect of refunds paid by way of deposit on the acquistion of motor vehicles on a consignment basis. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Feb. 1994 Geliefert am 04. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture (as defined therein) | |
Kurze Angaben All monies from time to time owing to the company by V.A.G. (united kingdom) in respect of refunds and monies paid by way of deposit on acquisition of motor vehicles. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Jan. 1994 Geliefert am 12. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to south west of marshgate doncaster south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Okt. 1993 Geliefert am 11. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over land and buildings lying to the south west of marshgate doncaster south yorkshire and with all fixtures and fittings other than trade fixtures and fittings together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 17. Mai 1993 Geliefert am 18. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All new and usedr cars car-derived vans and light commercial vehicles and all the dealers right title and interest under the dealer agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 1992 Geliefert am 23. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Car park area marshgate doncaster southgate. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 1992 Geliefert am 23. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Warehouse and front area marshgate motors showroom. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 1992 Geliefert am 23. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Main showroom and adjacent display area marshgate motors showroom doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Mai 1992 Geliefert am 14. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 5,7,9,11,13,15,17,19,21,bethel road rotherham S. yorks.with f/h land at fitzwilliam road rotherham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Sept. 1990 Geliefert am 20. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of charge | |
Kurze Angaben All monies from time to time owing to the company in respect of refunds of monies paid by way of deposit acquisition of motor vehicles on a consignment basis (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 07. Sept. 1989 Geliefert am 11. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under trustees of the charge | |
Kurze Angaben All new and unused cars, car-derived vans and light commercial vehicles manufactured by S.A. automobiles citroen (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1989 Geliefert am 09. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H plot of land to the south east side of thorne road doncaster south yorkshire of approx 1.3 acres. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. Juni 1986 Geliefert am 02. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the charger's interest (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 09. Nov. 1984 Geliefert am 22. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or carnell motor group (alwoodley) limited and/or carnell motor group (horsforth) limited and/or humberside motor cycle centres limited to the chargee supplemental to a debenture dated 3RD january 1972 | |
Kurze Angaben All the property comprised in the debenture dated 3RD january 1972 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures) (see form doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Dez. 1983 Geliefert am 29. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H plot of land containing approximately 2.1 acres situate at 125 low road horsforth near leeds in the conty of west yorkshire title no: wyk 174486.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1983 Geliefert am 29. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H plot of land containing approximately 1.4 acres situate at harrogate road, alwoodley leeds in the county of south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 1981 Geliefert am 27. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H 34, warnington drive bessacarr, doncaster, S. yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture mortgage debenture | Erstellt am 11. März 1981 Geliefert am 14. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a letter dated 3.2.81 | |
Kurze Angaben All these monies which may from time to time be owing to barnell motor group limited by datsun (UK) limited in respect of monies paid by or by direction of the company by way of deposit on the qcquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Feb. 1981 Geliefert am 25. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property being land & buildings situate on the south side of george street wakefield west yorkshire title no wyk 70253. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Feb. 1981 Geliefert am 17. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land (approx 1.27 acres) situate on the marshgate industrial estate, doncaster, south yorkshire, together with all buildings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0