GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED

GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00882788
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor Westfield House
    S1 3FZ 60 Charter Row
    Sheffield
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LOCAT LIMITED04. Nov. 199204. Nov. 1992
    KARMA INDUSTRIES LIMITED01. Mai 199101. Mai 1991
    GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED04. Juli 196604. Juli 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    16 SeitenLIQ13

    Erfüllung der Belastung 008827880010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2022

    6 SeitenAA

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bradshaw Works Swinston Hill Road Dinnington Sheffield S25 2RY zum 3rd Floor Westfield House 60 Charter Row Sheffield S1 3FZ am 18. Apr. 2023

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. März 2023

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    7 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STATON, Trevor
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    Sekretär
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    BritishEngineer16526030001
    GRAY, Julian
    Briersoak Barn
    Briers House Lane, Dungworth, Nr Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Briersoak Barn
    Briers House Lane, Dungworth, Nr Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer112961150001
    STATON, Trevor
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishEngineer16526030001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    MCCLURE, Sallie Jane
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    British42907450001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Sekretär
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Secretary3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Geschäftsführer
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    BritishChairman18247670001
    CLARKSON, Anthony George
    50 Woodstock Road
    S75 1DX Barnsley
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    50 Woodstock Road
    S75 1DX Barnsley
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director42906860001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector1525670001
    DAY, Alan Raymond
    Stenton Farm
    50 High Street, Laughton
    S25 1YF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stenton Farm
    50 High Street, Laughton
    S25 1YF Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director42907340002
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector2055530001
    GARSIDE, Garry
    21 School Lane
    Stainton
    S66 7QX Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 School Lane
    Stainton
    S66 7QX Rotherham
    South Yorkshire
    BritishCompany Director42907360001
    HINCHCLIFFE, Alan
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    Geschäftsführer
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    EnglandBritishDirector86931130002
    MCCLURE, Jeffrey Turner
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector42906710001
    MCCLURE, Jeffrey Turner
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Orchard Cottage
    Lindrick Common
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishManager42906710001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Secretary3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector42825970001
    WRIGHT, Stephen Michael
    98 Deerlands Road
    Wingerworth
    S42 6XA Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    98 Deerlands Road
    Wingerworth
    S42 6XA Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishEngineer112961140001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Julian Gray
    Briers House Lane
    Dungworth, Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    Briersoak Barn
    England
    01. Feb. 2017
    Briers House Lane
    Dungworth, Bradfield
    S6 6HD Sheffield
    Briersoak Barn
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Trevor Staton
    Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    19
    England
    01. Feb. 2017
    Stafford Drive
    S60 3DQ Rotherham
    19
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Tjs Holdings Ltd
    Swinston Hill Road
    Dinnington
    S25 2RY Sheffield
    Bradshaw Works
    England
    01. Feb. 2017
    Swinston Hill Road
    Dinnington
    S25 2RY Sheffield
    Bradshaw Works
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer05823840
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 14. Jan. 2016
    Geliefert am 15. Jan. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A fixed and floating charge over all assets.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Nov. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2010
    Geliefert am 31. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Feb. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 2009
    Geliefert am 10. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or tjs holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land and buildings on the south east side of first lane harry crofts south anston rotherham south yorkshire t/n SYK371323.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Feb. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2009
    Geliefert am 01. Okt. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 29. März 1995
    Geliefert am 01. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 11. Okt. 1993
    Geliefert am 13. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 20/03/90
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 1990
    Geliefert am 05. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 15. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. März 1990
    Geliefert am 26. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 15. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. März 2023Beginn der Liquidation
    23. Feb. 2024Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kris Anthony Wigfield
    3rd Floor Wakefield House Charter Row
    Number 60
    S1 3FZ Sheffield
    South Yorkshire
    Praktiker
    3rd Floor Wakefield House Charter Row
    Number 60
    S1 3FZ Sheffield
    South Yorkshire
    Philip David Nunney
    3rd Floor Westfield House
    60 Charter Row
    S1 3FZ Sheffield
    Praktiker
    3rd Floor Westfield House
    60 Charter Row
    S1 3FZ Sheffield

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0