GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00882788 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor Westfield House S1 3FZ 60 Charter Row Sheffield |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LOCAT LIMITED | 04. Nov. 1992 | 04. Nov. 1992 |
KARMA INDUSTRIES LIMITED | 01. Mai 1991 | 01. Mai 1991 |
GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED | 04. Juli 1966 | 04. Juli 1966 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 008827880010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bradshaw Works Swinston Hill Road Dinnington Sheffield S25 2RY zum 3rd Floor Westfield House 60 Charter Row Sheffield S1 3FZ am 18. Apr. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATON, Trevor | Sekretär | 19 Stafford Drive S60 3DQ Rotherham South Yorkshire | British | Engineer | 16526030001 | |||||
GRAY, Julian | Geschäftsführer | Briersoak Barn Briers House Lane, Dungworth, Nr Bradfield S6 6HD Sheffield South Yorkshire | England | British | Engineer | 112961150001 | ||||
STATON, Trevor | Geschäftsführer | 19 Stafford Drive S60 3DQ Rotherham South Yorkshire | England | British | Engineer | 16526030001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Sekretär | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
MCCLURE, Sallie Jane | Sekretär | Orchard Cottage Lindrick Common S81 8BA Worksop Nottinghamshire | British | 42907450001 | ||||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Sekretär | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Company Secretary | 3801050001 | |||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Geschäftsführer | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
CLARKSON, Anthony George | Geschäftsführer | 50 Woodstock Road S75 1DX Barnsley South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 42906860001 | ||||
CLEARY, Michael John | Geschäftsführer | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
DAY, Alan Raymond | Geschäftsführer | Stenton Farm 50 High Street, Laughton S25 1YF Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 42907340002 | |||||
EDGE, Geoffrey | Geschäftsführer | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | Director | 2055530001 | |||||
GARSIDE, Garry | Geschäftsführer | 21 School Lane Stainton S66 7QX Rotherham South Yorkshire | British | Company Director | 42907360001 | |||||
HINCHCLIFFE, Alan | Geschäftsführer | Manor Cottage Tapton S43 1QQ Chesterfield | England | British | Director | 86931130002 | ||||
MCCLURE, Jeffrey Turner | Geschäftsführer | Orchard Cottage Lindrick Common S81 8BA Worksop Nottinghamshire | England | British | Director | 42906710001 | ||||
MCCLURE, Jeffrey Turner | Geschäftsführer | Orchard Cottage Lindrick Common S81 8BA Worksop Nottinghamshire | England | British | Manager | 42906710001 | ||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Geschäftsführer | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Company Secretary | 3801050001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Geschäftsführer | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 | ||||
WRIGHT, Stephen Michael | Geschäftsführer | 98 Deerlands Road Wingerworth S42 6XA Chesterfield Derbyshire | United Kingdom | British | Engineer | 112961140001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Julian Gray | 01. Feb. 2017 | Briers House Lane Dungworth, Bradfield S6 6HD Sheffield Briersoak Barn England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Trevor Staton | 01. Feb. 2017 | Stafford Drive S60 3DQ Rotherham 19 England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Tjs Holdings Ltd | 01. Feb. 2017 | Swinston Hill Road Dinnington S25 2RY Sheffield Bradshaw Works England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 14. Jan. 2016 Geliefert am 15. Jan. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed and floating charge over all assets. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Dez. 2010 Geliefert am 31. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 2009 Geliefert am 10. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or tjs holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land and buildings on the south east side of first lane harry crofts south anston rotherham south yorkshire t/n SYK371323. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Sept. 2009 Geliefert am 01. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Okt. 2006 Geliefert am 07. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Okt. 2006 Geliefert am 07. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a harry crofts works first lane south anston sheffield south yorkshire t/no SYK371323. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 29. März 1995 Geliefert am 01. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 11. Okt. 1993 Geliefert am 13. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 20/03/90 | |
Kurze Angaben Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Okt. 1990 Geliefert am 05. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 20. März 1990 Geliefert am 26. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat GEORGE JOHNSON REFRACTORIES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0