FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED

FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00884786
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Towergate House Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOWERGATE SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED19. Jan. 200119. Jan. 2001
    BRIAN SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED17. März 198617. März 1986
    BRIAN SHARP INSURANCE SERVICES LIMITED08. Okt. 198508. Okt. 1985
    BRIAN SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED31. Dez. 198131. Dez. 1981
    BRIAN SHARP (LIFE AND PENSIONS) LIMITED03. Aug. 196603. Aug. 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA
    A5Y1JMD4

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    L1NAFVXF

    Beendigung der Bestellung von Andrew Charles Homer als Geschäftsführer am 29. Nov. 2012

    1 SeitenTM01
    X1MRQIR7

    Beendigung der Bestellung von Peter Geoffrey Cullum als Geschäftsführer am 29. Nov. 2012

    1 SeitenTM01
    X1MRQIE9

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Okt. 2012

    Kapitalaufstellung am 29. Okt. 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    X1KC0WNE

    Ernennung von Mr Mark Steven Hodges als Direktor am 17. Sept. 2012

    2 SeitenAP01
    X1HTJ39T

    Beendigung der Bestellung von Timothy Duncan Philip als Geschäftsführer am 30. Juni 2012

    1 SeitenTM01
    X1CDVYZ7

    Ernennung von Mr Scott Egan als Direktor am 19. Apr. 2012

    2 SeitenAP01
    X19G7KQ9

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XC3CSZ9O

    Beendigung der Bestellung von Andrew Hunter als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XATZLW5L

    Ernennung von Mr Samuel Thomas Budgen Clark als Sekretär

    1 SeitenAP03
    XATXRW5P

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA
    ARLBYW1S

    Ernennung von Mr Andrew Stewart Hunter als Sekretär

    1 SeitenAP03
    XCYJDQE7

    Beendigung der Bestellung von Darryl Clark als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XCYIQQEJ

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XWJKMOY4

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA
    AYECDM1Y

    Beendigung der Bestellung von Timothy Craton als Sekretär

    1 SeitenTM02
    XTTZZLIK

    Ernennung von Mr Darryl Clark als Sekretär

    1 SeitenAP03
    XTU0LLI8

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XX72FEPL

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Geoffrey Cullum am 05. Nov. 2009

    2 SeitenCH01
    XX72CEPI

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Timothy Charles Craton am 05. Nov. 2009

    1 SeitenCH03
    XX72BEPH

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Duncan Philip am 05. Nov. 2009

    2 SeitenCH01
    XX72EEPK

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Charles Homer am 05. Nov. 2009

    2 SeitenCH01
    XX72DEPJ

    Wer sind die Geschäftsführer von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    161870200001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector58444370003
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Sekretär
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    152540990001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Sekretär
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Sekretär
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    BritishInsurance99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    156624970001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Sekretär
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    BritishSolicitor6180280001
    SHARP, Jean Marie
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Sekretär
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    British18202050001
    CREWE, Joanne Lesley
    22 Saint Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    22 Saint Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    BritishFinancial Adviser64886370001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Geschäftsführer
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    BritishInsurance60697560014
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishInsurance59873490009
    DOWSETT, Susan Ann
    113 Noak Hill Road
    CM12 9UJ Billericay
    Essex
    Geschäftsführer
    113 Noak Hill Road
    CM12 9UJ Billericay
    Essex
    BritishDirector24382120002
    DREWE, Elizabeth Jean
    39 Queen Court
    Queen Square
    WC1N 3BB London
    Geschäftsführer
    39 Queen Court
    Queen Square
    WC1N 3BB London
    BritishSurgeon44387510001
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Geschäftsführer
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritishInsurance99424380001
    HOMER, Andrew Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    EnglandBritishInsurance13483140003
    LYONS, Derek George William
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    30 Downleaze
    South Woodham Ferrers
    CM3 5SN Chelmsford
    Essex
    EnglandIrishInsurance Broker20310970001
    MACIVER, Kenneth
    12 Norfolk Heights
    Church Road
    TN1 1JD Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    12 Norfolk Heights
    Church Road
    TN1 1JD Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishInsurance70920700003
    MARSHGREEN, John William
    Marringdean Manor
    Marringdean Road
    RH14 9HF Billingshurst
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Marringdean Manor
    Marringdean Road
    RH14 9HF Billingshurst
    West Sussex
    BritishInsurance Broker6406900004
    MARTIN, Kim Ian
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    Little Dene
    13 Manor Rise
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    EnglandBritishAccountant11165290001
    PEEL, Alan Albert
    500 Upper Brentwood Road
    RM2 6JA Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    500 Upper Brentwood Road
    RM2 6JA Romford
    Essex
    BritishInsurance Broker64886450002
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritishInsurance99066410001
    PROVERBS, Antony
    22 Lodgefield Road
    CT5 3RF Chestfield
    Kent
    Geschäftsführer
    22 Lodgefield Road
    CT5 3RF Chestfield
    Kent
    BritishInsurance79185700001
    SHARP, Brian Stephen
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    BritishInsurance Broker18202060001
    SHARP, Jean Marie
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    13a Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    BritishSecretary18202050001
    WRATHALL, David Martin
    18 Glen Avenue
    CO3 3SD Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    18 Glen Avenue
    CO3 3SD Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector27727740002

    Hat FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank and the hedging bank, and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. Aug. 2001
    Geliefert am 13. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 15. Mai 2001
    Geliefert am 23. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein ("the chargors") to the chargee pursuant to the framework agreement or the charge
    Kurze Angaben
    The assigned rights being all the rights, titles, benefits and interests of the company to the commissions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transaktionen
    • 23. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 07. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Dez. 1998
    Geliefert am 06. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Mezzanine Limited,as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender,the Overdraftbank,the Hedging Bank and the Investors (All Asdefined)
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0