FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00884786 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Towergate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Kent United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TOWERGATE SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED | 19. Jan. 2001 | 19. Jan. 2001 |
BRIAN SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED | 17. März 1986 | 17. März 1986 |
BRIAN SHARP INSURANCE SERVICES LIMITED | 08. Okt. 1985 | 08. Okt. 1985 |
BRIAN SHARP INSURANCE BROKERS LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
BRIAN SHARP (LIFE AND PENSIONS) LIMITED | 03. Aug. 1966 | 03. Aug. 1966 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Charles Homer als Geschäftsführer am 29. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Geoffrey Cullum als Geschäftsführer am 29. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Steven Hodges als Direktor am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Duncan Philip als Geschäftsführer am 30. Juni 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Scott Egan als Direktor am 19. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Hunter als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Samuel Thomas Budgen Clark als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Stewart Hunter als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Darryl Clark als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Craton als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Darryl Clark als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Geoffrey Cullum am 05. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Timothy Charles Craton am 05. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Duncan Philip am 05. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Charles Homer am 05. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 161870200001 | |||||||
EGAN, Scott | Geschäftsführer | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | England | British | Director | 170703910001 | ||||
HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 58444370003 | ||||
ALEXANDER, Peter | Sekretär | 4 Pintail Way Broomfield CT6 7XP Herne Bay Kent | British | 60245740001 | ||||||
CLARK, Darryl | Sekretär | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 152540990001 | |||||||
CRATON, Timothy Charles | Sekretär | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | British | 76055420004 | ||||||
DYER, Paul Francis | Sekretär | The Foxes Eastling Road Ospringe ME13 0RT Faversham Kent | British | Insurance | 99424380001 | |||||
HUNTER, Andrew Stewart | Sekretär | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent United Kingdom | 156624970001 | |||||||
REDDI, John | Sekretär | Farbank 21 First Avenue BN14 9NJ Worthing West Sussex | British | Solicitor | 6180280001 | |||||
SHARP, Jean Marie | Sekretär | 13a Piercing Hill Theydon Bois CM16 7JW Epping Essex | British | 18202050001 | ||||||
CREWE, Joanne Lesley | Geschäftsführer | 22 Saint Albans Road IG8 9EQ Woodford Green Essex | British | Financial Adviser | 64886370001 | |||||
CROCKER, Nicholas John David | Geschäftsführer | The Barn Little Biddenden Green Lewd Lane TN27 8NP Smarden Kent | British | Insurance | 60697560014 | |||||
CULLUM, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | United Kingdom | British | Insurance | 59873490009 | ||||
DOWSETT, Susan Ann | Geschäftsführer | 113 Noak Hill Road CM12 9UJ Billericay Essex | British | Director | 24382120002 | |||||
DREWE, Elizabeth Jean | Geschäftsführer | 39 Queen Court Queen Square WC1N 3BB London | British | Surgeon | 44387510001 | |||||
DYER, Paul Francis | Geschäftsführer | The Foxes Eastling Road Ospringe ME13 0RT Faversham Kent | England | British | Insurance | 99424380001 | ||||
HOMER, Andrew Charles | Geschäftsführer | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | England | British | Insurance | 13483140003 | ||||
LYONS, Derek George William | Geschäftsführer | 30 Downleaze South Woodham Ferrers CM3 5SN Chelmsford Essex | England | Irish | Insurance Broker | 20310970001 | ||||
MACIVER, Kenneth | Geschäftsführer | 12 Norfolk Heights Church Road TN1 1JD Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Insurance | 70920700003 | ||||
MARSHGREEN, John William | Geschäftsführer | Marringdean Manor Marringdean Road RH14 9HF Billingshurst West Sussex | British | Insurance Broker | 6406900004 | |||||
MARTIN, Kim Ian | Geschäftsführer | Little Dene 13 Manor Rise ME14 4DB Maidstone Kent | England | British | Accountant | 11165290001 | ||||
PEEL, Alan Albert | Geschäftsführer | 500 Upper Brentwood Road RM2 6JA Romford Essex | British | Insurance Broker | 64886450002 | |||||
PHILIP, Timothy Duncan | Geschäftsführer | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | United Kingdom | British | Insurance | 99066410001 | ||||
PROVERBS, Antony | Geschäftsführer | 22 Lodgefield Road CT5 3RF Chestfield Kent | British | Insurance | 79185700001 | |||||
SHARP, Brian Stephen | Geschäftsführer | 13a Piercing Hill Theydon Bois CM16 7JW Epping Essex | British | Insurance Broker | 18202060001 | |||||
SHARP, Jean Marie | Geschäftsführer | 13a Piercing Hill Theydon Bois CM16 7JW Epping Essex | British | Secretary | 18202050001 | |||||
WRATHALL, David Martin | Geschäftsführer | 18 Glen Avenue CO3 3SD Colchester Essex | United Kingdom | British | Director | 27727740002 |
Hat FOLGATE SHARP RISK SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Aug. 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank and the hedging bank, and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Aug. 2001 Geliefert am 13. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined) | |
Kurze Angaben (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of legal charge | Erstellt am 15. Mai 2001 Geliefert am 23. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein ("the chargors") to the chargee pursuant to the framework agreement or the charge | |
Kurze Angaben The assigned rights being all the rights, titles, benefits and interests of the company to the commissions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 07. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 18. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0