ABSTRACT 123 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ABSTRACT 123 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00886763 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABSTRACT 123 LIMITED?
- (3210) /
Wo befindet sich ABSTRACT 123 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 490-492 Wallisdown Road BH11 8PU Bournemouth Dorset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABSTRACT 123 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EMD DRIVE SYSTEMS LIMITED | 04. Apr. 2006 | 04. Apr. 2006 |
| THE ELECTRIC MOTOR COMPANY LIMITED | 07. Okt. 1999 | 07. Okt. 1999 |
| CETRONIC LIMITED | 31. Aug. 1966 | 31. Aug. 1966 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABSTRACT 123 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABSTRACT 123 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Justin Levine als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Justin Anthos Colin Levine am 12. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Geoffrey Siggs als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Dyoss als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ABSTRACT 123 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGGS, Stephen Geoffrey | Sekretär | Wallisdown Road BH11 8PU Bournemouth 490-492 Dorset | 148983680001 | |||||||
| SIGGS, Stephen Geoffrey | Geschäftsführer | Stirling Road BH3 7JH Bournemouth 49 Dorset | United Kingdom | British | 134418350001 | |||||
| AMBROSE SMITH, Brian Aubrey | Sekretär | 21 Marlowe Way Lexden CO3 4JP Colchester Essex | British | 569490001 | ||||||
| CARTER, Beryl Ann | Sekretär | Knoll Farm Standon Green End High Cross SG11 1BP Ware Hertfordshire | British | 6279700001 | ||||||
| DYOSS, Peter James | Sekretär | 9 Harbour Watch 391 Sandbanks Road BH14 8JB Poole Dorset | British | 105725380001 | ||||||
| MCDONALD, James | Sekretär | 20 Avenue Road Walkford BH23 5QH Christchurch Dorset | British | 66970160001 | ||||||
| PARKER, Edward Geoffrey | Sekretär | The Homestead 133 Malvern Road WR2 4LN Worcester | British | 37378570013 | ||||||
| POTTER, Stephen Brian, Mr. | Sekretär | 12 Avon Road West Moors BH22 0EG Ferndown Dorset | English | 88179470001 | ||||||
| RICHARDSON, Jonathan Charles | Sekretär | 24 Foxcote Way Walton S42 7NP Chesterfield Derbyshire | British | 118293300001 | ||||||
| SMITH, Simon John | Sekretär | Church View 2-3 Stone Cottages Church Street, Great Maplestead CO9 2RG Halstead Essex | British | 70359030002 | ||||||
| WEARN, Roger Frederick | Sekretär | Wyngar Stakes Hill Road PO7 5UB Waterlooville Hampshire | British | 104899420001 | ||||||
| WHITE, Mark Jonathan | Sekretär | 38 Grange Close Church Road Nascot Wood WD17 4HQ Watford Hertfordshire | British | 82978250001 | ||||||
| ALLEN, Gordon Stanley | Geschäftsführer | 103 Valley Park Drive PO8 0PS Waterlooville Hampshire | British | 67112500001 | ||||||
| AMBROSE SMITH, Brian Aubrey | Geschäftsführer | 21 Marlowe Way Lexden CO3 4JP Colchester Essex | British | 569490001 | ||||||
| ASHBY, Simon Henry | Geschäftsführer | Coronation Cottage Main Road East Boldre SO42 7WU Brockenhurst Hampshire | British | 41770060001 | ||||||
| BARBER, Julian Richard | Geschäftsführer | 3 Mount Temple SO51 5UW Romsey Hampshire | England | British | 103374330003 | |||||
| CARTER, David Patrick | Geschäftsführer | Knoll Farm Standon Green End High Cross SG11 1BP Ware Hertfordshire | British | 6279710001 | ||||||
| CURRY, John James | Geschäftsführer | Brett House 2 Mortlocks Lavenham CO10 9QF Sudbury Suffolk | British | 49740520005 | ||||||
| FERRIER, Derek Neilson | Geschäftsführer | 32 Melrose Road SO15 7PA Southampton Hampshire | England | British | 66914630002 | |||||
| FISCHER, Andrew Olaf | Geschäftsführer | 56 High Street St. Martins PE9 2LA Stamford Lincolnshire | United Kingdom | German | 70312740034 | |||||
| FISHER, Ian | Geschäftsführer | 26 Loudoun Road NW8 0LT London | United Kingdom | British | 51776160030 | |||||
| FLETCHER, Alan Thomas | Geschäftsführer | 14 Fiery Hill Road Barnt Green B45 8LG Birmingham | United Kingdom | British | 14669590002 | |||||
| HANSCOMBE, Peter Robert | Geschäftsführer | 1 Oxford Road CO9 1AZ Halstead Essex | British | 39413300001 | ||||||
| HARTLEY, Simon Andrew | Geschäftsführer | The Farmhouse Finchdean PO8 8AU Portsmouth Hants | British | 16818900001 | ||||||
| HIGGINSON, Andrew John | Geschäftsführer | Hawthorn House Long Road West Dedham CO7 6ES Colchester Essex | British | 74501390001 | ||||||
| HOWELL, Gregory | Geschäftsführer | 242 Panfield Lane CM7 5RH Braintree Essex | England | British | 101218720001 | |||||
| LEVINE, Justin Anthos Colin | Geschäftsführer | Wallisdown Road BH11 8PU Bournemouth 490-492 Dorset | United Kingdom | British | 121019400003 | |||||
| MCDONALD, James | Geschäftsführer | 20 Avenue Road Walkford BH23 5QH Christchurch Dorset | British | 66970160001 | ||||||
| MONK, Brian | Geschäftsführer | Wichita Shoppenhangers Road SL6 2QE Maidenhead Berkshire | British | 19699310001 | ||||||
| OLIVER, David Anthony | Geschäftsführer | 2 Kent Close Brightlingsea CO7 0PZ Colchester Essex | British | 18752880001 | ||||||
| POTTER, Stephen Brian, Mr. | Geschäftsführer | 12 Avon Road West Moors BH22 0EG Ferndown Dorset | United Kingdom | English | 88179470001 | |||||
| RICHARDSON, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 24 Foxcote Way Walton S42 7NP Chesterfield Derbyshire | England | British | 118293300001 | |||||
| ROBERTSON, Alan Charles | Geschäftsführer | Elmton House S80 4LX Elmton Creswell Near Worksop | British | 95758980001 | ||||||
| RUSSELL, Jeremy | Geschäftsführer | 132 Brunel Road SO15 0LR Southampton Hampshire | British | 64515250003 | ||||||
| SMITH, Stephen Anthony | Geschäftsführer | The Tudor House Week St Mary EX22 6UL Holsworthy | United Kingdom | British | 6780200002 |
Hat ABSTRACT 123 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 29. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 13. März 2006 Geliefert am 21. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Apr. 2000 Geliefert am 02. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 1994 Geliefert am 03. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on west side of hoddesdon road st margarets stanstead abbotts ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 01. Juni 1993 Geliefert am 04. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juni 1993 Geliefert am 04. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The spinney hoddesdon road st margarets nr ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 16. Sept. 1985 Geliefert am 27. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge. Over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Nov. 1982 Geliefert am 29. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - unit 5D shefford industrial park, high STREET8 shefford, bedford.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Dez. 1975 Geliefert am 16. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property: office buildings, the spinney, hoddesdon road, st. Margarets, nr. Ware, hertfordshire, described in a convenience dated 1.12.75.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0