ABSTRACT 123 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameABSTRACT 123 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00886763
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ABSTRACT 123 LIMITED?

    • (3210) /

    Wo befindet sich ABSTRACT 123 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    490-492 Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    Dorset
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ABSTRACT 123 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EMD DRIVE SYSTEMS LIMITED04. Apr. 200604. Apr. 2006
    THE ELECTRIC MOTOR COMPANY LIMITED07. Okt. 199907. Okt. 1999
    CETRONIC LIMITED31. Aug. 196631. Aug. 1966

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABSTRACT 123 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ABSTRACT 123 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    19 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Justin Levine als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Feb. 2011

    Kapitalaufstellung am 01. Feb. 2011

    • Kapital: GBP 101,000
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 13. Juli 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    21 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Justin Anthos Colin Levine am 12. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Stephen Geoffrey Siggs als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Peter Dyoss als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von ABSTRACT 123 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SIGGS, Stephen Geoffrey
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    Sekretär
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    148983680001
    SIGGS, Stephen Geoffrey
    Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    49
    Dorset
    Geschäftsführer
    Stirling Road
    BH3 7JH Bournemouth
    49
    Dorset
    United KingdomBritish134418350001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Sekretär
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    British569490001
    CARTER, Beryl Ann
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Sekretär
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British6279700001
    DYOSS, Peter James
    9 Harbour Watch
    391 Sandbanks Road
    BH14 8JB Poole
    Dorset
    Sekretär
    9 Harbour Watch
    391 Sandbanks Road
    BH14 8JB Poole
    Dorset
    British105725380001
    MCDONALD, James
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    Sekretär
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    British66970160001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Sekretär
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    British37378570013
    POTTER, Stephen Brian, Mr.
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    Sekretär
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    English88179470001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    British118293300001
    SMITH, Simon John
    Church View 2-3 Stone Cottages
    Church Street, Great Maplestead
    CO9 2RG Halstead
    Essex
    Sekretär
    Church View 2-3 Stone Cottages
    Church Street, Great Maplestead
    CO9 2RG Halstead
    Essex
    British70359030002
    WEARN, Roger Frederick
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    Sekretär
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    British104899420001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    ALLEN, Gordon Stanley
    103 Valley Park Drive
    PO8 0PS Waterlooville
    Hampshire
    Geschäftsführer
    103 Valley Park Drive
    PO8 0PS Waterlooville
    Hampshire
    British67112500001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    British569490001
    ASHBY, Simon Henry
    Coronation Cottage Main Road
    East Boldre
    SO42 7WU Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Coronation Cottage Main Road
    East Boldre
    SO42 7WU Brockenhurst
    Hampshire
    British41770060001
    BARBER, Julian Richard
    3 Mount Temple
    SO51 5UW Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    3 Mount Temple
    SO51 5UW Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish103374330003
    CARTER, David Patrick
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British6279710001
    CURRY, John James
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    British49740520005
    FERRIER, Derek Neilson
    32 Melrose Road
    SO15 7PA Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    32 Melrose Road
    SO15 7PA Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish66914630002
    FISCHER, Andrew Olaf
    56 High Street
    St. Martins
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    56 High Street
    St. Martins
    PE9 2LA Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomGerman70312740034
    FISHER, Ian
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Geschäftsführer
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    United KingdomBritish51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    14 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    Geschäftsführer
    14 Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    United KingdomBritish14669590002
    HANSCOMBE, Peter Robert
    1 Oxford Road
    CO9 1AZ Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    1 Oxford Road
    CO9 1AZ Halstead
    Essex
    British39413300001
    HARTLEY, Simon Andrew
    The Farmhouse
    Finchdean
    PO8 8AU Portsmouth
    Hants
    Geschäftsführer
    The Farmhouse
    Finchdean
    PO8 8AU Portsmouth
    Hants
    British16818900001
    HIGGINSON, Andrew John
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    British74501390001
    HOWELL, Gregory
    242 Panfield Lane
    CM7 5RH Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    242 Panfield Lane
    CM7 5RH Braintree
    Essex
    EnglandBritish101218720001
    LEVINE, Justin Anthos Colin
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    Geschäftsführer
    Wallisdown Road
    BH11 8PU Bournemouth
    490-492
    Dorset
    United KingdomBritish121019400003
    MCDONALD, James
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    Geschäftsführer
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    British66970160001
    MONK, Brian
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    British19699310001
    OLIVER, David Anthony
    2 Kent Close
    Brightlingsea
    CO7 0PZ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    2 Kent Close
    Brightlingsea
    CO7 0PZ Colchester
    Essex
    British18752880001
    POTTER, Stephen Brian, Mr.
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    Geschäftsführer
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    United KingdomEnglish88179470001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish118293300001
    ROBERTSON, Alan Charles
    Elmton House
    S80 4LX Elmton Creswell
    Near Worksop
    Geschäftsführer
    Elmton House
    S80 4LX Elmton Creswell
    Near Worksop
    British95758980001
    RUSSELL, Jeremy
    132 Brunel Road
    SO15 0LR Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    132 Brunel Road
    SO15 0LR Southampton
    Hampshire
    British64515250003
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Geschäftsführer
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritish6780200002

    Hat ABSTRACT 123 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 13. März 2006
    Geliefert am 21. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 21. Apr. 2000
    Geliefert am 02. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 28. Okt. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 1994
    Geliefert am 03. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on west side of hoddesdon road st margarets stanstead abbotts ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Juni 1993
    Geliefert am 04. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 1993
    Geliefert am 04. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The spinney hoddesdon road st margarets nr ware hertfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Sept. 1985
    Geliefert am 27. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge. Over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 05. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Nov. 1982
    Geliefert am 29. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - unit 5D shefford industrial park, high STREET8 shefford, bedford.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Dez. 1975
    Geliefert am 16. Dez. 1975
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property: office buildings, the spinney, hoddesdon road, st. Margarets, nr. Ware, hertfordshire, described in a convenience dated 1.12.75.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1975Registrierung einer Belastung
    • 05. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0