BAF PRINTERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBAF PRINTERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00887241
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BAF PRINTERS LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich BAF PRINTERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Portland House
    Cross Chancellor Street
    LS6 2TG Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BAF PRINTERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BAF PRINTERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    6 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 17. Juni 2010

    • Kapital: GBP 36,087
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Teresa Smeach Dunbar am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Peter Alan Williams am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für David Alan Woods am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Angela Jane Bond Wallis am 24. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    22 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    24 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    8 Seiten363s

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    6 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von BAF PRINTERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WALLIS, Angela Jane Bond
    Manor Farm House
    Carr Lane, Thorner
    LS14 3EY Leeds
    Yorkshire
    Sekretär
    Manor Farm House
    Carr Lane, Thorner
    LS14 3EY Leeds
    Yorkshire
    British9798110002
    DUNBAR, Teresa Smeach
    16902 Filly Lane
    FOREIGN Odessa
    Fl33556 Florida
    Usa
    Geschäftsführer
    16902 Filly Lane
    FOREIGN Odessa
    Fl33556 Florida
    Usa
    UsaAmerica112311210001
    SIEGEL, Todd
    2003 Gandy Blvd. North
    Suite 800
    33702 St. Petersburg
    Florida
    Usa
    Geschäftsführer
    2003 Gandy Blvd. North
    Suite 800
    33702 St. Petersburg
    Florida
    Usa
    UsaAmerican88873980002
    WALLIS, Angela Jane Bond
    Manor Farm House
    Carr Lane, Thorner
    LS14 3EY Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Manor Farm House
    Carr Lane, Thorner
    LS14 3EY Leeds
    Yorkshire
    EnglandBritish9798110002
    WILLIAMS, Peter Alan
    3 Pall Mall
    Billinge End Road Pleasington
    BB2 6QD Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    3 Pall Mall
    Billinge End Road Pleasington
    BB2 6QD Blackburn
    Lancashire
    United KingdomBritish112311040001
    WOODS, David Alan
    22 Carr Hill Avenue
    Calverley
    LS28 5QG Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    22 Carr Hill Avenue
    Calverley
    LS28 5QG Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritish9798130001
    BOND, Colin Michael George Attwood
    2 Richmondfield Cross
    Barwick In Elmet
    LS15 4HH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Richmondfield Cross
    Barwick In Elmet
    LS15 4HH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish2015230001
    BOND, Doreen
    2 Richmondfield Cross
    Barwick In Elmet
    LS15 4HH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Richmondfield Cross
    Barwick In Elmet
    LS15 4HH Leeds
    West Yorkshire
    British28126590001
    FURNESS, Alan
    51 Darnley Lane
    LS15 9EY Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    51 Darnley Lane
    LS15 9EY Leeds
    Yorkshire
    British9798120001
    FURNESS, Pauline
    51 Darnley Lane
    LS15 9EY Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    51 Darnley Lane
    LS15 9EY Leeds
    West Yorkshire
    British28126600001

    Hat BAF PRINTERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 13. Jan. 1994
    Geliefert am 14. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a portland house cross chancellor street leeds with all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings)plant and machinery together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Apr. 1993
    Geliefert am 28. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1989
    Geliefert am 07. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property situate and k/a land at cross chancellor street leeds, with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Leeds City Council
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Feb. 1989
    Geliefert am 24. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • Tsb England & Wales PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 21. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. März 1987
    Geliefert am 28. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb England & Wales PLC
    Transaktionen
    • 28. März 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Nov. 1984
    Geliefert am 14. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and premises known as portland house chancellor street, leeds, west yorkshire with all fixtures and fittings, plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Deed
    Erstellt am 22. Feb. 1982
    Geliefert am 26. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Deed created by the company for varying the terms of a charge dated 19 nov 1968
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & other debts uncalled capital, buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1982Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0