BRIGHTSEA FREL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRIGHTSEA FREL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00897846
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    F.R.EVANS(LEEDS)LIMITED09. Feb. 196709. Feb. 1967

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 03. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 50,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    16 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2011

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2010

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    16 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    2 Seiten403b

    legacy

    2 Seiten403b

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BRIGHTSEA FREL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135442170001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Sekretär
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    BOTTOMLEY, Simon David
    Fountain House The Walled Garden
    Woolley
    WF4 2JW Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fountain House The Walled Garden
    Woolley
    WF4 2JW Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish66174770001
    CROFT, Simon John
    100 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    100 Hall Lane
    Horsforth
    LS18 5JG Leeds
    West Yorkshire
    British63472210001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Geschäftsführer
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100020003
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HOLLEY, Peter Ian
    1 Coniston Way
    Woodlesford
    LS26 8RR Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Coniston Way
    Woodlesford
    LS26 8RR Leeds
    West Yorkshire
    British62699010001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    PRINGLE, David Anthony
    Sandal Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sandal Parkside
    BD16 4AD Bingley
    West Yorkshire
    British52239350001
    SYERS, Aian Matthew
    No1 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO2 3TB York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    No1 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO2 3TB York
    North Yorkshire
    British65588650001
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat BRIGHTSEA FREL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Tenth supplemental trust deed
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a derwenthaugh industrial estate, gateshead t/no TY388552. F/h property k/a viceroy works, leeds on the north east side of low fields road t/no WYK450296 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Derwenthaugh industrial estate, gateshead t/no TY388552 and viceroy works, leeds t/no WYK450296 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at lancaster park, audax close, clifton moor, york t/n NYK246758 including buildings fixtures and fittings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land at canon house apex way leeds t/n WYK307583 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land at hume house wade lane leeds t/n WYK192637 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the east side of dewsbury road and south side of parkfield street leeds t/nos WYK261704 and WYK123533 the fixtures and fittings the plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings to the north east of armley road leeds t/n WYK421254 and WYK421255, fixtures and fittings, plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Seventh supplemental trust deed
    Erstellt am 21. Okt. 2005
    Geliefert am 07. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a deeside industrial estate,deeside.t/nos WA864223 and CYM166484.all that f/h property k/a redvers house,sheffield.t/n SYK325658.all that f/h property k/a firth court,leeds.t/n WYK561178.(for details of further properties charged please see form 395) together with all buildings,erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Sixth supplemental trust deed
    Erstellt am 14. Juni 2005
    Geliefert am 01. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £100,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a single warehouse unit with ancillary offices at old run road, hunslet t/no WYK653056 and moor road, hunslet t/no WYK547405 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transaktionen
    • 01. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 28. Jan. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a springhead mill, well lane, guiseley, leeds t/no. WYK436492; and f/h land k/a swinderby industrial park, camp road, st hughes, newark t/nos. LL140686 and LL238817 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) f/hold land on north west side of george st,york,north yorkshire; NYK81755; (ii) l/hold land on north west side of kenyon rd,lomeshaye industrial estate,nelson,lancashire; LA565287; (iii) part of f/hold land on the south west side of audax rd,clifton moor,york,north yorkshire; NYK246758; all buildings and fixtures thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fourth supplemental trust deed made between evans of leeds limited (1) f r evans (leeds) limited (2) mulgate investments limited (3) fradley park limited (4) evans homes limited (5) and the law debenture trust corporation P.L.C.(6)
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at dearne mills, darton, barnsley t/n SYK388051, land at springhead mills, well lane, guiseley t/n WYK436492, land at 22-30 new york street and 13-15 harper street, leeds, t/n WYK541898, and land at former leodis works, north west road, leeds, t/ns WYK346534 and YWE69198, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and the benefit of the existing leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants and conditions;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Sept. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 14. März 2003
    Geliefert am 25. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage l/h land being redvers house furnival street sheffield south yorkshire t/no SYK325658.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 2003
    Geliefert am 15. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a mickelthwaite farm boston road wetherby t/n YWE34743 and WE4209.
    Berechtigte Personen
    • Crosby Homes (Yorkshire) Limited
    Transaktionen
    • 15. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 17. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Freehold property capitol house, 10, 12 and 14 infirmary street and 31/33 east parade, leeds, west yorkshire t/n's WYK176561, WYK515923 and WYK625100 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) fittings and fixed plant and machinery and equipment for the time being thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from incumbrances.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 19. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee all the estate and interests of the company in the land together with all buildings and fixtures at any time thereon. F/h land k/a 22-30 (even) new york street and 13 and 15 harper street leeds t/n WYK541898, f/h land k/a 10 manor street leeds t/n WYK529539, f/h land k/a land on the west side of millshaw beeston leeds t/n WYK488274 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 19. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 06. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold land known as apex park, dewsbury road, leeds, t/nos. WYK261704, WYK123533 and WYK185000. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 06. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold land known as land and buildings to the north east of armley road, leeds (also known as albion park) t/no. WYK421255. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 06. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The freehold land and buildings at burley road, leeds t/no. WYK522897 and the leasehold land known as land and buildings at burley road, leeds t/no. WYK522840 and the freehold land known as land on the east side of skippers lane, south bank middlesborough t/nos. CE123760, CE134943, CE132407 and CE134946 for details of further properties charged please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985
    Kurze Angaben
    Land on the south side of audax road clifton moor york t/n-NYK246758 and land on the south east of mill lane t/n-WYK208617 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Aug. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Erstellt am 20. Okt. 2000
    Geliefert am 26. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (or any of them) and/or on any other account whatsoever (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    F/H land on the south west side of audax road clifton moor north yorkshire t/n NYK179182 and land and buildings at dean terrace ryton gateshead tyne and wear t/n TY166262. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself Andthe Beneficiaries
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and deposit
    Erstellt am 18. Jan. 2000
    Geliefert am 20. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    £850,000.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of release and deposit
    Erstellt am 07. Jan. 2000
    Geliefert am 19. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH september 1985 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    £572,500 due or to become due from the company to the chargee.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Deed of release and deposit
    Erstellt am 04. Jan. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds dated 7 april 1988, 1 february 1989, 29 march 1989, 4 december 1992, 23 december 1992, 4 november 1993, 29 september 1994, 17 november 1994, 12 july 1995, 26 september 1995, 20 september 1996, 14 march 1997, 16 july 1997, 18 september 1997, 25 june 1998, 30 october 1998, 30 april 1999, 4 june 1999, 28 june 1999, 30 june 1999, 6 august 1999, 1 october 1999, 7 october 1999, 14 october 1999, 5 november 1999 and 4 january 2000 all of which are supplemental to the trust deed dated 20 september 1985
    Kurze Angaben
    £1,165,000.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0