TDL 2013 REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TDL 2013 REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00902438 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
- Sonstige Verlagsaktivitäten (58190) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THOMSON DIRECTORIES LIMITED | 06. Mai 1994 | 06. Mai 1994 |
| T.I.S. (DIRECTORIES) LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| DIRAG LIMITED | 31. März 1967 | 31. März 1967 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2012 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2013 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 07. Aug. 2016 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 21. Aug. 2016 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 11 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Mai 2016 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 7 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 19 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Jan. 2015 | 19 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator | 13 Seiten | 2.39B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Juli 2014 | 16 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Feb. 2014 | 18 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 10 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 46 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Mitteilung über den Beschluss zur Behandlung von belasteten Vermögenswerten | 6 Seiten | 2.28B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed thomson directories LIMITED\certificate issued on 21/08/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Thomson House, 296 Farnborough Road, Farnborough, Hants, GU14 7NU am 20. Aug. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Ernennung von Mr Vincenzo Santelia als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stefano Collmann als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 59 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TDL 2013 REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFORI, Massimo | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp Lancashire | Italy | Italian | 132342550001 | |||||
| GIURI, Paolo | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp Lancashire | France | Italian | 168980660001 | |||||
| SAHGAL, Gautam Giorgio | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp Lancashire | England | Italian | 137239430002 | |||||
| SANTELIA, Vincenzo | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp Lancashire | Italy | Italian | 175089960001 | |||||
| SCHIAVO, Elio | Geschäftsführer | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester Grant Thornton Uk Llp Lancashire | United Kingdom | Italian | 146826620002 | |||||
| CARUANA, Geraldine Bridget | Sekretär | Thomson House 296 Farnborough Road GU14 7NU Farnborough Hants | British | 66575160003 | ||||||
| DEALTRY, Charles Mark | Sekretär | Woodbury House Churt Road GU10 2NY Churt Surrey | British | 53530940001 | ||||||
| HUDSON, John Garland | Sekretär | 23 Copse Avenue Weybourne GU9 9ED Farnham Surrey | British | 17864590001 | ||||||
| MITCHELL, Gordon Philip | Sekretär | 2 Greystead Park Wrecclesham GU10 4NB Farnham Surrey | British | 62974200001 | ||||||
| RUSSELL, Angela | Sekretär | 75 Ondine Road SE15 4EA London | British | 776080001 | ||||||
| WATSON, Kevin John | Sekretär | Chalk House Dunkirt Lane Abbotts Ann SP11 7BB Andover Hampshire | British | 62572410001 | ||||||
| ALEXANDER WALL, Michael Graeme | Geschäftsführer | 77 Tavistock Road W11 London | British | 111709200001 | ||||||
| BOSWELL, Ralph Henry | Geschäftsführer | 95 Garner Road E17 4HG London | British | 2741160001 | ||||||
| BRUNI, Gian Luca | Geschäftsführer | Leone Pancaldo 98 App 18 FOREIGN Verona 37138 Italy | Italian | 86405510001 | ||||||
| CAPPELLINI, Alberto | Geschäftsführer | Thomson House 296 Farnborough Road GU14 7NU Farnborough Hants | Italy | Italian | 139246330001 | |||||
| CASASSA, Giacomo | Geschäftsführer | Via Cardinal M Fossati Turin 2-10100 Italy | Italian | 111464390001 | ||||||
| COLLMANN, Stefano | Geschäftsführer | Thomson House 296 Farnborough Road GU14 7NU Farnborough Hants | Italy | Italian | 126673700001 | |||||
| DEALTRY, Charles Mark | Geschäftsführer | Woodbury House Churt Road GU10 2NY Churt Surrey | British | 53530940001 | ||||||
| GARTLAND, William Joseph | Geschäftsführer | Abbots Wood Burwood Park 1 Broadwater Road KT12 5DB Walton-On-Thames Surrey | American | 30389460001 | ||||||
| GILL, John Anthony Samuel | Geschäftsführer | Brae Rise Berry Lane Worplesdon GU3 3QF Guildford Surrey | England | British | 13490001 | |||||
| GIURI, Paolo | Geschäftsführer | Via G Medici 26 Turin Italy | Italian | 81983600001 | ||||||
| GOLDSMITH, Michael John | Geschäftsführer | 12 Elainor Road CO3 3RX Colchester Essex | British | 2910860001 | ||||||
| GRAS, Robert William | Geschäftsführer | 3 Cheyne House 18 Chelsea Embankment SW3 4LA London | Us Citizen | 47389780001 | ||||||
| HOLT, Penelope Jane | Geschäftsführer | Thomson House 296 Farnborough Road GU14 7NU Farnborough Hants | United Kingdom | British | 159792430002 | |||||
| HOPSON, Andrew James | Geschäftsführer | Thomson House 296 Farnborough Road GU14 7NU Farnborough Hants | United Kingdom | British | 81235030001 | |||||
| HUDSON, John Garland | Geschäftsführer | 23 Copse Avenue Weybourne GU9 9ED Farnham Surrey | British | 17864590001 | ||||||
| KEMP, John Harvey | Geschäftsführer | Creekside 20 Derwent Close GU9 0DD Farnham Surrey | British | 70382690001 | ||||||
| KIERNAN, Robert | Geschäftsführer | Westwood Burnt Oak Lane Waldron TN21 0NY Heathfield Sussex | British | 82170680001 | ||||||
| KNIGHT, Mark David | Geschäftsführer | The Old Rectory Ightham TN15 9AJ Sevenoaks Kent | Gbr | British | 58674470001 | |||||
| LIST, Gary Chuckna | Geschäftsführer | Glenbrook Cavendish Road KT13 0JX Weybridge Surrey | United States | British,American | 40383190004 | |||||
| MAJOCCHI, Luca | Geschäftsführer | Via Degli Alberoni 13/A Turin Italy | Italian | 112758600001 | ||||||
| MAURI, Ernesto Riccardo | Geschäftsführer | Via Pietro Mascagni , 20 Milan FOREIGN 20122 Italy | Italian | 89646490001 | ||||||
| MITCHELL, Gordon Philip | Geschäftsführer | 2 Greystead Park Wrecclesham GU10 4NB Farnham Surrey | British | 62974200001 | ||||||
| NIGRI, Francesco | Geschäftsführer | V.G. Casalis N 28 Turin 10143 Italy | Italian | 81982440001 | ||||||
| PANCRATZ, Linda | Geschäftsführer | Connaught Four Winds Park Old Avenue St Georges Hill KT13 0QA Weybridge Surrey | American | 53260870001 |
Hat TDL 2013 REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 06. Sept. 2012 Geliefert am 13. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secred parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land being thomson house farnborough road barnborough t/no HP360228 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Sept. 2012 Geliefert am 13. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2010 Geliefert am 09. Feb. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 27. März 2009 Geliefert am 31. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £6,325.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £6,325.00 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juni 2005 Geliefert am 10. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the comapnty to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Jan. 2005 Geliefert am 21. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Juli 1999 Geliefert am 06. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from such charging company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and all monies and liabilities due or to become due from each other company to the chargee and to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First floor premises runnymede house hawthorne road staines; third floor premises 1 bridewell street bristol; ground floor unit 9 castleton court st mellons cardiff. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 04. Juni 1997 Geliefert am 17. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or hopenice limited (now known as tdl group limited) and/or any other group company (as defined therein) to the chargee under the terms of the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed charges over all f/h and l/h property present and future all proceeds of sale thereof, benefit of all licences,all plant and macinery and all rights thereof, all rental monies,all securities, all contracts and policies all goodwill and uncalled capital all intellectual property rights all book and other debts proceeds of all recievables together with floating charge all assets not charged by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 18. Sept. 1987 Geliefert am 21. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all moneys due & to become due from the company and/or dennelly directory limited to the chargee under the terms of a lease dated 28TH nov 86. | |
Kurze Angaben The sums of £14,250 & such greater sum as shall from time to time be equal to six months rent payable under the lease. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TDL 2013 REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0