DRAKE & SCULL PROPERTIES
Überblick
| Unternehmensname | DRAKE & SCULL PROPERTIES |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 00905382 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DRAKE & SCULL PROPERTIES?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 The Crescent KT6 4BN Surbiton Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JWP LEASING LIMITED | 16. Aug. 1993 | 16. Aug. 1993 |
| JWP INFORMATION SERVICES LIMITED | 20. Feb. 1992 | 20. Feb. 1992 |
| BUSINESSLAND (UK) LIMITED | 01. Nov. 1987 | 01. Nov. 1987 |
| GRANADA MICROCOMPUTER SERVICES LIMITED | 25. Jan. 1983 | 25. Jan. 1983 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | GAZ1(A) | |||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Howse als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 1 Thameside Centre, Kew Bridge Road, Kew Bridge, Middlesex, TW8 0HF am 03. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Matthews als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frank Macinnis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony J Guzzi als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DRAKE & SCULL PROPERTIES?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER, Michael Lawrence | Sekretär | 159 Court Lane Dulwich SE21 7EE London | British | 33962790001 | ||||||
| CHANTER, Keith | Geschäftsführer | KT23 | United Kingdom | British | 126079170001 | |||||
| GUZZI, Anthony J | Geschäftsführer | The Crescent KT6 4BN Surbiton 1 Surrey United Kingdom | United States | American | 167510820001 | |||||
| HOWSE, Christopher John | Geschäftsführer | The Crescent KT6 4BN Surbiton 1 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 58746330001 | |||||
| ROUSOU, James | Sekretär | 20 Daws Hill Lane HP11 1PW High Wycombe Buckinghamshire | British | 75634630001 | ||||||
| THACKRAH, Kevin Paul | Sekretär | The Spinney Elm Lane Lower Earley RG6 5UQ Reading Berkshire | British | 46486190001 | ||||||
| BRITTON, Graham | Geschäftsführer | Millstream Lower Peover WA16 9QD Knutsford Cheshire | British | 34559340001 | ||||||
| CRITCHLOW, Norman James | Geschäftsführer | 19 Danehurst Close TW20 9PX Egham Surrey | United Kingdom | British | 67957920001 | |||||
| CROWELL, Robert Jeryl | Geschäftsführer | 115 Warpole Street Dover Massachusetts 02030 Usa | American | 52328890002 | ||||||
| DAVIES, Brian John | Geschäftsführer | 11 Woodlands Glade HP9 1JZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 30176020003 | ||||||
| DAVIS, Martin Kennett | Geschäftsführer | 212 Clive Road West Dulwich SE21 8BS London | United Kingdom | British | 16398050001 | |||||
| DEPHIN, Pierre | Geschäftsführer | 50 Rue De Gometz FOREIGN Bures 91440 France | French | 31603810001 | ||||||
| DWYER, Andrew Thompson | Geschäftsführer | 532 Catitoe Road FOREIGN Bedford New York Usa | American | 16258580001 | ||||||
| GAY, Andrew | Geschäftsführer | Bircham Dyson Bell 50 Broadway SW1H 0BL London | United Kingdom | British | 73774260004 | |||||
| GOSCOMB, Christopher Roderick John | Geschäftsführer | Chichele Cottage 11 Chichele Road RH8 0AE Oxted Surrey | Uk | British | 1610330001 | |||||
| GRENDI, Ernest Walter | Geschäftsführer | 57 Harbor Hill Drive FOREIGN Lloyd Harbor New York 11743 Usa | American | 13328320001 | ||||||
| KORNFELD, Stephen | Geschäftsführer | 17 Chapel Street SW1X 7BY London | British | 35561690002 | ||||||
| MACINNIS, Frank Thomas | Geschäftsführer | 7 Sturges Hollow IRISH Westport Connecticut 06880 Usa | Usa | Canadian | 40058020001 | |||||
| MATTHEWS, John | Geschäftsführer | Springhill Cottage Foxlydiate Lane Webheath B97 5PB Redditch Worcestershire | England | British | 93708330001 | |||||
| MCCHESNEY, Brookes | Geschäftsführer | 1001 Ridder Park Drive FOREIGN San Jose California 95131 Usa | American | 31603800001 | ||||||
| MOORE, Clive Alan | Geschäftsführer | 239 Bedford Hill SW16 1LB London | British | 37447250001 | ||||||
| NORMAN, David Arthur | Geschäftsführer | 16101 Greenwood Road FOREIGN Monte Sereno California 95030 Usa | American | 25351470001 | ||||||
| PAUL, Dennis Kent | Geschäftsführer | 14711 Viekery Place Saratdea California 900700 Usa | American | 31603830001 | ||||||
| ROUSOU, James | Geschäftsführer | 20 Daws Hill Lane HP11 1PW High Wycombe Buckinghamshire | British | 75634630001 | ||||||
| WEST, John Vaughan Chanler | Geschäftsführer | 63 Pasture Road SG6 3LS Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 30124410001 | |||||
| WHALE, Anthony Roger | Geschäftsführer | Hadleigh 8 Beechwood Road HP9 1HP Beaconsfield Buckinghamshire | British | 41878460001 |
Hat DRAKE & SCULL PROPERTIES Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Jan. 2006 Geliefert am 24. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 2002 Geliefert am 07. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns all the plant, machinery, fixtures and fittings now and in the future belonging to the chargor and all right, title and interest of the chargor under any agreements now and in the future relating to the purchase, lease or hire purchase of the same, subject to reassignment on redemption... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 13. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the credit agreement and the company under a guarantee dated 29TH october 1997 | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the east of thurston road, great barton. T/no. SK113189. Redcliffe house, whitehouse street, bedminster. T/no. AV63756 and BL16664. Together with all buildings, fixtures and other fixed plant and machinery. Specific charge all the income and rights relating thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of reaffirmation and accession | Erstellt am 22. Dez. 1998 Geliefert am 07. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers (as therein defined) to the chargee under the credit agreement dated 19 june 1996 and all sums due under a guarantee dated 29 october 1997 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| General debenture | Erstellt am 29. Okt. 1997 Geliefert am 30. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under a credit agreement dated 19TH june 1997 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 03. Apr. 1997 Geliefert am 08. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 29. Okt. 1996 Geliefert am 04. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re jwp leasing LTD gts deposit deal no 86994899. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 11. Okt. 1996 Geliefert am 17. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the "deposit(s)" into charged deposit with barclays bank PLC re:- jwp leasing limited gts deposit deal number :-64754577. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Sept. 1993 Geliefert am 27. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0