BRNE REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRNE REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00910429
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRNE REALISATIONS LIMITED?

    • Herstellung von Schmuck und verwandten Gegenständen (32120) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hollins Mount
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROWN & NEWIRTH LIMITED11. Juli 196711. Juli 1967

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Okt. 2013

    12 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Okt. 2012

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Aug. 2012

    16 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    32 Seiten2.17B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed brown & newirth LIMITED\certificate issued on 21/03/12
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. Feb. 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Elma House Beaconsfield Close Hatfield Hertfordshire AL10 8YG United Kingdom am 14. Feb. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Feb. 2012

    Kapitalaufstellung am 01. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Mr Mark Jason Birchall als Direktor am 24. Dez. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Lazenby als Sekretär am 24. Dez. 2011

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Julie Large als Geschäftsführer am 09. Dez. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Lazenby als Geschäftsführer am 24. Dez. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Sewa Singh Kang als Geschäftsführer am 22. Dez. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    27 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB United Kingdom am 25. Nov. 2011

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr. John Robert Ball als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    10 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRNE REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ASHTON, Simon Mark
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritishDirector49915710004
    BALL, John Robert, Mr.
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director160952980001
    BIRCHALL, Mark Jason
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollins Lane
    GL9 8DG Bury
    Hollins Mount
    Lancashire
    EnglandBritishDirector70139540002
    BROWN, Zelma
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    British10810020001
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Sekretär
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    BritishDirector138964960001
    LAZENBY, Simon, Mr.
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    155155810001
    SANDERS, Christopher
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    Sekretär
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    British22630460001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Sekretär
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    BritishFinance Director81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Sekretär
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    BritishAccountant190689780001
    ASHTON, Simon Mark
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector49915710004
    BROWN, Edward Ivor
    2 Aylwards Rise
    HA7 3EH Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Aylwards Rise
    HA7 3EH Stanmore
    Middlesex
    BritishJeweller2770090002
    BROWN, Zelma
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Broadfield Court
    Bushey
    WD2 1JB Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary10810020001
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    BritishDirector138964960001
    HAMLEY, Nicholas Peter, Mr.
    Manton House Farm
    Barton Dean
    SN8 4HB Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Manton House Farm
    Barton Dean
    SN8 4HB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector126433050001
    KANG, Sewa Singh
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandIndianFinance Director135961150001
    LARGE, Julie
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishProduct Development Director157506070001
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector138472720001
    LEVER, Michael Neville
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector12573190001
    POMERANCE, Alex Richard
    18 Folly Close
    WD7 8DR Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Folly Close
    WD7 8DR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director22630450001
    SANDERS, Christopher
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Chester Road
    IG7 6AJ Chigwell
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director22630460001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    BritishFinance Director81186640001
    THOMPSON, Scott
    15 Chapmans Close
    Potton
    SG19 2PL Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    15 Chapmans Close
    Potton
    SG19 2PL Sandy
    Bedfordshire
    BritishIt Director53391290003
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishAccountant190689780001
    WILLIAMS, Gary Stephen
    33 Lee Grove
    IG7 6AD Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    33 Lee Grove
    IG7 6AD Chigwell
    Essex
    EnglandBritishCompany Director22630470002

    Hat BRNE REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2012
    Geliefert am 07. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chrysus Holdco Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Mai 2011
    Geliefert am 06. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Moorgarth Property Investments Limited (Moorgarth)
    Transaktionen
    • 06. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. März 2009
    Geliefert am 21. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Micheal Neville Lever
    Transaktionen
    • 21. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 23. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a peter rosenberg house 11-15 wilmington grove leeds and all other interests in any f/h or l/h property all fixtures and fittings and fixed plant and machinery its goodwill and its uncalled capital its book debts by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Burdale Financial Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal assignment of contract monies
    Erstellt am 02. Feb. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts between the company and hsbc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Erstellt am 30. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 30. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 08. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Juni 2001
    Geliefert am 19. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of security
    Erstellt am 09. Juli 1991
    Geliefert am 19. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 3/7/91.
    Kurze Angaben
    All amounts which are now or may from time to time hereafter be standing to the credit of the company's account with the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 19. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 1990
    Geliefert am 28. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 6 station close, porter bar, hertfordshire. Title no hd 72186.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 08. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 20. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 27 april 1978
    Kurze Angaben
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 03. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Apr. 1978
    Geliefert am 04. Mai 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank LTD
    Transaktionen
    • 04. Mai 1978Registrierung einer Belastung
    • 08. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BRNE REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Feb. 2012Beginn der Verwaltung
    05. Okt. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Malcolm Titley
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Praktiker
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Lancashire
    Andrew Poxon
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    Praktiker
    Hollins Mount Hollins Lane
    BL9 8DG Bury
    2
    DatumTyp
    05. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    22. Apr. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Malcolm Titley
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12,18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Andrew Poxon
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0