LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00910788 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LLOYDS TSB AUTOLEASE (VL) LIMITED | 29. Juli 2002 | 29. Juli 2002 |
| FIRST NATIONAL VEHICLE LEASING LIMITED | 11. Aug. 1997 | 11. Aug. 1997 |
| FREIGHT TRANSPORT LEASING LIMITED | 07. Aug. 1997 | 07. Aug. 1997 |
| FREIGHT TRANSPORT LEASING LIMITED | 14. Juli 1967 | 14. Juli 1967 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 11. Juli 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claude Kwasi Sarfo-Agyare als Geschäftsführer am 16. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed lloyds tsb autolease (vl) LIMITED\certificate issued on 23/09/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Carol Ann Parkes am 10. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Carol Ann Parkes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Francis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare am 24. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| PARKES, Carol Ann | Geschäftsführer | Heathside Park Road SK3 0RB Stockport Heathside Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139996590027 | |||||||||
| FERRIS, Michael James | Sekretär | Zitrey Cox Hill CM6 2HL Great Easton Essex | British | 114444730001 | ||||||||||
| GALVIN, Martin Christopher | Sekretär | 1 Duke Street SK13 8JD Glossop Derbyshire | British | 16555430001 | ||||||||||
| HOPKINS, Stephen John | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 149228480001 | |||||||||||
| PAWSON, Michael Andrew | Sekretär | 14 Laurence Court Woodlesford LS26 8QY Leeds West Yorkshire | British | 8181070001 | ||||||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Sekretär | 25 Gresham Street EC2V 7HN London | Other | 38589290002 | ||||||||||
| SMYTH, Margaret | Sekretär | Swansway Mereside Road, Mere WA16 6QR Knutsford Cheshire | British | 74350280001 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| ABRAMS, Brian | Geschäftsführer | 18 Wentworth Avenue Whitefield M45 7GQ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 16555480001 | |||||||||
| ABRAMS, Eric | Geschäftsführer | 5 Wells Avenue Prestwich M25 0GN Manchester Lancashire | British | 6655950001 | ||||||||||
| ABRAMS, Steven Mark | Geschäftsführer | 33 Delahays Drive Hale WA15 8DR Altrincham Cheshire | British | 16555440001 | ||||||||||
| BARLEY, Michael James | Geschäftsführer | 20 Saint Matthews Avenue KT6 6JJ Surbiton Surrey | United Kingdom | British | 71570430001 | |||||||||
| BLACKWELL, Timothy Mark | Geschäftsführer | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | 124967310001 | |||||||||
| DAVIES, John Lewis | Geschäftsführer | 68 The Plain CM16 6TW Epping Essex | British | 51486560001 | ||||||||||
| FRANCIS, Rick | Geschäftsführer | Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Blake House United Kingdom | England | British | 180380320001 | |||||||||
| GEORGE, Philip Anthony | Geschäftsführer | Foxgloves 32 Hempstead Lane Potten End HP4 2SD Berkhamsted Hertfordshire | British | 25753480001 | ||||||||||
| HOCKEY MORLEY, Gary | Geschäftsführer | 69 Westbury Road HA6 3DA Northwood Middlesex | British | 78595520001 | ||||||||||
| KILBEE, Michael Peter | Geschäftsführer | Wychway Cavendish Road KT13 0JW Weybridge Surrey | British | 19310990002 | ||||||||||
| PATEL, Shashin | Geschäftsführer | 91 Chester Drive HA2 7PX Harrow Middlesex | England | British | 79860270001 | |||||||||
| PAWSON, Michael Andrew | Geschäftsführer | 8 East Ridge View Garforth LS25 2PN Leeds West Yorkshire | British | 8181070002 | ||||||||||
| POTTS, David Keith | Geschäftsführer | 23 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 5774320002 | |||||||||
| SARFO-AGYARE, Claude Kwasi | Geschäftsführer | Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Blake House United Kingdom | United Kingdom | British | 170061790001 | |||||||||
| SCOTT, John Stearn | Geschäftsführer | Three Elms Common Gate Road WD3 5JR Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 7126810001 | |||||||||
| SIMPSON, Martin Edward | Geschäftsführer | 2 Green Lane Timperley WA15 7PF Altrincham Cheshire | British | 64225390001 | ||||||||||
| SMYTH, Margaret | Geschäftsführer | Swansway Mereside Road, Mere WA16 6QR Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 74350280001 | |||||||||
| SMYTH, Michael | Geschäftsführer | Brookdale Brookbottom Riding Gate Harwood BL2 4DL Bolton Lancashire | British | 33134410001 | ||||||||||
| SNARR, Peter David | Geschäftsführer | 80 Grasmere SK11 8PL Macclesfield Cheshire | British | 30021640001 | ||||||||||
| STAPLES, Martin Kenneth | Geschäftsführer | 1 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh Princes Exchange Scotland | Scotland | British | 110383950001 | |||||||||
| STEAD, Nigel Cleator | Geschäftsführer | Northend Timble LS21 2NN Otley West Yorkshire | England | British | 47582470001 | |||||||||
| STUDHOLME, Dennis | Geschäftsführer | Moorlands 89 Chapeltown Road Bromley Cross BL7 9LZ Bolton Lancashire | England | British | 13723760003 | |||||||||
| STURT SCOBIE, James | Geschäftsführer | Hazelhurst Willow Hall Drive HX6 2BL Halifax West Yorkshire | British | 65652830001 | ||||||||||
| TYLDSLEY, William Andrew | Geschäftsführer | Hermosa Troutbeck Close Hawkshaw BL8 4LJ Bury Greater Manchester | United Kingdom | British | 36851690001 | |||||||||
| WHITE, Adrian Patrick | Geschäftsführer | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | 130578200001 |
Hat LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of assignment | Erstellt am 10. Aug. 1994 Geliefert am 11. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest in the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 04. Jan. 1994 Geliefert am 13. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 08. Dez. 1993 Geliefert am 11. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit & interest in & to sub hire agreements & the benefit of all guarantees etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 01. Dez. 1993 Geliefert am 04. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights title and interest in and to sub-hire agreements benefit of all guarantees securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 08. Nov. 1993 Geliefert am 13. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 08. Nov. 1993 Geliefert am 13. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 05. Nov. 1993 Geliefert am 12. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 05. Nov. 1993 Geliefert am 09. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire agreements interim finance documents and the legal charge dated 7TH may 1993 | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in or arising out of the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 07. Okt. 1993 Geliefert am 12. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to the sub-hire agreements made between freight transport leasing limited and bedfordshire county council. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 23. Sept. 1993 Geliefert am 28. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in connection with the agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 06. Sept. 1993 Geliefert am 17. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 12. Aug. 1993 Geliefert am 01. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a purchase agreement dated 22ND march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest present and future in and to the sub hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 12. Aug. 1993 Geliefert am 20. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 27. Juli 1993 Geliefert am 20. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/03/93 | |
Kurze Angaben All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master charge dated 07/05/93 (as defined) | |
Kurze Angaben All its right,title,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise under or arising out of or in respect of the agreements 8339. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 29. Juni 1993 Geliefert am 02. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a master charge dated 7TH may 1993 | |
Kurze Angaben All rights title benefits and interest of the company under or arising out of or in respect of the agreements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 24. Juni 1993 Geliefert am 05. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22 march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements made between the company and bedfordshire county council and the benefit of all guarantees,indemnities,negotiable instruments and securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 23. Juni 1993 Geliefert am 05. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22 march 1993 | |
Kurze Angaben All rights benefit and interest present and future in and to sub-hire agreements made between the company and bedfordshire county council and the benefit of all guarantees,indemnities,negotiable instruments and securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 25. Mai 1993 Geliefert am 04. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 22/3/93 | |
Kurze Angaben All rights benefit & interest in & to the sub hire agreements made between the company & bedfordshire county council & the benefit of all guarantees indemnities & securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over sub-hire agreements | Erstellt am 07. Mai 1993 Geliefert am 24. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the agreements,any interim finance document and any other agreement or arrangement | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all the sub hire agreements details of which sre set out on the schedule attached to form 395 (please see form 395 M53C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge without written instrument | Erstellt am 03. Apr. 1993 Geliefert am 05. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £32,131.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 29/01/89 | |
Kurze Angaben The agreements specified in the schedule to form 395 together with all the company's rights and benefits thereunder and the goods the subjects of the agreements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 08. März 1993 Geliefert am 13. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben All rights title & interest present & future in & to the sub hire agreements (for full details refer to doc M395 ). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 14. Juli 1992 Geliefert am 17. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of agreements entered into and to be entered into between the chargee and the company and all costs charges and expenses incurred by the chargee to enforce any of the provisions of the master assignment dated 08/11/88 | |
Kurze Angaben All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the assignment please refer to form 395 for full details of the property charged. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge agreement | Erstellt am 29. Juni 1992 Geliefert am 30. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements dated 29/06/92 | |
Kurze Angaben A first fixed charge over all rights and interest of the company under hire agreements the vehicles all monies (see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Certificate of assignment | Erstellt am 11. Mai 1992 Geliefert am 12. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to nws 1 under the terms of the agreements entered into from time to time between the company and nws 1 and all costs and charges incurred by nws 1 to enforce the provisions of the master assignment | |
Kurze Angaben All monies due and to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LEX AUTOLEASE (VL) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0