AAH RETAIL PHARMACY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AAH RETAIL PHARMACY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00917620 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LLOYDS PHARMACY LIMITED | 30. Jan. 1998 | 30. Jan. 1998 |
ELLIOTTS PHARMACY LIMITED | 09. Okt. 1967 | 09. Okt. 1967 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Hanns Martin Lipp als Direktor am 21. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thorsten Beer als Geschäftsführer am 21. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 31. März 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 20 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Wendy Margaret Hall als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Shepherd als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Thorsten Beer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Willetts als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Nichola Louise Legg als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Brierley als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGG, Nichola Louise | Sekretär | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
HALL, Wendy Margaret | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | Solicitor | 172979860001 | ||||
LIPP, Hanns Martin | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Finance Director | 220582440001 | ||||
BRIERLEY, Jennifer Anne | Sekretär | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
DAVIES, John Richard Bridge | Sekretär | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
HEATON, Janet Ruth | Sekretär | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
MORDE, Diane | Sekretär | 6 Karen Drive Backwell BS19 3JT Bristol Avon | British | Personal Assistant | 8059410001 | |||||
MURPHY, Francis Joseph | Sekretär | Oakmere Murieston Road WA15 9SU Hale Cheshire | British | 32866430003 | ||||||
SMERDON, Peter | Sekretär | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
STEWART, Brian | Sekretär | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | British | Accountant | 980530001 | |||||
BEER, Thorsten | Geschäftsführer | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Cfo | 172030260001 | ||||
ENGLAND, Philip Nicholas | Geschäftsführer | 5 Park Avenue Peper Harrow Park GU8 6BA Godalming Surrey | British | Marketing Director | 43835770003 | |||||
GREENHALGH, Gary | Geschäftsführer | Washdyke Farm Lincoln Road NG32 3HY Fulbeck Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 1192810001 | ||||
HOOD, John | Geschäftsführer | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | Finance Director | 39644740002 | |||||
KERSHAW, Graham Anthony | Geschäftsführer | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 8991780003 | ||||
MAJOR, Michael Evelyn | Geschäftsführer | 1 Frobisher Gardens GU1 2NT Guildford Surrey | British | Business Development Dir | 31230890001 | |||||
MEISTER, Stefan Mario | Geschäftsführer | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Company Director | 43550520003 | |||||
MISCHKE, Gerhard Viktor | Geschäftsführer | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | Chief Finance Officer | 62107000001 | |||||
ORME, Allan Cameron | Geschäftsführer | Cornerstones Lime Walk Dibden Purlieu SO4 5RB Southampton Hampshire | British | Managing Director | 1271730001 | |||||
ROTHERY, Brian Hilton | Geschäftsführer | 12 Eaves Brow Road Croft WA3 7LF Warrington Cheshire | British | Pharmacist | 12851670001 | |||||
SHEPHERD, William | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | Solicitor | 162873980001 | ||||
SMERDON, Peter | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Company Secretary | 16898700002 | ||||
STEWART, Brian | Geschäftsführer | 12 Fulwell Park Avenue TW2 5HQ Twickenham Middlesex | England | British | Finance Director | 980530001 | ||||
TAYLOR, David Leslie | Geschäftsführer | Woodbank Wilmslow Park SK9 2BA Wilmslow Cheshire | Gb-Eng | British | Pharmacist | 10776940001 | ||||
VIZARD, Ronald Charles, Harold | Geschäftsführer | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Chartered Accountant | 122881190001 | |||||
WICKS, David Frederick | Geschäftsführer | 8 Gloucester Drive Kempshott Rise RG22 4PH Basingstoke Hampshire | British | Director | 1257240001 | |||||
WILLETTS, Andrew John | Geschäftsführer | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Chartered Accountant | 120451550002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AAH RETAIL PHARMACY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admenta Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat AAH RETAIL PHARMACY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1989 Geliefert am 09. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 152 bell hill road st. George, bristol avon, title no av 58555. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1988 Geliefert am 04. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 103 st. Marks road, easton bristol avon, tn bl 22853. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1988 Geliefert am 04. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 182 gloucester road bristol, avon, tn. Av 52666. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 58 whiteladies road cilfton, bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 308 wells road, knowle bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Arch house, victoria square, bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 62 ridingleaze, lawrence weston, bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1988 Geliefert am 27. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 20 north street, bedminster, bristol, avon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Apr. 1988 Geliefert am 20. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 07. Aug. 1987 Geliefert am 20. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 182 gloucester road horfield bristol title no av 52666 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Sept. 1986 Geliefert am 08. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben "Wendover" 112 weston road long ashton, bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 04. Apr. 1985 Geliefert am 17. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1983 Geliefert am 31. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 58 whiteladies road clifton, bristol and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Mai 1982 Geliefert am 13. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as ground floor shop 20 north street bedminster bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. März 1981 Geliefert am 17. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 308 wells road, knowle, bristol.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 22. Dez. 1980 Geliefert am 30. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 62 ridingleaze lawrence weston bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Mai 1980 Geliefert am 29. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H arch house, boyce avenue clifton bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Mai 1980 Geliefert am 29. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H ground floor shop 20 north street bedminster bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Mai 1980 Geliefert am 29. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 58 whiteladies rd clifton bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 20. Juni 1978 Geliefert am 06. Juli 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All payments now due or to become due & payable to elliotts pharmacy LTD by the N.H.S. executive council for avon braches at :- 20 north st., Bedminster bristol. 95 east dundry rd. Whitchurch bristol. 103 st. Marks rd bristol. The arch pharmacy, victoria sq. Bristol. & 58 whiteladies rd., Clifton bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0