LOGICAL COMMERCE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LOGICAL COMMERCE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00919643 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOGICAL COMMERCE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DIAMOND PLATFORMS LIMITED | 08. Nov. 1995 | 08. Nov. 1995 |
EXETER HIRE CENTRE LIMITED | 25. Okt. 1967 | 25. Okt. 1967 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jerome Sarragozi als Sekretär am 30. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN England zum 30 Finsbury Square London EC2P 2YU am 25. Jan. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jerome Sarragozi als Sekretär am 28. Juli 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Andrew Cole als Sekretär am 28. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Donald Thomas Kenny am 24. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Thomas Anthony Murray als Direktor am 01. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Stuart Merrell als Geschäftsführer am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Peter Fish als Geschäftsführer am 28. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 145-157 st. John Street London EC1V 4PY zum 15 Midland Court Central Park Lutterworth Leicestershire LE17 4PN am 31. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Stuart Merrell als Sekretär am 07. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Richard Andrew Cole als Sekretär am 07. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNY, Thomas Donald | Geschäftsführer | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | Irish | Group Ceo | 165677760002 | ||||
MURRAY, Thomas Anthony | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | England | British | Chartered Accountant | 198214500001 | ||||
COLE, Richard Andrew | Sekretär | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | 207374600001 | |||||||
FRANKLIN, Karen Jane | Sekretär | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | Company Director | 24926760001 | |||||
HILL, Percy James Hannaford | Sekretär | 65 Southfield Avenue TQ3 1LQ Paignton Devon | British | 34368290001 | ||||||
MERRELL, Alan Stuart | Sekretär | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | British | Finance Director | 59110640004 | |||||
SARRAGOZI, Jerome | Sekretär | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 236102320001 | |||||||
SHIPMAN, David Cyril | Sekretär | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | Director | 77501360001 | |||||
APPLETON, Kevin Andrew | Geschäftsführer | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | England | British | Company Director | 67821450016 | ||||
BAKER, Austin Philip | Geschäftsführer | 4 Meadowcroft Drive Kingsteignton TQ12 3PB Newton Abbot Devon | British | Regional Manager | 44426070001 | |||||
FISH, Jeremy Peter | Geschäftsführer | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | England | British | Managing Director | 160373640001 | ||||
FRANKLIN, Karen Jane | Geschäftsführer | 189 Marldon Road TQ3 3NB Paignton Devon | British | Office Manager | 24926760001 | |||||
GANSSER-POTTS, Michael David | Geschäftsführer | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire | England | British | Chief Executive | 158445070001 | ||||
GESTETNER, Geoffrey Sigmund | Geschäftsführer | Flat 5 160 Gloucester Terrace W2 6HR London | British | Company Director | 47136960001 | |||||
MCMEEKING, Robert John | Geschäftsführer | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | Company Director | 75448720003 | ||||
MERRELL, Alan Stuart | Geschäftsführer | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | Company Secretary | 59110640004 | ||||
PRICE, David Lawrence | Geschäftsführer | Brook Farm Luddington In Th Brook PE28 0HB Oundle Northamptonshire | British | Company Director | 25187800003 | |||||
SHIPMAN, David Cyril | Geschäftsführer | Church Farm Church Lane DE7 6DE Morley Derbyshire | British | Company Director | 77501360001 | |||||
TANNER, Cecilia Kathleen Bessie | Geschäftsführer | Three Tors Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | Director | 24926770001 | |||||
TANNER, Charles Derek | Geschäftsführer | Three Tors 66 Higher Cadewell Lane Shiphay TQ2 7EX Torquay Devon | British | Managing Director | 79342340001 | |||||
TANNER, Dale Charles | Geschäftsführer | 5 Fair Isle Close Scotts Meadow Barton TQ2 7BT Torquay Devon | British | Area Manager | 43117330002 | |||||
WRIGHT, Andrew John | Geschäftsführer | Midland Court Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Leicestershire England | United Kingdom | British | Director | 122845150001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOGICAL COMMERCE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zooom Holdings (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Central Park LE17 4PN Lutterworth 15 Midland Court Leicestershire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LOGICAL COMMERCE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Erstellt am 08. März 2012 Geliefert am 27. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from an obligor or the obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the security created under the deed is created in favour of the security agent for and on behalf of the secured parties is created over present and future assets of the company is security of the payment and discharge of all the secured obliations see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 18. Nov. 2009 Geliefert am 27. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, shares, dividends, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Sept. 2008 Geliefert am 20. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any one or more of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. März 1999 Geliefert am 20. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 18. Juni 1991 Geliefert am 19. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts except those mentioned above uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Nov. 1989 Geliefert am 29. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Hereditaments and premises being 10 bittern road, sowton industrial estate exeter, devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 17/2/87 | Erstellt am 23. Jan. 1987 Geliefert am 24. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Warehouse premises on the north west side of salterton road, exmouth, devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Aug. 1981 Geliefert am 25. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 27 fore street, exmouth, devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Aug. 1981 Geliefert am 25. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 10 bittern road, sowton industrial estate, exeter, devon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 07. Apr. 1981 Geliefert am 09. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels, plant machinery and items described or referred to in the schedule (see doc M31 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 08. Juli 1977 Geliefert am 28. Juli 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben Shop & dwellinghouse, no 145, pinhoe road, exeter devon, title no dn 59731. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 24. Aug. 1972 Geliefert am 30. Aug. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. | |
Kurze Angaben Floating charge on the undertaking and all property present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 01. Mai 1968 Geliefert am 08. Mai 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc. | |
Kurze Angaben Plots 110 & 111 leadewell estate extension berkeley avenue, torquay. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat LOGICAL COMMERCE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0