NAMARA LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NAMARA LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00920881 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NAMARA LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NAMARA LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Field Court WC1R 5EF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NAMARA LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2020 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2021 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2019 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NAMARA LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 29. Dez. 2021 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 12. Jan. 2022 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 29. Dez. 2020 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für NAMARA LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2023 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2022 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Shepherd Market London W1J 7PP zum 3 Field Court London WC1R 5EF am 23. Aug. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Timothy John Samuel Cochrane als Direktor am 30. Juni 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Naim Ibrahim Attallah als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Maria Attallah als Geschäftsführer am 17. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ramsay Attallah am 22. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Naim Ibrahim Attallah am 22. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maria Attallah am 22. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Timothy John Samuel Cochrane am 22. Juni 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NAMARA LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCHRANE, Timothy John Samuel | Sekretär | Field Court WC1R 5EF London 3 | British | 51304320001 | ||||||
ATTALLAH, Ramsay | Geschäftsführer | Field Court WC1R 5EF London 3 | United Kingdom | British | Marketing Executive | 43350450002 | ||||
COCHRANE, Timothy John Samuel | Geschäftsführer | Field Court WC1R 5EF London 3 | England | British | Accountant | 51304320001 | ||||
ASPREY, John Rolls | Geschäftsführer | 166 New Bond Street W1Y 0AR London | United Kingdom | British | Company Director | 68034280002 | ||||
ATTALLAH, Maria | Geschäftsführer | 25 Shepherd Market London W1J 7PP | United Kingdom | British | Designer | 43350210001 | ||||
ATTALLAH, Naim Ibrahim | Geschäftsführer | 25 Shepherd Market London W1J 7PP | United Kingdom | British | Company Secretary | 25646240001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NAMARA LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Naim Ibrahim Attallah | 29. Dez. 2016 | Field Court WC1R 5EF London 3 | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat NAMARA LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Chattel mortgage | Erstellt am 28. Nov. 2000 Geliefert am 12. Dez. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various chattels including the following "sinbad", "small tiger pictures", "noah's ark", "4 small erotic pictures" etc. please see the form 395 for further details of the chattels charged. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 16. Nov. 2000 Geliefert am 23. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to all chattels listed in schedule to form 395 titled "schedule of fine arts". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 16. Nov. 2000 Geliefert am 23. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Sept. 1998 Geliefert am 02. Okt. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Feb. 1997 Geliefert am 07. März 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 51 beak street london borough of city of westminster t/n-124012. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 1996 Geliefert am 08. Okt. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 45 & 46 poland street l/b of city of westminster tno 82566. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Credit agreement | Erstellt am 04. Aug. 1993 Geliefert am 14. Aug. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £44336.46 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right title & interest in & to all sums payable under the insurance as from time to time varied or extended & the benefit of all powers & remedies. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 15. Aug. 1984 Geliefert am 21. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 51 beak street london W1 title no 124012 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Jan. 1984 Geliefert am 30. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking & all other property & assets present & future in goodwill & book debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Juni 1979 Geliefert am 25. Juni 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 45 and 46 poland street london W1 title no 82566. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 18. Apr. 1978 Geliefert am 05. Mai 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys now due,or hereafter to become due on from time to time accuring due from the company and/or all or any of the companies named therein to messrs coutts & co | |
Kurze Angaben Any monies from time to time standing to the credit of the company with the bank whether on current or deposit a/c. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of set-off | Erstellt am 13. Mai 1977 Geliefert am 01. Juni 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of namara music LTD, namara public relations LTD, namara features LTD, namara entertainments LTD. Namara namara publications, picture wall LTD quartit books LTD the womans pics LTD. Present and future actual or contingent to coutts & co. | |
Kurze Angaben Any monies from time to time standing to the credit of the company with the bank whether on current or deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 13. Mai 1977 Geliefert am 30. Mai 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/hold or l/hold properties for the time being. A specific charge over all stocks, shares or other securities in any subsidiary companies for the time being. A specific charge over all book & other debts for the time being. An assignment of goodwill. A floating charge over its. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 28. Okt. 1974 Geliefert am 14. Nov. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18 wellington court sw 1. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NAMARA LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0