NAMARA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNAMARA LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00920881
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NAMARA LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich NAMARA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Field Court
    WC1R 5EF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NAMARA LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2020
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2021
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2019

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für NAMARA LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis29. Dez. 2021
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung12. Jan. 2022
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis29. Dez. 2020
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für NAMARA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2023

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Aug. 2022

    14 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    5 SeitenNDISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Shepherd Market London W1J 7PP zum 3 Field Court London WC1R 5EF am 23. Aug. 2021

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Aug. 2021

    LRESEX

    Ernennung von Mr Timothy John Samuel Cochrane als Direktor am 30. Juni 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Naim Ibrahim Attallah als Geschäftsführer am 02. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Maria Attallah als Geschäftsführer am 17. Feb. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 21. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 6,527,210
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Ramsay Attallah am 22. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Naim Ibrahim Attallah am 22. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Maria Attallah am 22. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Timothy John Samuel Cochrane am 22. Juni 2015

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von NAMARA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COCHRANE, Timothy John Samuel
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    Sekretär
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    British51304320001
    ATTALLAH, Ramsay
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    Geschäftsführer
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    United KingdomBritishMarketing Executive43350450002
    COCHRANE, Timothy John Samuel
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    Geschäftsführer
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    EnglandBritishAccountant51304320001
    ASPREY, John Rolls
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    Geschäftsführer
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    United KingdomBritishCompany Director68034280002
    ATTALLAH, Maria
    25 Shepherd Market
    London
    W1J 7PP
    Geschäftsführer
    25 Shepherd Market
    London
    W1J 7PP
    United KingdomBritishDesigner43350210001
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    25 Shepherd Market
    London
    W1J 7PP
    Geschäftsführer
    25 Shepherd Market
    London
    W1J 7PP
    United KingdomBritishCompany Secretary25646240001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NAMARA LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Naim Ibrahim Attallah
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    29. Dez. 2016
    Field Court
    WC1R 5EF London
    3
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat NAMARA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2000
    Geliefert am 12. Dez. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various chattels including the following "sinbad", "small tiger pictures", "noah's ark", "4 small erotic pictures" etc. please see the form 395 for further details of the chattels charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Naim Ibrahim Attallah
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 16. Nov. 2000
    Geliefert am 23. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to all chattels listed in schedule to form 395 titled "schedule of fine arts". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 16. Nov. 2000
    Geliefert am 23. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1998
    Geliefert am 02. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 1997
    Geliefert am 07. März 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    51 beak street london borough of city of westminster t/n-124012.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 1996
    Geliefert am 08. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    45 & 46 poland street l/b of city of westminster tno 82566.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Credit agreement
    Erstellt am 04. Aug. 1993
    Geliefert am 14. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £44336.46 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance as from time to time varied or extended & the benefit of all powers & remedies.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Aug. 1984
    Geliefert am 21. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    51 beak street london W1 title no 124012 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bankers
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 1984
    Geliefert am 30. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking & all other property & assets present & future in goodwill & book debts.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bank
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1979
    Geliefert am 25. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    45 and 46 poland street london W1 title no 82566. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 25. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 18. Apr. 1978
    Geliefert am 05. Mai 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys now due,or hereafter to become due on from time to time accuring due from the company and/or all or any of the companies named therein to messrs coutts & co
    Kurze Angaben
    Any monies from time to time standing to the credit of the company with the bank whether on current or deposit a/c.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 05. Mai 1978Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set-off
    Erstellt am 13. Mai 1977
    Geliefert am 01. Juni 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities of namara music LTD, namara public relations LTD, namara features LTD, namara entertainments LTD. Namara namara publications, picture wall LTD quartit books LTD the womans pics LTD. Present and future actual or contingent to coutts & co.
    Kurze Angaben
    Any monies from time to time standing to the credit of the company with the bank whether on current or deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 01. Juni 1977Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Mai 1977
    Geliefert am 30. Mai 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/hold or l/hold properties for the time being. A specific charge over all stocks, shares or other securities in any subsidiary companies for the time being. A specific charge over all book & other debts for the time being. An assignment of goodwill. A floating charge over its. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Coutts and Co
    Transaktionen
    • 30. Mai 1977Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Okt. 1974
    Geliefert am 14. Nov. 1974
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 wellington court sw 1. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Messrs Coutts & Co
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1974Registrierung einer Belastung
    • 19. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NAMARA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Aug. 2021Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Antony Batty
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praktiker
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0