LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00922893 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Station Works Station Road, Long Buckby NN6 7PF Northampton Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PERFORMANCE SAILCRAFT EUROPE LIMITED | 04. Aug. 1983 | 04. Aug. 1983 |
| BROOK SHAW MOTOR SERVICES LIMITED | 20. Nov. 1967 | 20. Nov. 1967 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Nov. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Full Moon Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Full Moon Holdings Limited as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 1 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 5 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 7 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAHANSHAD, Khosrow | Geschäftsführer | 25 Grand Street, Appartment 220 Norwalk Connecticut 06851 | United States | Iranian | 286587250001 | |||||
| ABRAHAMS, Matthew Alan | Sekretär | Station Works Station Road, Long Buckby NN6 7PF Northampton Northamptonshire | 146864650001 | |||||||
| ABRAHAMS, Matthew Alan | Sekretär | 4 Centaine Road NN10 9FH Rushden Northamptonshire | British | 66930220002 | ||||||
| BOWLER, Stephen William | Sekretär | 8 Robinson Way LE10 2EU Burbage Leicestershire | British | 146055040001 | ||||||
| DACRE, Sarah Margaret | Sekretär | 23 Ratcliffe Avenue Branston DE14 3DA Burton-On-Trent Staffordshire | British | 111084580001 | ||||||
| DYER, William Frederick | Sekretär | Toll Brook Westlands Avenue Weston On The Green OX6 8RD Bicester Oxfordshire | British | 13523620001 | ||||||
| JONES, Adrian | Sekretär | Dale End Dale Street Naunton GL54 3AU Cheltenham Gloucestershire | British | 56172190001 | ||||||
| LYNCH, Helen Jean | Sekretär | 14 Douglas Road NN5 6XX Northampton Northamptonshire | British | 75029280001 | ||||||
| SIBLEY, Richard Michael | Sekretär | 11 Grimsbury Green OX16 3JF Banbury Oxfordshire | British | 74649240001 | ||||||
| WEINER, Mark | Sekretär | Kinnaird Peters Lane Whiteleaf HP27 0LQ Princes Risborough Buckinghamshire | British | 75446320002 | ||||||
| BULMAN, Paul | Geschäftsführer | 37 The Rydes Bodicote OX15 4EJ Banbury Oxfordshire | British | 13198210001 | ||||||
| CLUCAS, Ronald | Geschäftsführer | 69 Northampton Road NN12 7AH Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 172957670001 | |||||
| COVENTRY, Timothy William | Geschäftsführer | Rosewarren Cottage Old Church Road Mawnan Smith TR11 5HU Falmouth Cornwall | England | British | 28340300001 | |||||
| FINLAYSON, Alastair Crawford | Geschäftsführer | The Oast House Pristling Lane, Staplehurst TN12 0HH Tonbridge Kent | England | British | 62101500001 | |||||
| GILLAMS, Charles Alfred Richard | Geschäftsführer | Meon House Stratford Road Mickleton GL55 6SU Chipping Campden Gloucestershire | England | British | 9660470003 | |||||
| GRAHAM, David | Geschäftsführer | 8 Manitoba Way Eydon NN11 3PR Northampton Northamptonshire | England | British | 277782070001 | |||||
| HANCOCK, Alan Vivian | Geschäftsführer | Corner Cottage Hannington RG26 5TY Basingstoke Hampshire | British | 13734570001 | ||||||
| JONES, Adrian | Geschäftsführer | Dale End Dale Street Naunton GL54 3AU Cheltenham Gloucestershire | British | 56172190001 | ||||||
| NICHOLS, Christopher Francis | Geschäftsführer | 47 Foxes Way CV34 6AY Warwick Warwickshire | British | 13198240001 | ||||||
| RASTEGAR, Farzad Ali | Geschäftsführer | 125 Main Street Suite 330 Westport Connecticut Ct 06880 Usa | American | 77719170002 | ||||||
| READER, Harvey Charles | Geschäftsführer | 17 Owl End Way Lower Boddington NN11 6YA Daventry Northamptonshire | British | 13198250001 | ||||||
| SIMMONDS, Richard Carlyle | Geschäftsführer | End Cottage West End Wooton OX20 1DL Woodstock Oxfordshire | British | 70460920002 | ||||||
| WEINER, Mark | Geschäftsführer | Kinnaird Peters Lane Whiteleaf HP27 0LQ Princes Risborough Buckinghamshire | England | British | 75446320002 | |||||
| YOUNG, Richard Stanford Kilburn | Geschäftsführer | Little Foxes 3 Gong Hill Drive Lower Bourne GU10 3HG Farnham Surrey | England | British | 575020001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon Holdings Limited | 30. Juni 2017 | Station Works Station Road Long Buckby Station Works Northants United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Full Moon Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Station Road Long Buckby NN6 7PF Northamptonshire Station Works England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LASERPERFORMANCE (EUROPE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Apr. 2007 Geliefert am 27. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Aug. 2006 Geliefert am 02. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over goodwill trade marks and tradenames | Erstellt am 17. Juni 1993 Geliefert am 25. Juni 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge overall trade marks,trade mark applications,trade names and other rights all interests or rights of the company all other goodwill both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 05. Juni 1989 Geliefert am 26. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £280,000 due from gaver securities limited to the chargee on any account whatsoever under a loan agreement dated 5.6.89 and the charge. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 1984 Geliefert am 15. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £316,758 | |
Kurze Angaben F/H land & premises k/a factory on the east side of swan close road, banbury oxford approx 2,093 sq yds equitable charge all the companys estate title or interest in any f/h & l/h property and the proceeds of sale thereof floating charge on all undertaking, property, assets or rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. März 1984 Geliefert am 06. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a or being land & factory premises on the east side of swan close rd.banbury approx. 2.093 square yards formerly k/a laver works comprised in a conveyance date 9.3.84. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juli 1983 Geliefert am 26. Juli 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See doc M40). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0