GEARED SHIPS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGEARED SHIPS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00924055
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GEARED SHIPS LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich GEARED SHIPS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    16 Palace Street
    London
    SW1E 5JQ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GEARED SHIPS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KRISHIP SHIPPING COMPANY LIMITED01. Dez. 196701. Dez. 1967

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEARED SHIPS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für GEARED SHIPS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von GEARED SHIPS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALLINSON, Bernadette
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Sekretär
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Other116264270002
    DALGAARD, Flemming
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomDanish116091010001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Geschäftsführer
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WOOLLACOTT, John Mark
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Australian121666370002
    BEAZLEY, James Henry Tetley
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    Sekretär
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    British41463620001
    BEAZLEY, James Henry Tetley
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    Sekretär
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    British41463620001
    BISHOP, Stephen Michael
    Hill View Grove Heath North
    Ripley
    GU23 6EN Woking
    Surrey
    Sekretär
    Hill View Grove Heath North
    Ripley
    GU23 6EN Woking
    Surrey
    British66704130001
    DAMLE, Sameer Dileep
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    Sekretär
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    British121281830001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Sekretär
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    British30168510002
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Sekretär
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    British10057640001
    REES, Nicholas Haydn Glyndwr
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    Sekretär
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    British115881230001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Sekretär
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    British75631110001
    BEAZLEY, James Henry Tetley
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    Geschäftsführer
    62 Telford Avenue
    SW2 4XF London
    United KingdomBritish41463620001
    BISHOP, Stephen Michael
    Hill View Grove Heath North
    Ripley
    GU23 6EN Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hill View Grove Heath North
    Ripley
    GU23 6EN Woking
    Surrey
    British66704130001
    GRADON, Richard Michael
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish48859920002
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish73770040001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritish8207040001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Geschäftsführer
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    EnglandBritish30168510002
    MONTEITH, Nicholas John
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    British39120850002
    MOORE, Michael Ellis
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    Geschäftsführer
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    American114436710001
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    British10057640001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Geschäftsführer
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    EnglandBritish75631110001
    SHAW, Derek
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    EnglandBritish114437060001
    SHIRREFF, Ian Robert
    Quarry House 49 Oakhill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Quarry House 49 Oakhill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    British23720110001
    TIMMERMANN, Karlheinz Wilhelm
    6 Bracknell Lodge
    Frognal Lane Hampstead
    NW3 7DL London
    Geschäftsführer
    6 Bracknell Lodge
    Frognal Lane Hampstead
    NW3 7DL London
    German13722590001
    WALTERS, Patrick William
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    Geschäftsführer
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    EnglandBritish154424260001

    Hat GEARED SHIPS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed
    Erstellt am 19. Dez. 1990
    Geliefert am 02. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $3,500,000 and all other monies due or to become due from the company to chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    The right, title and interest in the book debts of the company at the date of the deed.
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebson Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 02. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Dez. 1987
    Geliefert am 28. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee assigned from tyling limited under the falcon arrow agreement dated 22.12.87 on an account current and under the terms of a deed of covenant dated 22/12/87
    Kurze Angaben
    64/64 shares on motor vessel "nandu arrow" registered at hong kong no. 384326 see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebson Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 22. Dez. 1987
    Geliefert am 08. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee assigned from tyling limited under the falcon arrow agreement dated 22/12/87 and secured by a charge dated 22/12/87
    Kurze Angaben
    64/64 shares in M.V. "nandu arrow" registered at hong kong no. 384326 see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebson Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    Five party deed
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 21. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the security documents named therein
    Kurze Angaben
    All the companys rights title interest and benefits to in and under a group relief agreement dated 30.9.87 (see 395 M10/22/oct/rn for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of covenant
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 19. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    $16,716,431.16 and all other monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 30.9.87.
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty-fourth shares of and in M.V. "nandu arrow" registered in the name of the company of the part of hong kong. Official no: 384326.
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebson Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Statutory mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 19. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenants dated 30.9.87.
    Kurze Angaben
    Sixty-four sixty-fourth shares of and in M.V. "nandu arrow" registered in the name of the company of the part of hong kong. Official no:- 384326.
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebson Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 30. Sept. 1987
    Geliefert am 19. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee as defined in the sixth statutory mortgage and in the manner and at the times set forth in a deed of covenants d/d 30/9/87 between the company and the mortgagees as the same may ffom time-to-time be amended
    Kurze Angaben
    All the company's rights title, interests and benefits to in and under a group relief agreement dated 30TH september 1987. (see form 395 for further details).
    Berechtigte Personen
    • Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi a/S
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 21. Mai 1987
    Geliefert am 09. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 21 may 1987.
    Kurze Angaben
    All policies and contracts of insurance in respect of M.V."nandu arrow" any credit balance on any of the company's accounts with the mortgage (for detail see form 395 relevant to this charge).
    Berechtigte Personen
    • Snadeforsikring Sselskapet Vesta a/V
    Transaktionen
    • 09. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 21. Mai 1987
    Geliefert am 09. Juni 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant dated 21 may 87.
    Kurze Angaben
    M.V. "nandu arrow" registered under british flag at the port of hong kong under number 384326.
    Berechtigte Personen
    • Snadeforscking Sselskapet Vesta a/S
    Transaktionen
    • 09. Juni 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental deed of covenant
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $3,681,432.75 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28.11.86.
    Kurze Angaben
    The earnings of M.V. "nandu arrow" registered in the name of the company at the port of hong kong under official no 384326.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed of covenant
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    $6,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28.11.86.
    Kurze Angaben
    The earnings of M.V. "nandu arrow" registered is the name of the company at the part of hong kong under official no 384326.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of charge
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    $4,311,432.75 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28.11.86
    Kurze Angaben
    All moneys standing to the credit of accounts no F5531042 and F5531045 by the company with the bank. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limimted
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a deed of charge dated 28.11.86
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the M.V. "nardu arrow" at the port of hong kong under official no 384326.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of charge
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $12,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 28.11.86.
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the accounts with the bank nos. F5531042 and F5531045. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 1986
    Geliefert am 18. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a deed of charge dated 28.11.86.
    Kurze Angaben
    64/64TH shares of and in M. V. "nandu arrow" in the name of the company in the port of hong kong under official no 384326.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage and deed of covenant
    Erstellt am 27. Aug. 1985
    Geliefert am 29. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Us $ 8,000,000 due from the company to the chargee under the terms of a mortgage & deed of covenant d/d 19/10/81 executed in favour of bank of america national trust and savings associations and tranfered by way of endorsement ON27/8/85 in favour of bergen bank a/s
    Kurze Angaben
    "Raven arrow" official no 399426 her boats & appurtenances (see doc M6O for full details).
    Berechtigte Personen
    • Bergen Bank a/S
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    Second priority ship mortgage "b"
    Erstellt am 29. Dez. 1981
    Geliefert am 05. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee an account current under the terms fo a deed of covenant dated 29TH 1981
    Kurze Angaben
    All shares in the motorship raven arrow registered 71 in 1981 at the registry of ships in hong kong; official number 399426.
    Berechtigte Personen
    • Forsikring Saktiesesl Kapet Vesta
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    Deed of covenants
    Erstellt am 29. Dez. 1981
    Geliefert am 05. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with a guarnatee dated 5TH june 1979 between the company and liberian paramount inc., As amended and as may from time to time be amended supplementala to a mortgage dated 29TH december 1881.
    Kurze Angaben
    All shares in the motorship raven arrow registrered 71 in 1981 at the registry of ships in hong kong, official number 399426.
    Berechtigte Personen
    • Forsikring Saktiesels Kapet Vesta
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 19. Okt. 1981
    Geliefert am 11. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 19TH october, 1981 and an agreement dated 29 april, 1981.
    Kurze Angaben
    M. V. raven arrow, official no 399426.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America National Trust and Savings Association
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 19. Okt. 1981
    Geliefert am 11. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current regulated by an ageement dated 29TH april, 1981 and a deed of covenants dated 19TH october, 1981
    Kurze Angaben
    M. V. raven arrow official no. 399426.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America National Trust and Savings Association
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    Deed of covenants
    Erstellt am 13. Mai 1981
    Geliefert am 02. Juni 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a mortgage dated 13-5-81 & a loan agreement dated 29-4-81
    Kurze Angaben
    The vessels & insurances.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America National Trust and Savings Association
    Transaktionen
    • 02. Juni 1981Registrierung einer Belastung
    Ships mortage
    Erstellt am 13. Mai 1981
    Geliefert am 02. Juni 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of an agreement & dated 29.4.81 & deed of covenants dated 13.5.81
    Kurze Angaben
    Vessel tsuru arrow official number 363540.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America National Trust and Savings Associaion
    Transaktionen
    • 02. Juni 1981Registrierung einer Belastung
    Deed of covenant
    Erstellt am 14. Juni 1979
    Geliefert am 28. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing the amount of us $12,000,000 and all amounts which may at any time and from time to time be or become due under the loan agreement dated 7/6/79 and secured by a mortgage dated 14/6/79
    Kurze Angaben
    The mortgage premises (being the ship, the insurances, the earnings of the ship, & requistion compensation).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Statutory mortgage
    Erstellt am 14. Juni 1979
    Geliefert am 28. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to chargee on an account current pursuant to a loan agreement dated 7/6/79 and the deed of covenant dated 14/6/79.
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in M.V. "nandu arrow" registered port of hong kong official no. 384326.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of covenant
    Erstellt am 14. Juni 1979
    Geliefert am 28. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing the amount of us $4,311,432.75 and all amounts which may at any time and from time to time be or become due under the said loan agreement dated 6TH december 1976 as amended and supplemented as aforesaid, the deed of covenant and any other security documents and secured by a mortgage dated 14TH june, 1979
    Kurze Angaben
    M.V. nandu arrow official no. 384326 the insurances, the earnings of the ship and requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0