PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00925483 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Second Avenue Millbrook SO15 0BT Southampton Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PAGE MOTORS (BOURNEMOUTH) LIMITED | 11. Dez. 1984 | 11. Dez. 1984 |
| PAGE MOTORS (WALTON) LIMITED | 04. Jan. 1968 | 04. Jan. 1968 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Jan. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2016 bis 30. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Stephen Snow als Geschäftsführer am 24. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Leslie John Gatrell als Sekretär am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Leslie John Gatrell als Geschäftsführer am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW, Stephen Paul | Geschäftsführer | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows House United Kingdom | England | British | 28250750003 | |||||
| TRAPANI, Mark Anthony | Geschäftsführer | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows House United Kingdom | England | British | 9868400002 | |||||
| GATRELL, Leslie John | Sekretär | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows House | British | 9917790008 | ||||||
| PAGE, Mark Lewis | Sekretär | 7 Moreton Terrace SW1V 2NS London | British | 70181350001 | ||||||
| TAYLOR, Stephen John Douglas | Sekretär | 29 Sutherland Avenue Jacobs Well GU4 7QX Guildford Surrey | British | 3387890001 | ||||||
| BEECH, Jason Mark | Geschäftsführer | 22 Albion Way BH31 7LR Verwood Dorset | England | British | 102773300001 | |||||
| BOYCE, Roger Arthur | Geschäftsführer | Stocks Barn Witchampton Wimborne Dorset | British | 14822610001 | ||||||
| CLARK, Robert Macgillivray | Geschäftsführer | Tansleys Welcomes Road CR8 5HB Kenley Surrey | British | 14224200001 | ||||||
| GATRELL, Leslie John | Geschäftsführer | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows House United Kingdom | United Kingdom | British | 9917790008 | |||||
| MATTHEWS, David | Geschäftsführer | Acacia House Lower Road Charlton All Saints SP5 4HQ Salisbury | British | 14787690002 | ||||||
| PAGE, Richard Lewis | Geschäftsführer | Brook Cottage Gomshall GU5 9NZ Surrey | United Kingdom | British | 52983060001 | |||||
| PAGE, Richard Lewis | Geschäftsführer | Brook Cottage Gomshall GU5 9NZ Surrey | United Kingdom | British | 52983060001 | |||||
| SLATER, Martin | Geschäftsführer | 33 Linnet Road BH17 7TF Poole Dorset | British | 77718930001 | ||||||
| SNOW, Geoffrey Stephen | Geschäftsführer | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows House United Kingdom | United Kingdom | British | 9917800003 | |||||
| TAYLOR, Stephen John Douglas | Geschäftsführer | 29 Sutherland Avenue Jacobs Well GU4 7QX Guildford Surrey | British | 3387890001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snows Business Holdings Limited | 13. Juli 2016 | Second Avenue SO15 0BT Southampton Snows Motor Group England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PAGE MOTORS (FERNDOWN) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Aug. 2006 Geliefert am 01. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 2006 Geliefert am 08. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on vehicle stocks | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 01. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed and floating charge all such of the present and future property and assets including all new and used motor vehicles and all proceeds of sale or other disposition of any motor vehicles and all insurance monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 08. Nov. 2004 Geliefert am 19. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 01. Nov. 2001 Geliefert am 03. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Apr. 2000 Geliefert am 06. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on vehicle stocks | Erstellt am 19. Aug. 1996 Geliefert am 20. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All used motor vehicles. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 22. Sept. 1994 Geliefert am 29. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 28TH july 1981 | |
Kurze Angaben Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 28. Juli 1981 Geliefert am 18. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all bookdebts & other debts floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts excluding those mentioned above uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 22. Sept. 1976 Geliefert am 27. Sept. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys now due or to become due from page motors LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Floating charge see doc (M42) for full details.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1976 Geliefert am 27. Sept. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the page motors LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/Hold land & premises:- 36, 38 and 40 walton st., Walton on the hill, surrey, tog. With all fixtures. See doc (M41) for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge. | Erstellt am 22. Sept. 1976 Geliefert am 27. Sept. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge see doc (M40) for full details.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 1972 Geliefert am 06. Dez. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 36, 38, 40 walton street walton on the hill, surrey. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Aug. 1972 Geliefert am 30. Aug. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 38-40, walton street, walton on the hill, ladworth, surrey. By way of floating charge, all doc. 11 for details. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. März 1968 Geliefert am 02. Apr. 1968 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000 & any other monies due to chargee from the company on account current or stated for goods supplied on otherwise | |
Kurze Angaben 36,38 & 40, walton street, walton-on-the-hill, surrey. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0