WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYCOMBE AIR CENTRE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00928463
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED?

    • (6210) /
    • (6220) /
    • (9261) /

    Wo befindet sich WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o FRP ADVISORY LLP
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2013

    8 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 06. Juni 2013

    28 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Dez. 2012

    1 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Juni 2012

    9 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    20 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Wycombe Air Centre Wycombe Air Park Booker Marlow Buckinghamshire SL7 3DR United Kingdom am 22. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2011

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Simon Andrew Watkins als Sekretär am 24. Okt. 2011

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Andrew Spencer Cruise als Geschäftsführer am 24. Okt. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Andrew Watkins als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Christopher Leigh als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Ernennung von Mr Christopher Michael Leigh als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Read als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew Spencer Cruise als Direktor

    2 SeitenAP01

    legacy

    6 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEYAMI, Shahriar
    Two Ways Avenue Road
    Bray
    SL6 1UG Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Two Ways Avenue Road
    Bray
    SL6 1UG Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishLicensed Aircraft Engineer49765160003
    BRADLY RUSSELL, Michael John
    Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Long Close
    Hertfordshire
    Sekretär
    Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Long Close
    Hertfordshire
    British118662260002
    BRADLY RUSSELL, Michael John
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant118662260002
    GYSELYNCK, Anthony John
    1 Ruperts Close
    RG9 2JD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    1 Ruperts Close
    RG9 2JD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British19806280001
    HUNTER SMART, James Edward
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    152628770001
    PEYAMI, Shahriar
    2 Talbots Drive
    SL6 4LZ Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    2 Talbots Drive
    SL6 4LZ Maidenhead
    Berkshire
    BritishManaging Director49765160001
    READ, Stephen John
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Sekretär
    The Garth
    Welders Lane
    SL9 8TU Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director2897330003
    SARNEY, Amanda Marie
    2 Ivy Place
    Lane End
    HP14 3LQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    2 Ivy Place
    Lane End
    HP14 3LQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishOffice Manager63334170002
    WATKINS, Simon Andrew
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    161636090001
    BIRD, Richard Colin
    Mill Cottage
    73 Friarage Road
    HP20 2SD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Mill Cottage
    73 Friarage Road
    HP20 2SD Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Pilot63329370002
    BRADLY RUSSELL, Michael John
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Lomg
    Close, Great Wymondley
    SG4 7ET Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118662260002
    CRUISE, Andrew Spencer
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector116991450001
    GYSELYNCK, Richard Kim
    Sea Bank Shore Road
    IM9 6HW Port Erin
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Sea Bank Shore Road
    IM9 6HW Port Erin
    Isle Of Man
    EnglandBritishChartered Accountant10338170003
    HENRY, Maurice Charles
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Clonard Way
    HA5 4BT Hatch End
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director91857380001
    HUNTER SMART, James Edward
    Ford
    SP4 6DX Salisbury
    Castleford Farm House
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Ford
    SP4 6DX Salisbury
    Castleford Farm House
    Wiltshire
    United KingdomBritishChartered Accountant18240120003
    HUXTABLE, Nigel
    33 Rectory Close
    Slapton
    LU7 9BZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    33 Rectory Close
    Slapton
    LU7 9BZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishChief Engineer63329310001
    LEIGH, Christopher Michael
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wycombe Air Park
    Booker
    SL7 3DR Marlow
    Wycombe Air Centre
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant24955980002
    NICHOLSON, Alastair George
    2 Stable Close
    OX1 2RF Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    2 Stable Close
    OX1 2RF Oxford
    Oxfordshire
    BritishPensions Consultant8724390003
    READ, Stephen John
    Landmark 14 Seacombe Road
    Sandbanks
    BH13 7RJ Poole
    Flat 8
    Dorset
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Landmark 14 Seacombe Road
    Sandbanks
    BH13 7RJ Poole
    Flat 8
    Dorset
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director2897330004
    SARNEY, Amanda Marie
    2 Ivy Place
    Lane End
    HP14 3LQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Ivy Place
    Lane End
    HP14 3LQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishOffice Manager63334170002

    Hat WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of memorandum of variation
    Erstellt am 14. Feb. 2011
    Geliefert am 15. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the owner to the chargee or any associated company of close brothers group PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An aircraft mortgage dated 29/09/10 and a loan agreement dated 29/09/10 secured by mortagge over the beech 76 aircraft, reg mark g-waci and s/no. ME289 and includes the engines and all equipment, the insurances and the requisition compensation see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of memorandum of variation
    Erstellt am 14. Feb. 2011
    Geliefert am 15. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the owner to the chargee or any associated company of close brothers group PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An aircraft mortgage dated 29/09/10 and a loan agreement dated 29/09/10 secured by mortagge over the beech 76 aircraft, reg mark g-wacj and s/no. ME278 and includes the engines and all equipment, the insurances and the requisition compensation see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Aircraft mortgage deed
    Erstellt am 29. Sept. 2010
    Geliefert am 02. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the owner to the chargee or any associated company of close brothers group PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    One(1) reims cessna F127P aircraft, bearing manufacturers serial number 2217 and registration mark g-wacy and includes the engines and all equipment, the insurances and the requisition compensation see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Aircraft mortgage deed
    Erstellt am 29. Sept. 2010
    Geliefert am 02. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the owner to the chargee or any associated company of close brothers group PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    One(1) beech 76 aircraft, bearing manufacturers serial number me-278 and registration mark g-wacj and includes the engines and all equipment, the insurances and the requisition compensation see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Aircraft mortgage deed
    Erstellt am 29. Sept. 2010
    Geliefert am 02. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the owner to the chargee or any associated company of close brothers group PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    One(1) beech 76 aircraft, bearing manufacturers serial number me-289 and regsistration mark g-waci and includes the engines and all equipment, the insurances and the requisition compensation see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Asset Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 16. Juli 2008
    Geliefert am 21. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £67,983.30 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Beech C24R, reg mark g-bzpg s/no mc-556, beech C24R reg mark g-cbcy s/no mc-491 together with an assignment of the rights, title and interest in the insurances including all claims and the return of any premiums.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 10. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cessna F152 g-wace 1978, cessna F152 g-wacb 1972, cessna 152 g-wacf 152-84852 for details of further assets charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Capital (UK) PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 21. Sept. 2006
    Geliefert am 29. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £230,338 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    First priority fixed aircraft mortgage over aircraft type (1) & (2) beech 76 (3) (4) (5) cessna registration mark (1) g-wacj (2) g-waci (3) g-byem (4) g-wacy (5) g-ojag serial number (1) me-278 (2) me-289 (3) R182-00822 (4) 2217 (5) 172S9794 together with an assignment of the rights title and interest in the insurances in relation thereto including all claims thereunder and return of any premiums.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 23. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or owner trustee to the chargee
    Kurze Angaben
    Beechcraft 76 "duchess" reg mark g-waci s/no ME289; beechcraft 76 "duchess" reg mark g-wacj s/no ME278; cessna 182RG reg mark g-byem s/no 182-00822 for details of further aircraft charged please refer to form 395 , with all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 11. Dez. 2002
    Geliefert am 20. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Aircraft type (1) cessna (2) beech (3) beech, registration mark (1) g-byem (2) g-waci (3) wacj, serial number (1) R182-00822 (2) ME276 (3) ME278 together with the assignment of the rights title and interest in the insurances in relation thereto including all claims thereunder and the return of any premiums.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Aircraft mortgage
    Erstellt am 16. Jan. 2002
    Geliefert am 17. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    First priority fixed aircraft mortgage over: aircraft type:- cessna 172, registration mark:- g-wacm, serial number:- 17259005, together with an assignment of the rights, title and interest in the insurances, in relation thereto, including all claims thereunder, and the return of any premiums.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fleet aircraft mortgage
    Erstellt am 19. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All its interest in the aircraft (see schedule to form 395) the engines the equipment and technical records..any replacement or substitute engine technical records or equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 19. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The frasca 142 flight simulator (1989) serial no 142.V4.12B/038 together with all additions alterations accessories replacements and renewals. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. März 1999
    Geliefert am 26. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat WYCOMBE AIR CENTRE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Dez. 2011Beginn der Verwaltung
    06. Juni 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Geoffrey Paul Rowley
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Praktiker
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Jason Daniel Baker
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Praktiker
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0