LEISURE PROMOTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEISURE PROMOTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00939341
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 11. Jan. 2022

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 22. Sept. 2020

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 13. Juli 2020

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England zum Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 16. März 2020

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Sekretär am 28. Jan. 2020

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Sekretär am 28. Jan. 2020

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Geschäftsführer am 28. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Direktor am 28. Jan. 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Juni 2016

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Sekretär
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960680001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Geschäftsführer
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Geschäftsführer
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Sekretär
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Sekretär
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    British7148530001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Sekretär
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209562700001
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965380002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Sekretär
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Sekretär
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BRYDON, Leslie
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    British103621720001
    EVANS, Byron
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    Geschäftsführer
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    British105734100001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Geschäftsführer
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    United KingdomBritish7148530001
    HUGHES, John Ashley
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish112694600001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Geschäftsführer
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEISURE PROMOTIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06. Apr. 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05382157
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LEISURE PROMOTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A standard security which was presented for registration in scotland on 01ST may 2006 and
    Erstellt am 04. Apr. 2007
    Geliefert am 11. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole (in the first place) the subjects being the ground floor office premises at 7 queensferry street lane edinburgh t/n MID8109 (in the second place) all and whole the subjects k/a 18 shadwick place edinburgh t/n MID8159 and (in the third place) all and whole the tenant's interst in the lease of the subjects at 18A shandwick place edinburgh t/n MID39984. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself as a Finance Party and as Agent and Trustee for Theother Finance Party
    Transaktionen
    • 11. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 04. Apr. 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 08. Feb. 2007
    Geliefert am 14. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 22 august 2005 and
    Erstellt am 06. Juli 2005
    Geliefert am 25. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    18A shandwick place edinburgh t/no MID39984.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 20TH july 2005 and
    Erstellt am 06. Juli 2005
    Geliefert am 23. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a ground floor office at 7 queensferry street lane edinburgh t/n MID8109.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 20TH july 2005 and
    Erstellt am 06. Juli 2005
    Geliefert am 23. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as 18 shadwick place edinburgh t/n MID8159.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 06. Juli 2005
    Geliefert am 13. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2005
    Geliefert am 09. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 2003
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 25. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Interest in the lease dated 6 december 2002 of 18A shandwick place edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 14 april 2003 and
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 19. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The subjects k/a 7 queensferry street lane edinburgh being subjects under t/n MID8109.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 04 september 2001 and
    Erstellt am 15. Aug. 2001
    Geliefert am 11. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects and others formerly k/a number 5 and now k/a number 18 shandwick place in the city of edinburgh, and for the purpose of registration in the county of midlothian being the subjects on the north side of shandwick place together with the whole fixtures and fittings in and upon the said subjects, the whole rights common, mutual and exclusive pertaining thereto... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4TH january 2001 and
    Erstellt am 08. Nov. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole the dwellinghouse being the eastmost half of the top flat at no.2 Alva st,edinburgh together with the cellar and other subjects thereto.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 23RD april 1999
    Erstellt am 03. Feb. 1999
    Geliefert am 01. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 shandwick place edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Mai 1998
    Geliefert am 30. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 21. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Sept. 1992
    Geliefert am 02. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M365. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 21. Apr. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 23. März 1990
    Geliefert am 31. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The cosy cinema hall, saltburn by sea in the county of york.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 23. März 1990
    Geliefert am 31. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The rex bingo hall and amusement centre denton street denton holme carlisle.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Sept. 1984
    Geliefert am 14. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Feb. 1982
    Geliefert am 05. März 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over present and future including goodwill & book debts uncalled capital. With all building fixtures fixed plant and machinery.. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1982Registrierung einer Belastung
    • 13. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 1981
    Geliefert am 25. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H black bull hotel, market street, kirkby stephen, cumbria.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1981
    Geliefert am 19. Okt. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling pound 40000 from the company to the chargee including monies due for goods sold & delivered.
    Kurze Angaben
    F/H- black bull hotel, market street, kirkby stephen, cumbria, together with the barns, stables, coach houses & other outbuildings, yard and other premises.
    Berechtigte Personen
    • Allied Breweries (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1981Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juli 1980
    Geliefert am 21. Juli 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H rex cinema denton street carlisle cumbria.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 1980Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 1971
    Geliefert am 03. Jan. 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The cosy cinema, milton st, saltburn, yorks.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1972Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 1970
    Geliefert am 27. Nov. 1970
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The picture house,south view,billingham,teesside as comprised is a conveyance dated 12/3/69.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1970Registrierung einer Belastung
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0