LEISURE PROMOTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEISURE PROMOTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00939341 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Wales |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 11. Jan. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Zane Cedomir Mersich am 22. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales zum Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 13. Juli 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England zum Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB am 16. März 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Sekretär am 28. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Sekretär am 28. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Neil Paramore als Geschäftsführer am 28. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Mark Glennon als Direktor am 28. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Juni 2016 | 6 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLENNON, Andrew Mark | Sekretär | South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | 266960680001 | |||||||
| GLENNON, Andrew Mark | Geschäftsführer | South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | Wales | British | 260666740001 | |||||
| MERSICH, Zane Cedomir | Geschäftsführer | South Road Bridgend Industrial Estate CF31 3EB Bridgend Novomatic House Wales | England | South African | 131382980002 | |||||
| HARVEY, Peter James | Sekretär | 3 Gates Court High Street SG7 6GA Baldock Hertfordshire | British | 103770410001 | ||||||
| HUGHES, Harry Stuart | Sekretär | Clervaux Dalton Road Croft DL2 2NR Darlington Co Durham | British | 7148530001 | ||||||
| PARAMORE, Neil | Sekretär | 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate CF31 3RY Bridgend Astra House Mid Glamorgan Wales | 209562700001 | |||||||
| WILSON, Karen | Sekretär | Woodlands Business Park Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House Buckinghamshire United Kingdom | British | 151965380002 | ||||||
| YANTIN, Gary Laurence | Sekretär | 85 Cardinal Avenue WD6 1ST Borehamwood Hertfordshire | British | 119004760001 | ||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Black Friars Lane EC4V 6HD London 20 | 39182980001 | |||||||
| BRYDON, Leslie | Geschäftsführer | 1 Victoria House Market Place DL8 4NP Middleham North Yorkshire | British | 103621720001 | ||||||
| EVANS, Byron | Geschäftsführer | Keepers Cottage 46 High Street Whittlebury NN12 8JX Northampton | British | 105734100001 | ||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HARDING, Nicholas Simon | Geschäftsführer | The Old Wharf House The Wharf MK14 5AS Great Linford Buckinghamshire | England | British | 150860820001 | |||||
| HARVEY, Peter James | Geschäftsführer | Woodlands Business Park Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 103770410003 | |||||
| HUGHES, Harry Stuart | Geschäftsführer | Clervaux Dalton Road Croft DL2 2NR Darlington Co Durham | United Kingdom | British | 7148530001 | |||||
| HUGHES, John Ashley | Geschäftsführer | Longwood Darlington Road DL10 7EB Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 112694600001 | |||||
| PARAMORE, Neil | Geschäftsführer | 1 Kingsway Bridgend Industrial Estate CF31 3RY Bridgend Astra House Mid Glamorgan Wales | Wales | British | 79707840002 | |||||
| REDMOND, Brendan Patrick | Geschäftsführer | 57 Crisp Street 3188 Hampton Victoria 3188 Australia | Australia | Irish | 117576220001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEISURE PROMOTIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talarius Ltd | 06. Apr. 2016 | Breckland Linford Wood MK14 6EW Milton Keynes Birch House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LEISURE PROMOTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A standard security which was presented for registration in scotland on 01ST may 2006 and | Erstellt am 04. Apr. 2007 Geliefert am 11. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole (in the first place) the subjects being the ground floor office premises at 7 queensferry street lane edinburgh t/n MID8109 (in the second place) all and whole the subjects k/a 18 shadwick place edinburgh t/n MID8159 and (in the third place) all and whole the tenant's interst in the lease of the subjects at 18A shandwick place edinburgh t/n MID39984. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 04. Apr. 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 08. Feb. 2007 Geliefert am 14. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 22 august 2005 and | Erstellt am 06. Juli 2005 Geliefert am 25. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 18A shandwick place edinburgh t/no MID39984. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 20TH july 2005 and | Erstellt am 06. Juli 2005 Geliefert am 23. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a ground floor office at 7 queensferry street lane edinburgh t/n MID8109. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 20TH july 2005 and | Erstellt am 06. Juli 2005 Geliefert am 23. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects known as 18 shadwick place edinburgh t/n MID8159. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 06. Juli 2005 Geliefert am 13. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juli 2005 Geliefert am 09. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 2003 | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Interest in the lease dated 6 december 2002 of 18A shandwick place edinburgh. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 14 april 2003 and | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 19. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The subjects k/a 7 queensferry street lane edinburgh being subjects under t/n MID8109. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 04 september 2001 and | Erstellt am 15. Aug. 2001 Geliefert am 11. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All and whole the subjects and others formerly k/a number 5 and now k/a number 18 shandwick place in the city of edinburgh, and for the purpose of registration in the county of midlothian being the subjects on the north side of shandwick place together with the whole fixtures and fittings in and upon the said subjects, the whole rights common, mutual and exclusive pertaining thereto... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 4TH january 2001 and | Erstellt am 08. Nov. 2000 Geliefert am 11. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole the dwellinghouse being the eastmost half of the top flat at no.2 Alva st,edinburgh together with the cellar and other subjects thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 23RD april 1999 | Erstellt am 03. Feb. 1999 Geliefert am 01. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18 shandwick place edinburgh. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Mai 1998 Geliefert am 30. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 21. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 ref M365. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 23. März 1990 Geliefert am 31. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cosy cinema hall, saltburn by sea in the county of york. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-mortgage | Erstellt am 23. März 1990 Geliefert am 31. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The rex bingo hall and amusement centre denton street denton holme carlisle. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Sept. 1984 Geliefert am 14. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 1982 Geliefert am 05. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over present and future including goodwill & book debts uncalled capital. With all building fixtures fixed plant and machinery.. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Nov. 1981 Geliefert am 25. Nov. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H black bull hotel, market street, kirkby stephen, cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 1981 Geliefert am 19. Okt. 1981 | Vollst ändig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pound 40000 from the company to the chargee including monies due for goods sold & delivered. | |
Kurze Angaben F/H- black bull hotel, market street, kirkby stephen, cumbria, together with the barns, stables, coach houses & other outbuildings, yard and other premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juli 1980 Geliefert am 21. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H rex cinema denton street carlisle cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1971 Geliefert am 03. Jan. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The cosy cinema, milton st, saltburn, yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Nov. 1970 Geliefert am 27. Nov. 1970 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The picture house,south view,billingham,teesside as comprised is a conveyance dated 12/3/69. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0