LB MOTORENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLB MOTORENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00940954
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LB MOTORENT LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LB MOTORENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LB MOTORENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LLOYDS TSB MOTORENT LIMITED29. Dez. 200029. Dez. 2000
    MOTORENT (U.K.) LIMITED22. Okt. 196822. Okt. 1968

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LB MOTORENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LB MOTORENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 17. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 24. Juni 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Carol Ann Parkes am 26. März 2019

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Mai 2016

    • Kapital: GBP 190,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Andrew John Hartley als Direktor am 16. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 27. Mai 2015

    • Kapital: GBP 190,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Sutton als Geschäftsführer am 16. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert

    1 SeitenAD02

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed lloyds tsb motorent LIMITED\certificate issued on 13/06/14
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name13. Juni 2014

    Beschluss zur Änderung der Firma am 12. Juni 2014

    RES15
    change-of-name13. Juni 2014

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Mai 2014

    • Kapital: GBP 190,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Sutton am 28. Feb. 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LB MOTORENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02791894
    73512200003
    HARTLEY, Andrew John
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193543400001
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139996590028
    COTTRELL, Dora
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    British2797140001
    FRAIN, Paula
    16 Woodland Place
    CF64 2EX Penarth
    South Glamorgan
    Sekretär
    16 Woodland Place
    CF64 2EX Penarth
    South Glamorgan
    British70163380001
    HOPKINS, Stephen John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    149224300001
    PRICE, David John
    22 Launcelot Crescent
    Thornhill
    CF14 9AQ Cardiff
    Sekretär
    22 Launcelot Crescent
    Thornhill
    CF14 9AQ Cardiff
    British55210940002
    SAUNDERS, Deborah Ann
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Sekretär
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Other38589290002
    BLACKWELL, Timothy Mark
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish124967310001
    BLAKE, Brendan Patrick Paul
    Woodlands House Devauden Road
    St Arvens
    NP6 6EZ Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    Woodlands House Devauden Road
    St Arvens
    NP6 6EZ Chepstow
    Gwent
    British8309510001
    COTTRELL, Bernard Raymond
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    British2797130001
    COTTRELL, Dean Spencer
    The Cotters
    Caldecote Lane
    WD23 4EF Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Cotters
    Caldecote Lane
    WD23 4EF Bushey Heath
    Hertfordshire
    British86348330001
    COTTRELL, Dora
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Grimsdyke Manor Priory Drive
    HA7 3HN Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish2797140001
    COTTRELL, Gary Bernard
    Pudds Corner
    Pudds Cross
    HP3 0NJ Bovingdon
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Pudds Corner
    Pudds Cross
    HP3 0NJ Bovingdon
    Hertfordshire
    British71014470003
    COTTRELL, Ian Clive
    70 Lamorna Grove
    HA7 1PG Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    70 Lamorna Grove
    HA7 1PG Stanmore
    Middlesex
    British3215930001
    DAVIES, John Lewis
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    British51486560001
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish180380320001
    GOW, David Stewart
    54 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XS Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    54 Mill Road
    Lisvane
    CF14 0XS Cardiff
    South Glamorgan
    British75821340002
    KILBEE, Michael Peter
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    British19310990002
    POTTS, David Keith
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish5774320002
    PUTTOCK, George Thomas
    7 Mollison Close
    Woodley
    RG5 4XG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    7 Mollison Close
    Woodley
    RG5 4XG Reading
    Berkshire
    British15173800001
    RICHMOND, Simon John
    Heritage House 20 Badgers Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6UE Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    Heritage House 20 Badgers Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6UE Chepstow
    Gwent
    British74691050001
    STEAD, Nigel Cleator
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    Geschäftsführer
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    EnglandBritish47582470001
    SUTTON, Christopher
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    ScotlandBritish130660440002
    THORNTON, Colin Rhodes
    Sherwood
    Rock Cross, Rock
    DY14 9SD Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Sherwood
    Rock Cross, Rock
    DY14 9SD Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish47528560002
    WHITE, Adrian Patrick
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish130578200001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LB MOTORENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03961947
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LB MOTORENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 13TH july 1992 and made between the company (1) and royscot trust PLC, royscot leasing limited, royscot industrial leasing limited, royscot commercial leasing limited and royscot spa leasing limited (2) issued by the company
    Erstellt am 03. Nov. 1998
    Geliefert am 04. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of legal assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in the attached schedule attached to the form 395 together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to aquire title in the goods forming the subject matter of such sub-hire agreements. By way of equitable legal assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements ancillary contracts and other contracts at any time entered into in substitution for assets assigned as above or entered into in relation to the goods forming the subject matter of sub-hire agreements and all rights of the company to aquire title in such goods insofar as not assigned in law.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 13TH july 1990
    Erstellt am 28. Sept. 1998
    Geliefert am 03. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All monies due under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 23. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in the sub-hire agreements specified in the schedule and all moneys,claims for damages,guarantees,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Keedietfinance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 23. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 06. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the sub-hire agreements (as detailed on the form 395 and continuation sheets) and all monies and all claims for damages the benefit of all guarantees and the assignable rights in the goods leased under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kredietfinance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 06. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and interest of the sub-hire agreements (as defined on the form 395 and continuation sheets) including all monies and all claims for damages the benefit of all guarantees and the assignable rights in the goods leased under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kredietfinance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment (pursuant to a master assignment dated 13 july 1990)
    Erstellt am 13. Nov. 1997
    Geliefert am 19. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of certain agreements between the company and the chargee and under the provisions of the master assignment
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due under the 48 sub-hire agreements specified in the schedule fo the certificate of assignment with the benefit of all guarantees indemnities and securities in connection with the assigned agreements.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Okt. 1997
    Geliefert am 16. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first specific equitable mortgage all present and future contracts of lease or hire made by the company in relation to all or any goods acquired or which may hereafter be acquired together with all monies now or from time to time payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 15TH august 1994
    Erstellt am 29. Sept. 1997
    Geliefert am 09. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any hiring agreements
    Kurze Angaben
    All right title and benefit under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees etc. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master security assignment
    Erstellt am 08. Sept. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in respect of any sub-hire agreements including all claims for damages all moneys and all claims with the full benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kredietfinance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master agreement and charge
    Erstellt am 17. Juli 1997
    Geliefert am 22. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of any lease purchase, hire purchase, conditional sale or bailment agreement (as defined in the charge) or under the charge
    Kurze Angaben
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire ("the sub lessee") whereby the customer lets or agrees to let the goods forming the subject matter of any lease purchase hire purchase conditional sale or bailment agreement to the sub lessee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited and Various Other Companies (Together "the Finance Company")
    Transaktionen
    • 22. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 15TH august 1994 issued by the company
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 03. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any hiring agreements and all other monies incurred by the chargee to enforce any of the provisions of the master assignment
    Kurze Angaben
    Assignment by way of security of:- 1) all monies right title and benefit due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment ("the assigned agreements"). 2) the benefit of all guaranties indemnities negotiable instruments and securties taken by the company in connection with the assigned agreements.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 13. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £880,772.38 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge agreement
    Kurze Angaben
    A specific fixed charge over:-all the rights and interests of the company under the hire agreements specified in the appendix.all monies payable.the vehicles comprised in and the subject of the said hire agreements.all monies payable under any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 25. März 1997
    Geliefert am 02. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hiring agreements
    Kurze Angaben
    All monies right title and benefit in the sub-hire agreements and the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Finance PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 05. März 1997
    Geliefert am 06. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £736,142.22 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the hire agreements contract numbers;-int 0006, MEN0003, TUI0040, MIC0040, MIC0041, MIC0039, SLD0009, WCP0019,BPL0033, BPL0032, ETY0176, DEN0064, BCI0020 HWL0139, BRR0156, SHE0014, BPP0015, FSL0015, BPP0011, BPP0012, TTM0025, ETY0179, HWL0141, BPP0013, WLL0054, URL0017, TSC0305, TSC0304, BPP0017. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 06. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 05. März 1997
    Geliefert am 06. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £326,693.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in and to the hire agreements numbered DLS0001, MCP0035, MIS0007, BOH0044, TSC0296, TSC0301, TSC300, HWL0140, KLT0001, TBT0034, THF0012, PUR0013, PRL0236, TSC0299, TSC0298, TSC0295, TSC0302,PRL0235, TUM0013, ALO0015,TUM0012, FEL0034, MLD0161, D2205, ELM0072,EPS0010. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 06. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 28. Nov. 1996
    Geliefert am 30. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £634,146.86 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge agreement
    Kurze Angaben
    A specific fixed charge over:- a) all the rights and interests of the company under the hire agreements specified in the attached appendix to the form 395. b) all monies now or hereafter to become payable under the said hire agreements. C) the vehicles comprised in and the subject of the said hire agreements as specified in the said appendix, and d) all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. Appendix-FCM0008, 18/10/96, peugeot 406 1.9 lx td saloon 4DR, P783 kdt. RTI0311, 01/11/96, rover 400 420 gsi hatch 5DR, P187 ebl. TSA0014, 01/11/96, rover 200 216 sli hatch 5DR, P183 ebl.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 28. Okt. 1996
    Geliefert am 29. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £724,389.38 and all monies due or to become due from the company to the chargee secured by the charge agreement
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the hire agreements specified in the attached appendix all monies payable the vehicles comprised in and subject of the hire agreements and all monies payable under any insurance in respect of the vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 25. Okt. 1996
    Geliefert am 26. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,199,014.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All rights and interests of the company in the hire agreements (as specified in the schedule attached to the form 395) and all monies payable all vehicles comprised therein and insurance payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 13TH july 1992 and issued by the company
    Erstellt am 23. Sept. 1996
    Geliefert am 24. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in the schedule attached to the form 395 together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter of such sub-hire agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 13TH july 1992 and issued by the company
    Erstellt am 23. Sept. 1996
    Geliefert am 24. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in the schedule attached to the form 395 together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter of such sub-hire agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of sub-hiring agreements
    Erstellt am 02. Aug. 1996
    Geliefert am 20. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in respect of present and/or future leasing hiring conditional sale lease purchase hire purchase or credit sale agreements made or to be made between the company to the chargee and all other liabilities under the charge
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest and any benefits payments debts and advantages accruing under the sub-hire agreements all maintenance contracts in relation to the goods all guarantees indemnities and other securities all insurance policies all right and debts under the sub-hiring agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 08. Juli 1996
    Geliefert am 11. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £866,097.63 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the rights and interests of the company under the hire agreements specified in the appendix attached to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 11. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 13. Mai 1996
    Geliefert am 14. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £447,740.65 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Specific fixed charge over all rights and interest under the hire agreements specified in the schedule attached to form 395 showing various cars and their registration numbers. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 17. Jan. 1996
    Geliefert am 18. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £248,178.19 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    A specific charge over:- a) all the rights and interests of the company under the hire agreements, contract no.-SGK0005, date-121295, make-ford mondeo 1.8 lx turbo di estate, reg no-N812 flb. Contract no.-RMP0188, date-211295, make-ford mondeo 1.8I glx hatch 5DR, reg no.-N823 flb. Contract no.-TTC0007, date-121295, make-renault laguna 2.2 rt diesel hatch, reg no.-N897 rcg. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge agreement
    Erstellt am 17. Jan. 1996
    Geliefert am 18. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £183,781.38 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Kurze Angaben
    A specific charge over a) all the rights and interests of the company under the hire agreements, contract no.-MAC0170, date-061195, make-renault laguna 2.0 rt hatch 5DR, reg no.-N355 rcg. Contract no.-CFR0029, date-061095, make-volvo 850 2.0 20V glt sallon, reg no.-N126 fcl. Contract no.-BRR0120, date-061095, make-audi A6 2.0 SE estate 5DR auto, reg no.-N896 0YF. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LB MOTORENT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Juni 2019Beginn der Liquidation
    02. Feb. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0