SIMONS CONSTRUCTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SIMONS CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00961095 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House LE19 1WL Meridian Business Park Leicester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SIMONS CONSTRUCTION GROUP LIMITED | 28. Aug. 1969 | 28. Aug. 1969 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2019 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Aug. 2020 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 26. Sept. 2020 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Aug. 2019 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Apr. 2025 | 22 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Apr. 2024 | 23 Seiten | LIQ03 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Apr. 2023 | 22 Seiten | LIQ03 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 29 Seiten | AM22 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 34 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 40 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 45 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 39 Seiten | AM10 | ||
Erfüllung der Belastung 009610950010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 71 Seiten | AM07 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 25 Seiten | AM02 | ||
Vorschlag des Verwalters | 66 Seiten | AM03 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 991 Doddington Road Lincoln Lincs LN6 3AA zum C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Meridian Business Park Leicester LE19 1WL am 16. Dez. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Daniel Edwin Robinson als Geschäftsführer am 31. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Thomas Daniel Edwin Robinson als Direktor am 07. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Thomas Daniel Edwin Robinson als Geschäftsführer am 19. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Richard Hodgkinson am 27. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Michael Harrison Kasher as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Harrison Kasher als Geschäftsführer am 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGKINSON, Paul Richard | Geschäftsführer | Ashcroft House LE19 1WL Meridian Business Park C/O Frp Advisory Llp Leicester | England | British | 35550580004 | |||||
| HODGKINSON, Philip David | Geschäftsführer | Ashcroft House LE19 1WL Meridian Business Park C/O Frp Advisory Llp Leicester | England | British | 2850580001 | |||||
| CONROY, Graham Leslie | Sekretär | 2 Ridge View Harmston LN1 3QW Lincoln Lincolnshire | British | 74935030007 | ||||||
| KASHER, Michael Harrison | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | 209623220001 | |||||||
| KENDALL, Philip James | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | 150544650001 | |||||||
| KENDALL, Philip James | Sekretär | Overbury 1 Kenderdine Close Bednall ST17 0YS Stafford Staffordshire | British | 58364160002 | ||||||
| KENT, Patrick Anthony | Sekretär | Lincoln Drive Caistor LN7 6PA Market Rasen 7 Lincolnshire | British | 124674960001 | ||||||
| MURPHY, Patrick | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | 150592880001 | |||||||
| O'CONNELL, Christian John | Sekretär | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | 165197430001 | |||||||
| BARNES, Alan David | Geschäftsführer | New Lodge 4 The Avenue Wanstead E11 2EF London | United Kingdom | British | 124713870001 | |||||
| BRIDGES, David Julien Otho | Geschäftsführer | The Walled Garden Harmston LN5 9WG Lincoln 1 Lincolnshire | United Kingdom | British | 124020040001 | |||||
| BROCKLESBY, Philip John | Geschäftsführer | 64 Brant Road LN5 8SH Lincoln Lincolnshire | British | 37307340002 | ||||||
| BRYANT, Clifford Thomas | Geschäftsführer | Clandon House Thorpe In The Fallows LN1 2DR Lincoln Lincolnshire | British | 62230010002 | ||||||
| CHILTON-MURPHY, Antony David | Geschäftsführer | Priory Lane OX18 4SG Burford 10 Oxfordshire | British | 124674880002 | ||||||
| CONROY, Graham Leslie | Geschäftsführer | 2 Ridge View Harmston LN1 3QW Lincoln Lincolnshire | British | 74935030007 | ||||||
| COSGROVE, Graeme John | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 183405790001 | |||||
| FIRTH, Richard Joseph | Geschäftsführer | Westhaven Main Street Osgodby LN8 3PA Market Rasen Lincolnshire | United Kingdom | British | 125971300004 | |||||
| GATENBY, Ronald Christopher | Geschäftsführer | 9 Pasture Close Skelton YO3 6GZ York North Yorkshire | England | British | 20815850001 | |||||
| GUTHRIE, Fiona | Geschäftsführer | Millfield Fen Lane Dunston LN4 2HD Lincoln Lincolnshire | England | British | 107950190001 | |||||
| HALL, Roger Alan | Geschäftsführer | Sugar Chapel Lane Dunston LN4 2ET Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 31884180001 | |||||
| HALLAM, Jonathan | Geschäftsführer | Broadale Close Sudbrooke LN2 2FD Lincoln 12 Lincolnshire | British | 125930960002 | ||||||
| HODGKINSON, Martin Peter | Geschäftsführer | Carlton House 37 High Street LN5 9HL Carlton Le Moorland Lincoln | United Kingdom | British | 3736390002 | |||||
| KASHER, Michael Harrison | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 140185150001 | |||||
| KENDALL, Philip James | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 58364160002 | |||||
| KENDALL, Philip James | Geschäftsführer | Overbury 1 Kenderdine Close Bednall ST17 0YS Stafford Staffordshire | England | British | 58364160002 | |||||
| KENNEDY, Philip Howard | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 166938770001 | |||||
| KENT, Patrick Anthony | Geschäftsführer | Lincoln Drive Caistor LN7 6PA Market Rasen 7 Lincolnshire | United Kingdom | British | 124674960001 | |||||
| LITTLEWOOD, Rex | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | United Kingdom | British | 137904800001 | |||||
| MARTIN, Brian | Geschäftsführer | 10 Laurel Avenue Keyworth NG12 5DF Nottingham Nottinghamshire | British | 3736410001 | ||||||
| MEEHAN, Andrew David | Geschäftsführer | Doddington Road LN6 3AA Lincoln 991 Lincs England | England | British | 62737150001 | |||||
| MURPHY, James William | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | None | British | 4145300002 | |||||
| MURPHY, Patrick | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | Irish | 146322290001 | |||||
| O'CONNELL, Christian John | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 165195970001 | |||||
| POLKEY, John Albert | Geschäftsführer | 2 Shaftsbury Avenue Forest Park LN6 0QN Lincoln Lincolnshire | British | 3736380001 | ||||||
| ROBINSON, Thomas Daniel Edwin | Geschäftsführer | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | England | British | 264024530001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIMONS CONSTRUCTION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Richard Hodgkinson | 15. Aug. 2019 | Ashcroft House LE19 1WL Meridian Business Park C/O Frp Advisory Llp Leicester | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Michael Harrison Kasher | 04. Juli 2016 | 991 Doddington Road Lincoln LN6 3AA Lincs | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat SIMONS CONSTRUCTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 13. Apr. 2017 Geliefert am 13. Apr. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (ad defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01).. In the debenture "land" means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant's fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 24. März 2006 Geliefert am 29. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of a deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 16. Sept. 1993 Geliefert am 21. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee in favour of burnfield builders & demolishers limited for £165,000 | |
Kurze Angaben The sum of £165,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 99667665 and earmarked or designated by refernece to the comapny. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Mai 1993 Geliefert am 03. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-401 monks road lincoln, and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Mai 1993 Geliefert am 01. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 3 and 4 st lawrence works industrial estate nacton road ipswich and or the proceeds of sale thereof together with the benefit of all licences and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Mai 1993 Geliefert am 01. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at outgang lane osbaldwick york and or the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Apr. 1993 Geliefert am 20. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £40,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Unit 2 rose lane mews rose lane ticknall derbyshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1977 Geliefert am 01. Dez. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as dwellinghouse 420 monks rd, lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Juni 1976 Geliefert am 21. Juni 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And over all book & other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Aug. 1974 Geliefert am 05. Sept. 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land in monks road lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SIMONS CONSTRUCTION LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0