DYSERTH FALLS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDYSERTH FALLS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00964086
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DYSERTH FALLS LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
    • Wohnmobilparks, Anhängerparks und Campingplätze (55300) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich DYSERTH FALLS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Opus Restructuring Llp 1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DYSERTH FALLS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LIDO BEACH CARAVAN PARK LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    BOURNE LEISURE (PRESTATYN) LIMITED16. Okt. 196916. Okt. 1969

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DYSERTH FALLS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für DYSERTH FALLS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    29 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Apr. 2023

    32 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6th & 7th Floor 120 Bark Street Bolton BL1 2AX zum Opus Restructuring Llp 1 Radian Court Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8PJ am 19. Juli 2023

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    13 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor, Churchgate House 30 Churchgate Bolton Lancashire BL1 1HL zum 6th & 7th Floor 120 Bark Street Bolton BL1 2AX am 06. Okt. 2022

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Apr. 2022

    40 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Apr. 2021

    38 SeitenLIQ03

    Erfüllung der Belastung 009640860010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    14 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Apr. 2020

    39 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    11 SeitenLIQ10

    Eintragung der Belastung 009640860010, erstellt am 27. Juni 2019

    7 SeitenMR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Dyserth Falls Resort Allt Y Graig Dyserth Rhyl Clwyd LL18 6DX zum C/O Anderson Brookes Insolvency Practitioners Ltd 4th Floor, Churchgate House 30 Churchgate Bolton Lancashire BL1 1HL am 29. Apr. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Apr. 2019

    LRESEX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of Lesley Goddard as a person with significant control on 14. Juni 2017

    2 SeitenPSC01

    Wer sind die Geschäftsführer von DYSERTH FALLS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GODDARD, Arthur Edward
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    WalesBritish232997860001
    COOK, John Charles
    Lady Grove Farm
    Preston
    SG4 7SA Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    Lady Grove Farm
    Preston
    SG4 7SA Hitchin
    Hertfordshire
    British141338430001
    GODDARD, Arthur Edward
    5 Highlands Close
    Rhuddlan
    LL18 2RU Rhyl
    Clwyd
    Sekretär
    5 Highlands Close
    Rhuddlan
    LL18 2RU Rhyl
    Clwyd
    British29318300001
    KING, Dermot Francis
    Little Croft The Pines
    Boxmoor
    HP3 0DJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    Little Croft The Pines
    Boxmoor
    HP3 0DJ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Irish60175360002
    PARKER, Emma
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Graig Park Hotel And Country Club
    Denbighshire
    Sekretär
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Graig Park Hotel And Country Club
    Denbighshire
    British150390100001
    ALLEN, David Charles Russell
    5 Little London Court
    Old Town
    SN1 3HY Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    5 Little London Court
    Old Town
    SN1 3HY Swindon
    Wiltshire
    British927840001
    COOK, John Charles
    Lady Grove Farm
    Preston
    SG4 7SA Hitchin
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Lady Grove Farm
    Preston
    SG4 7SA Hitchin
    Hertfordshire
    Great BritainBritish141338430001
    GODDARD, Arthur Edward
    5 Highlands Close
    Rhuddlan
    LL18 2RU Rhyl
    Clwyd
    Geschäftsführer
    5 Highlands Close
    Rhuddlan
    LL18 2RU Rhyl
    Clwyd
    British29318300001
    GODDARD, David Joseph
    Corsydd
    Rhuddlan Road, St. George
    LL22 9SD Abergele
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Corsydd
    Rhuddlan Road, St. George
    LL22 9SD Abergele
    Clwyd
    WalesBritish29318310004
    GODDARD, Luke Arthur
    Allt Y Graig
    LL18 6DX Dyserth
    Dyserth Falls Resort Ltd
    Denbighshire
    Wales
    Geschäftsführer
    Allt Y Graig
    LL18 6DX Dyserth
    Dyserth Falls Resort Ltd
    Denbighshire
    Wales
    WalesBritish193156740001
    GODDARD, Luke Arthur
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    WalesBritish193156740001
    GODDARD, Luke Arthur
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    WalesBritish193156740001
    GODFREY, Gillian Ann
    3 Davidge Place
    Knotty Green
    HP9 2SR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Davidge Place
    Knotty Green
    HP9 2SR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92857250001
    HARRIS, Caryl Lesley
    Sallow Copse
    Ringshall
    HP4 1LZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sallow Copse
    Ringshall
    HP4 1LZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British13355630001
    HARRIS, Peter Woodstock
    10 Newall Street
    BL3 3LX Birmingham
    Geschäftsführer
    10 Newall Street
    BL3 3LX Birmingham
    British65242660001
    SEATON, Robert
    6 Eldon Grove
    NW3 5PS London
    Geschäftsführer
    6 Eldon Grove
    NW3 5PS London
    British54511890001
    WHITELAM, David Roy
    8 Staines Square
    LU6 3JQ Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    8 Staines Square
    LU6 3JQ Dunstable
    Bedfordshire
    British49041180001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DYSERTH FALLS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Lesley Goddard
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    14. Juni 2017
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mrs Margaret Goddard
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    14. Juni 2017
    1 Radian Court
    Knowlhill
    MK5 8PJ Milton Keynes
    Opus Restructuring Llp
    Buckinghamshire
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr David Joseph Goddard
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    06. Apr. 2016
    Allt Y Graig
    Dyserth
    LL18 6DX Rhyl
    Dyserth Falls Resort
    Clwyd
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DYSERTH FALLS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 27. Juni 2019
    Geliefert am 03. Juli 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The freehold property known as the dyserth falls resort, allt y graig, dyserth, rhyl, LL18 6DX with title number WA448580 and other items as more particularly set out in the instrument.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Charles Street Commercial Investments Limited
    Transaktionen
    • 03. Juli 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Okt. 2013
    Geliefert am 23. Okt. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land lying to the south of the promenade prestatyn registered at land registry under title number WA366326. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Black Horse Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 2005
    Geliefert am 15. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property situate and being lido beach holiday park bastion road prestatyn denbighshire t/nos WA13503, WA366326 and CYM57467.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 18. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2005
    Geliefert am 19. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a that pumping station site adjoining lido beach caravan park lying to the north of grosvenor road prestatyn, denbighshire t/no CYM57467. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 2001
    Geliefert am 13. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a lido beach caravan park prestatyn denbighshire t/n WA13503 and WA366326. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2001
    Geliefert am 13. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a lido beach caravan park prestatyn denbigshire t/n WA13503 and WA366326. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 2000
    Geliefert am 09. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents (all as defined therein)
    Kurze Angaben
    The property k/a lido beach caravan park rhuddlan prestatyn clwyd t/n WA366326 WA13503. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1997
    Geliefert am 09. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any other group company (including any other charging company except any money or liabilities due and payable by any other charging company as guarantor for the charging company first referred to) to the chargee (as agent and security trustee (as defined) for the beneficiaries (as defined)) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 1983
    Geliefert am 03. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as bastion camp, bastion road, prestatyn, clwyd. Title no. Wa 13503.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1984Registrierung einer Belastung

    Hat DYSERTH FALLS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2019Beginn der Liquidation
    05. Jan. 2024Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laura Prescott
    4th Floor Churchgate House
    BL1 1HL Bolton
    Praktiker
    4th Floor Churchgate House
    BL1 1HL Bolton
    Brendan P Hogan
    4th Floor Churchgate House Churchgate
    BL1 1HL Bolton
    Praktiker
    4th Floor Churchgate House Churchgate
    BL1 1HL Bolton
    Stephen Berry
    20 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Praktiker
    20 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Rikki Burton
    4th Floor Churchgate House
    BL1 1HL Bolton
    Praktiker
    4th Floor Churchgate House
    BL1 1HL Bolton
    Ian Mcculloch
    Mount Suite, Rational House 32 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    Praktiker
    Mount Suite, Rational House 32 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0